Actos BORME de Telvent Environment Sa
28 de Octubre de 2014Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 5140 , F 112, S 8, H SE 6680, I/A 89 (21.10.14).
17 de Septiembre de 2014Otros conceptos: Conforme al Articulo 231 del RRM se extiende la correspondiente nota de inexistencia de obstáculos registrales enla sociedad TELVENT ENVIRONMENT SA que será absorbida por "Telvent Energia, SA". Datos registrales. T 5140 , F 112, S 8, HSE 6680, I/A 88 2 ( 9.09.14).
25 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: RAMOS ROBLEDO FRANCISCO JAVIER;CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA. Datos registrales.T 5140 , F 111, S 8, H SE 6680, I/A 88 (10.03.14).
21 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GIRON GARCIA JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 5140 , F 110, S 8, H SE 6680, I/A 87 (10.03.14).
27 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS CARRANZA CRISTOBAL. Nombramientos. Consejero: RIOS ODERO JESUS MANUEL.Datos registrales. T 5140 , F 110, S 8, H SE 6680, I/A 86 (19.02.14).
02 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO.Nombramientos. Consejero: HELBERT CYRILLE. Presidente: HELBERT CYRILLE. Datos registrales. T 5140 , F 109, S 8, H SE6680, I/A 85 (23.12.13).
25 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: EGEA SANCHEZ JOSE-MARIA. Datos registrales. T 5140 , F 109, S 8, H SE 6680, I/A 84 (18.09.13).
20 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DOMENECH MONTES HELENA. Datos registrales. T 5140 , F 108, S 8, H SE 6680, I/A 83 ( 6.08.13).
04 de Junio de 2013Declaración de unipersonalidad. Socio único: TELVENT ENERGIA SA. Datos registrales. T 5140 , F 108, S 8, H SE 6680, I/A 82(24.05.13).
04 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: LORIA ROMERO EDUARDO. Datos registrales. T 5140 , F 108, S 8, H SE 6680, I/A 81 (26.03.13).
28 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: OLANO RUIPEREZ LETICIA. Datos registrales. T 5140 , F 108, S 8, H SE 6680, I/A 80 (19.12.12).
11 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CANSECO MARTA. Datos registrales. T 5140 , F 107, S 8, H SE 6680, I/A 79 (30.11.12).
13 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: ANGUEIRA GANDARA MANUEL JULIO;JOAQUIN CORONADO GALDOS;GAROZ NEIRA JAVIER.Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ FALCON AMANDO;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUSANGEL;DE LAS CUEVAS TERAN FERNANDO. Apo.Man.Soli: VILLALBA QUESADA FERNANDO;RAMOS CARRANZACRISTOBAL;VALERO RODRIGUEZ ADRIAN;GAROZ NEIRA JAVIER;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;GONZALEZDOMINGUEZ IGNACIO;LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZAMANUEL;RAMOS CARRANZA CRISTOBAL;ZUBIRA FUREST BARBARA SOFIA. Datos registrales. T 5140 , F 106, S 8, H SE 6680,I/A 78 (29.10.12).
08 de Octubre de 2012Revocaciones. Apoderado: ESCUDERO GOMEZ LUIS. Datos registrales. T 5140 , F 106, S 8, H SE 6680, I/A 77 (27.09.12).
02 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: GAROZ NEIRA JAVIER. Consejero: GAROZ NEIRA JAVIER. Nombramientos. Consejero:GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO. Reelecciones. Consejero: RAMOSCARRANZA CRISTOBAL. SecreNoConsj: GARCIA PAEZ LIDIA. Consejero: VILLALBA QUESADA FERNANDO. Datos registrales. T5140 , F 106, S 8, H SE 6680, I/A 76 (23.07.12).
02 de Julio de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLALBA QUESADA FERNANDO;RAMOS CARRANZA CRISTOBAL;MARTINEZ TAUSPABLO;VALERO RODRIGUEZ ADRIAN;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;GARCIA JIMENEZ MARTA;GONZALEZ DOMINGUEZIGNACIO;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T 5140 , F 104, S 8, H SE 6680, I/A75 (19.06.12).
24 de Febrero de 2012Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5140 , F 103, S 8, H SE 6680, I/A 74 ( 8.02.12).
30 de Agosto de 2011Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -CAMPUS PALMAS ALTAS (SEVILLA). Datos registrales. T 5140 , F 103, S 8, H SE 6680, I/A 73 (12.08.11).
04 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: BAGO SOTILLO RAFAEL ANGEL. Apo.Sol.: VILLALBA QUESADA FERNANDO;AGUERA INFANTERAUL;VALERO RODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Man.Soli: GAROZ NEIRA JAVIER;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;LEBREROBURGOS FRANCISCO-JAVIER;SANCHEZ ORTEGA MANUEL;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZAMANUEL;DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 5140 , F 102, S 8, H SE 6680, I/A 72 (12.04.11).
23 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: RAMOS CARRANZA CRISTOBAL;RAMOS CARRANZA CRISTOBAL. Datos registrales. T 5140 , F102, S 8, H SE 6680, I/A 71 ( 7.12.10).
08 de Octubre de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLALBA QUESADA FERNANDO;RAMOS CARRANZA CRISTOBAL;VALERO RODRIGUEZADRIAN;GAROZ NEIRA JAVIER;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO;LEBRERO BURGOSFRANCISCO JAVIER;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZA MANUEL;RAMOS CARRANZA CRISTOBAL;ZUBIRAFUREST BARBARA SOFIA. Datos registrales. T 5140 , F 100, S 8, H SE 6680, I/A 70 (23.09.10).
14 de Julio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MARBAN BERRUEZO CARLOS. Datos registrales. T 5140 , F 100, S 8, H SE 6680, I/A 69 ( 1.07.10).
08 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS CARRANZA CRISTOBAL. Datos registrales. T 5140 , F 99, S 8, H SE 6680, I/A 68 (24.05.10).
19 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLALBA QUESADA FERNANDO;AGUERA INFANTE RAUL;VALERO RODRIGUEZADRIAN;GAROZ NEIRA JAVIER;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER;SANCHEZORTEGA MANUEL;ANGUEIRA GANDARA MANUEL;FERNANDEZ MAZA MANUEL;DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Datosregistrales. T 5140 , F 98, S 8, H SE 6680, I/A 66 (30.12.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MERA FERNANDO. Datos registrales. T 5140 , F 98, S 8, H SE 6680, I/A 67 (30.12.09).
17 de Noviembre de 2009Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. Construir, reconstruir, rehabilitartoda clase de obras públicas o privadas; ejecutar y montar obras por contrato o por administración, por cuenta propia o ajena;promocionar, estudiar, confeccionar y realizar proyectos de obras; construir y preparar partes de edificios y obras de ingeniería civil.Datos registrales. T 3967 , F 109, S 8, H SE 6680, I/A 65 (29.10.09).
15 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: VILLALBA QUESADA FERNANDO;AGUERA INFANTE RAUL;VALERO RODRIGUEZ ADRIAN.Apo.Man.Soli: GAROZ NEIRA JAVIER;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;LEBRERO BURGOS FRANCISCO-JAVIER;SANCHEZORTEGA MANUEL;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZA MANUEL;DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO.Datos registrales. T 3967 , F 107, S 8, H SE 6680, I/A 63 ( 2.09.09).
Revocaciones. Apoderado: EGEA SANCHEZ JOSE-MARIA. Apo.Sol.: JORDANA AGUSTIN CARLOS;GOMEZ MARTINEZ JORGE.Datos registrales. T 3967 , F 109, S 8, H SE 6680, I/A 64 ( 2.09.09).
10 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ FALCON AMANDO;GARCIA-QUILEZGOMEZ JESUS ANGEL;DE LAS CUEVAS TERAN FERNANDO. Otros conceptos: Los apoderados ejercitarán sus facultades doscualesquiera de ellos, de forma MANCOMUNADA.- Datos registrales. T 3967 , F 107, S 8, H SE 6680, I/A 61 (26.06.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: GIMENEZ ARGUELLES JOAQUIN. Datos registrales. T 3967 , F 107, S 8, H SE 6680, I/A 62 (29.06.09).
29 de Mayo de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: EGEA SANCHEZ JOSE-MARIA. Datos registrales. T 3967 , F 106, S 8, H SE 6680, I/A 59 (15.05.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ JARES CRISTINA. Datos registrales. T 3967 , F 106, S 8, H SE 6680, I/A 60 (15.05.09).
23 de Febrero de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ JIMENEZ PATRICIA. Datos registrales. T 3967 , F 105, S 8, H SE 6680, I/A 58 ( 6.02.09).