Actos BORME de Tendit Solutions Sa
16 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;GUERRA CORTADA ANTONIO MARIA.Nombramientos. Apo.Manc.: RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;GUERRA CORTADA ANTONIOMARIA;GUERRA CORTADA JORGE. Datos registrales. T 30510 , F 24, S 8, H M 549061, I/A 8 ( 9.01.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: PUZO FONCILLAS CRISTINA;GUERRA CORTADA ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 30510 , F25, S 8, H M 549061, I/A 9 ( 9.01.23).
28 de Noviembre de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 30510 , F 24, S 8, H M 549061, I/A 7 (21.11.22).
25 de Octubre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT SL. Ceses/Dimisiones.Adm. Unico: ACZEDA SL. Representan: GUERRA MERCADAL ANTONIO MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: GLOBALBUSINESS DEVELOPMENT SL. Representan: GUERRA MERCADAL ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 30510 , F 23, S 8, H M549061, I/A 6 (18.10.21).
01 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;GALLARDO HERREROS FRANCISCO.Nombramientos. Apoderado: RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;GUERRA CORTADA ANTONIO MARIA.Datos registrales. T 30510 , F 23, S 8, H M 549061, I/A 5 (24.09.18).
30 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ACZEDA SL. Nombramientos. Adm. Unico: ACZEDA SL. Datos registrales. T 30510 , F 22, S 8,H M 549061, I/A 4 (22.09.16).
23 de Octubre de 2013Revocaciones. Apoderado: RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;RODRIGUEZ PASCUAL ANTONIO.Nombramientos. Apo.Manc.: RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;GALLARDO HERREROS FRANCISCO.Datos registrales. T 30510 , F 22, S 8, H M 549061, I/A 3 (14.10.13).
10 de Diciembre de 2012Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 114 (MADRID). Datos registrales. T 30510 , F 22, S 8, H M 549061, I/A 2 (27.11.12).
22 de Noviembre de 2012Cambio de objeto social. LA COMPRA,VENTA,IMPORTACION,EXPORTACION Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DEEQUIPOS Y APARATOS QUE INCORPORAN UN COMPONENTE TECNOLOGICO,TODOS ELLOS NUEVOS DE SEGUNDAMANO,A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO,EQUIPOS Y... Datos registrales. T 42243 , F 34, S 8, H B 353835, I/A 14 (8.11.12).
15 de Octubre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: RENTIOR SOLUTIONS SA. Datos registrales. T 42243 , F 31, S 8, H B 353835, I/A13 ( 1.10.12).
12 de Septiembre de 2012Revocaciones. APODERADO: OTAL CASTAN ALFREDO;PUZO FONCILLAS CRISTINA. Nombramientos. APODERADO:RIVERA LOPEZ SANDRA;PUZO FONCILLAS CRISTINA;RODRIGUEZ PASCUAL ANTONIO. Datos registrales. T 42243 , F 31, S 8,H B 353835, I/A 12 ( 3.09.12).
28 de Agosto de 2012Nombramientos. APODERADO: PUZO FONCILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 42243 , F 30, S 8, H B 353835, I/A 11(13.08.12).
09 de Marzo de 2011Cambio de domicilio social. CL CORCEGA Num.282 P.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 42243 , F 30, S 8, H B 353835, I/A10 (25.02.11).
03 de Enero de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 75.000,00 Euros. Datos registrales. T 42243 , F 30, S 8, H B 353835, I/A 9(21.12.10).
29 de Diciembre de 2010Fe de erratas: En el BORME no.145/2007 y con referencia 397306 SE RECTIFICA EN EL CAPITALSOCIAL, LA CIFRA DELCAPITAL DESEMBOLSADO: DONDE SE LEE "100.000,00 EUROS", DEBE LEERSE:"25000 EUROS". Datos registrales. T 39757 ,F 158, S 8, H B 353835, I/A 1 ( 9.07.07).
27 de Diciembre de 2010Revocaciones. ADM.CONJUNTO: COMELLAS FONT RAMON;PUZO FONCILLAS CRISTINA. Nombramientos. ADM.UNICO:ACZEDA SL. REPR.143 RRM: GUERRA MERCADAL ANTONIO MARIA. Modificaciones estatutarias. ARTS. 19,20,30: CAMBIODE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO: ACZEDA SL.Datos registrales. T 39757 , F 167, S 8, H B 353835, I/A 8 (14.12.10).
10 de Marzo de 2010Revocaciones. APODERADO: VIDAL ALEGRET JAUME;OTAL CASTAN ALFREDO;PUZO FONCILLAS CRISTINA.Nombramientos. APODERADO: OTAL CASTAN ALFREDO;PUZO FONCILLAS CRISTINA;GUERRA MERCADAL ANTONIO MARIA.Datos registrales. T 39757 , F 165, S 8, H B 353835, I/A 7 (25.02.10).
14 de Mayo de 2009Revocaciones. APODERADO: PUZO FONCILLAS CRISTINA;MEDINA ORTIZ JOSE ANTONIO;VIDAL ALEGRET JAUME.Nombramientos. APODERADO: VIDAL ALEGRET JAUME;OTAL CASTAN ALFREDO;PUZO FONCILLAS CRISTINA. Datosregistrales. T 39757 , F 164, S 8, H B 353835, I/A 6 (29.04.09).
24 de Abril de 2009Revocaciones. ADM.CONJUNTO: MEDINA ORTIZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: PUZO FONCILLASCRISTINA. Datos registrales. T 39757 , F 163, S 8, H B 353835, I/A 5 (15.04.09).