Actos BORME de Teralvi Sl
02 de Diciembre de 2019Revocaciones. CONSEJERO: VILARET IBORRA MARGARITA. PRESIDENTE: VILARET IBORRA MARGARITA. CONSEJERO:VILARET IBORRA LUIS. SECRETARIO: VILARET IBORRA LUIS. CONSEJERO: VILARET IBORRA JOSE ANTONIO. CONS.DELEG.: VILARET IBORRA LUIS. Nombramientos. ADM.UNICO: VILARET IBORRA LUIS. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 18,19 Y 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 34497 , F151, S 8, H B 629, I/A 18 (22.11.19).
16 de Febrero de 2015Fe de erratas: En el BORME no.173/2014 y con referencia 362569 SE OMITIO EL NOMBRAMIENTO DE DON LUIS VILARETIBORRA COMO CONSEJERO DELEGADO. Datos registrales. T 34497 , F 150, S 8, H B 629, I/A 16 ( 3.09.14).
12 de Febrero de 2015Otros conceptos: RECTIFICADA LA INSCRIPCION 16 EN LA CUAL SE OMITIO EL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERODELEGADO DON LUIS VILARET IBORRA. Datos registrales. T 34497 , F 151, S 8, H B 629, I/A 17 ( 4.02.15).
11 de Septiembre de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: VILARET SALVAT OSCAR MARCOS. Datos registrales. T 34497 , F 150, S 8, H B 629, I/A 14( 3.09.14).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 71.597,13 Euros. Resultante Suscrito: 938.221,10 Euros. Datos registrales. T 34497 , F 150, S 8, HB 629, I/A 15 ( 3.09.14).
Revocaciones. CONSEJERO: VILARET BOSCH FELIX. PRESIDENTE: VILARET BOSCH FELIX. CONSEJERO: VILARET IBORRALUIS. SECRETARIO: VILARET IBORRA LUIS. CONS. DELEG.: VILARET IBORRA LUIS. CONSEJERO: VILARET IBORRAMARGARITA. VICEPRESIDEN: VILARET IBORRA MARGARITA. Nombramientos. CONSEJERO: VILARET IBORRA MARGARITA.PRESIDENTE: VILARET IBORRA MARGARITA. CONSEJERO: VILARET IBORRA LUIS. SECRETARIO: VILARET IBORRA LUIS.CONSEJERO: VILARET IBORRA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 34497 , F 150, S 8, H B 629, I/A 16 ( 3.09.14).
29 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 44.161,48 Euros. Resultante Suscrito: 866.623,97 Euros. Datos registrales. T 34497 , F 149, S 8, HB 629, I/A 13 (22.08.14).
13 de Mayo de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 254.517,49 Euros. Resultante Suscrito: 822.462,49 Euros. Datos registrales. T 34497 , F 149, S 8,H B 629, I/A 12 ( 5.05.14).
24 de Mayo de 2011Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AIMANZOE SL. Datos registrales. T 34497 , F 147, S 3, H B 629, I/A 11 (12.05.11).