Actos BORME de Terminal Intermodal Monzon Sociedad Limitada
29 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SEMITIEL NOGUERO PEDRO. Datos registrales. T 4560 , F 122, S 8, H Z 49362, I/A 25 (22.11.23).
13 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4560 , F 121, S 8, H Z 49362, I/A 24 ( 3.11.23).
10 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4560 , F 121, S 8, H Z 49362, I/A 23 ( 2.11.23).
26 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: RAMI PUEYO ANSELMO;BARRABES CASTANERA FRANCISCO;RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 4560 , F 117, S 8, H Z 49362, I/A 18 (18.07.22).
Nombramientos. Apoderado: BOJ SOLANO REBECA. Datos registrales. T 4560 , F 118, S 8, H Z 49362, I/A 19 (18.07.22).
Nombramientos. Apoderado: SEMITIEL NOGUERO PEDRO. Datos registrales. T 4560 , F 118, S 8, H Z 49362, I/A 20 (18.07.22).
Nombramientos. Apoderado: BARRABES CASTANERA FRANCISCO. Datos registrales. T 4560 , F 119, S 8, H Z 49362, I/A 21(18.07.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4560 , F 120, S 8, H Z 49362, I/A 22(18.07.22).
03 de Diciembre de 2021Modificaciones estatutarias. Artículo Decimocuarto. Reglas. Se le aplicarán las normas de la legislación sobre Sociedades deResponsabilidad Limitada, con las siguientes especialidades: 1. La convocatoria se realizará carta certificada con acuse de recibo,cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o notificación notarial Artículo Decimosexto. Consejo de Administración. Se le aplicarán lassiguientes reglas: 1. Deberá elegir entre sus miembros un Presidente, encargado de convocar las sesiones, dirigirlas y llevar a cabotodo lo que a dicho cargo atribuye la legislación mercantil. También deberá elegir un Secretario,. Datos registrales. T 3744 , F 124, S8, H Z 49362, I/A 17 (26.11.21).
19 de Noviembre de 2021Ampliación de capital. Capital: 441.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.941.200,00 Euros. Datos registrales. T 3744 , F 123, S 8,H Z 49362, I/A 14 (12.11.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOCIEDAD ANONIMA MINERA CATALANO ARAGONESA. Nombramientos. Consejero: LUENGOEGIDO JAVIER;GOMEZ BARBERO OSCAR;CLIMENT DEWIT GENOVEVA;GARCIA MILA LLOVERAS SANTIAGO. Presidente:LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 3744 , F 123, S 8, H Z 49362, I/A 15(12.11.21).
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3744 , F 124, S 8, H Z49362, I/A 16 (12.11.21).
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 3744 ,F 123, S 8, H Z 49362, I/A 13 (13.10.21).
27 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 3744 , F 122, S 8, H Z 49362, I/A 12 (20.07.21).
15 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3744 , F 122, S 8, H Z49362, I/A 11 ( 7.01.20).
04 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3744 , F 122, S 8, H Z 49362, I/A 10 (27.12.18).
16 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3744 , F 121, S 8, H Z 49362, I/A 9 ( 8.11.18).
02 de Julio de 2015Nombramientos. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 3744 , F 120, S 8, H Z 49362, I/A 8(24.06.15).
05 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: BARRABES CASTANERA FRANCISCO. Datos registrales. T 3744 , F 119, S 8, H Z 49362, I/A 7(27.04.15).
11 de Agosto de 2011Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 3744 , F 119, S 8, HZ 49362, I/A 6 ( 2.08.11).
16 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 3744 , F 118, S 8, H Z 49362, I/A 5 ( 7.02.11).
25 de Enero de 2011Ampliación de capital. Capital: 2.496.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 3744 , F 118, S8, H Z 49362, I/A 4 (13.01.11).
12 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: RAMI PUEYO ANSELMO. Datos registrales. T 3744 , F 118, S 8, H Z 49362, I/A 3 (30.03.10).
18 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3744 , F 117, S 8, H Z 49362, I/A 2 ( 9.02.10).
10 de Diciembre de 2009Constitución. Comienzo de operaciones: 27.11.09. Objeto social: La construcción y explotación de un apartadero ferroviario demercancías en terrenos situados en el Polígono Industrial denominado La Armentera, en término municipal de Monzón (Huesca), asícomo el transporte ferroviario, eltransporte por vía terrestre y demás actividades auxiliares relacionadas co. Domicilio: PASEOINDEPENDENCIA 21 3& (ZARAGOZA). Capital: 4.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL.Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: ORERA PEÑA JOSE RUBEN. Vicepresid.: ORERA PEÑA JOSE RUBEN.Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: ORERA PEÑA JOSERUBEN;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3744 , F 116, S 8, H Z 49362, I/A 1 (30.11.09).