Actos BORME de Terminal Polivalente Del Puerto De Cadiz Sa
11 de Diciembre de 2023Otros conceptos: Cambio de representante persona física del consejero y presidente VAPORES SUARDIAZ SU-ATLANTICOSLCesa: Doña Susana Uyá PedrosaNombran: Don Javier Guerra Caballero. Datos registrales. T 1955 , F 54, S 8, H CA 14742, I/A35 (30.11.23).
Otros conceptos: Cambio de representante físico de la mercantil LOGISTICA SUARDIAZ SLCesan: Don Alfredo MenéndezGarcía.Nombran: Doña Paula Luiken Núñez. Datos registrales. T 2512 , F 68, S 8, H CA 14742, I/A 36 (30.11.23).
28 de Abril de 2023Modificaciones estatutarias. "Artículo 25. Resumen. Datos registrales. T 1955 , F 54, S 8, H CA 14742, I/A 33 (20.04.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL;JUAN MANUEL BERNAL GUTIERREZ;RAUL BERNALSOTO;LOGISTICA SUARDIAZ SL;VAPOREZ SUARDIAZ MEDITERRANEO SA. Presidente: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICOSL. Vicepresid.: JUAN MANUEL BERNAL GUTIERREZ. Secretario: RAUL BERNAL SOTO. Nombramientos. Consejero: VAPORESSUARDIAZ SUR ATLANTICO SL;LOGISTICA SUARDIAZ SL;GERMAN BERNAL SOTO. Presidente: VAPORES SUARDIAZ SURATLANTICO SL. Secretario: GERMAN BERNAL SOTO. Datos registrales. T 1955 , F 54, S 8, H CA 14742, I/A 34 (20.04.23).
21 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: BERNAL GUTIERREZ JUAN;NIETO LEON JOAQUIN;RIVA FRANCOS JUAN;BERNAL SOTORAUL;MENENDEZ GARCIA ALFREDO. Vicepresid.: BERNAL GUTIERREZ JUAN. Secretario: BERNAL SOTO RAUL. Presidente:NIETO LEON JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL;BERNAL GUTIERREZ JUANMANUEL;BERNAL SOTO RAUL;LOGISTICA SUARDIAZ SL;VAPOREZ SUARDIAZ MEDITERRANEO SA. Presidente: VAPORESSUARDIAZ SUR ATLANTICO SL. Vicepresid.: BERNAL GUTIERREZ JUAN MANUEL. Secretario: BERNAL SOTO RAUL. Datosregistrales. T 1955 , F 52, S 8, H CA 14742, I/A 32 (14.12.17).
29 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ PEDEMONTE FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: PEREZ LOPEZFRANCISCA. Datos registrales. T 1955 , F 52, S 8, H CA 14742, I/A 31 (18.12.15).
01 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: GOMEZ OSORIO RAUL. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PEDEMONTE FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 1955 , F 51, S 8, H CA 14742, I/A 30 (20.03.13).
14 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: CAÑAS DIEZ BENITO LUIS. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ OSORIO RAUL. Datosregistrales. T 1955 , F 49, S 8, H CA 14742, I/A 29 ( 3.10.11).
26 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMA MUÑOZ RAMON;RIVA MEANA AMADEO;CARRIEDO FERNANDEZ AGUSTIN.Reelecciones. Consejero: BERNAL GUTIERREZ JUAN;NIETO LEON JOAQUIN;RIVA FRANCOS JUAN;BERNAL SOTORAUL;MENENDEZ GARCIA ALFREDO. Vicepresid.: BERNAL GUTIERREZ JUAN. Secretario: BERNAL SOTO RAUL. Presidente:NIETO LEON JOAQUIN. Datos registrales. T 1955 , F 49, S 8, H CA 14742, I/A 28 (14.09.11).
02 de Septiembre de 2011Nombramientos. Auditor: MANCERA CLAVERIA JUAN. Datos registrales. T 1955 , F 49, S 8, H CA 14742, I/A 27 (19.08.11).
05 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: MANCERA CLAVERIA JUAN. Datos registrales. T 1563 , F 15, S 8, H CA 14742, I/A 25 (26.10.09).
Nombramientos. Apoderado: CAÑAS DIEZ BENITO LUIS. Datos registrales. T 1563 , F 15, S 8, H CA 14742, I/A 26 (26.10.09).
08 de Mayo de 2009Reelecciones. Auditor: MANCERA CLAVERIA JUAN. Datos registrales. T 1563 , F 14, S 8, H CA 14742, I/A 22 (27.04.09).
Reelecciones. Auditor: MANCERA CLAVERIA JUAN. Datos registrales. T 1563 , F 14, S 8, H CA 14742, I/A 23 (27.04.09).
Ceses/Dimisiones. Presidente: RIVA MEANA AMADEO. Nombramientos. Presidente: NIETO LEON JOAQUIN. Datos registrales.T 1563 , F 15, S 8, H CA 14742, I/A 24 (28.04.09).