Buscador CIF Logo

Actos BORME Terminal Polivalente Sureste Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Terminal Polivalente Sureste Sl

Actos BORME Terminal Polivalente Sureste Sl - B54012489

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Terminal Polivalente Sureste Sl con CIF B54012489

馃敊 Perfil de Terminal Polivalente Sureste Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Terminal Polivalente Sureste Sl

31 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GAGO DE PEDRO JOAQUIN;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;NU脩EZ GARCIA GABRIEL.SecreNoConsj: OLIVERA MASSO PABLO. Liquidador: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN.Nombramientos. Liquidador: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 4210 , F 26,S 8, H A 94366, I/A 47 (23.12.21).

21 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GAGO DE PEDRO JOAQUIN;YBA脩EZRUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4210 , F 24, S 8, H A 94366, I/A 46(13.07.21).

30 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Datos registrales. T 4210 , F23, S 8, H A 94366, I/A 45 (19.11.20).

25 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Revocaciones. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Apo.Manc.:NU脩EZ GARCIA GABRIEL;YBA脩EZ RUBIO PABLO;LAZARO BA脩OS CARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAUREENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 4210 , F 23, S 8, H A94366, I/A 44 (17.02.20).

11 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS;CABELLOMU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 4210 , F 23, S 8, H A94366, I/A 43 (29.11.19).

26 de Julio de 2019
Nombramientos. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 4210 , F 23, S 8, H A 94366, I/A 42 (18.07.19).

18 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNARMARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS.Datos registrales. T 4210 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 41 (11.07.19).

26 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 4178 , F 8, S 8, H A 94366, I/A 40 (15.04.19).

24 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;CABELLOMU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;AZNAR MARTINEZ JESUS;OVIEDO RAPOSOFRANCISCO JOSE;CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 4178 , F 8, S 8, H A 94366, I/A 39 (12.04.19).

22 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GARCIA LILIA IVONNE;ALVAREZ EMBARBA RAQUEL. Datos registrales. T 4178 , F 7,S 8, H A 94366, I/A 38 (10.04.19).

16 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 37 (8.04.19).

15 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 36 ( 4.04.19).

11 de Abril de 2019
Nombramientos. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 35 (3.04.19).

10 de Abril de 2019
Fe de erratas: Error en la inscripci贸n 31陋 en cuanto al cargo para el que ha sido nombrado don Pablo Olivera Masso, debiendo leerse"Secretario no consejero". Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 31 (19.12.18).

08 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;OVIEDORAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4178 , F 5, S 8, H A94366, I/A 33 (27.12.18).

Nombramientos. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 34 (28.12.18).

31 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANTOS RODRIGUEZCRISTINA. Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 32 (20.12.18).

28 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO. Nombramientos. Liquidador: OLIVERA MASSO PABLO.Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 31 (19.12.18).

17 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DELCARMEN. Nombramientos. Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO.Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 30 ( 8.05.18).

30 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 29 (21.12.15).

01 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Manc.: ORTS FUSTER LUISMANUEL. Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 28 (23.11.15).

18 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILISEMILIO. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTSFUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 27 (10.06.15).

12 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 3764 , F 224, S 8, H A 94366, I/A 26 ( 4.05.15).

11 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3764 , F 223,S 8, H A 94366, I/A 25 ( 3.02.15).

10 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3764 , F 221, S 8, H A 94366, I/A 24 ( 2.02.15).

06 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3764 , F 221, S 8, H A 94366, I/A 23 (29.01.15).

22 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Sol.: BENAVENT QUILISEMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3764 , F 221, S 8, H A 94366, I/A 22 (13.05.14).

15 de Abril de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 29潞.- El Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 3676 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 24 (7.04.14).

11 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 3676 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 23 ( 2.12.13).

10 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T3676 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 21 (28.11.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3676 , F 21, S8, H A 94366, I/A 22 ( 2.12.13).

05 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3676 , F 19, S 8, H A 94366, I/A 19 (27.11.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILIS EMILIO. Datos registrales. T 3676 , F 21,S 8, H A 94366, I/A 20 (28.11.13).

04 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3676 , F 19, S 8, H A94366, I/A 18 (24.10.13).

21 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE.Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Nombramientos. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3676 , F 19, S 8, H A 94366, I/A 17 (10.05.13).

04 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A94366, I/A 16 (25.03.13).

13 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-PITA RIPOLLES ISABEL. Vicesecret.: GACITUAGA FERNANDEZ IGNACIO.Nombramientos. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO.

10 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A14 (29.07.10).

16 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: MILLER ALICANTE SL. Consejero: MILLER ALICANTE SL. Cons.Del.Man: MILLER ALICANTE SL.Consejero: BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Nombramientos. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE.Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A 13 ( 6.07.10).

27 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A 12 (17.11.09).

05 de Noviembre de 2009
Cambio de domicilio social. MUELL PONIENTE, MUELLE 23 - JUNTO ESTACION PASAJER (ALICANTE). Datos registrales. T2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A 11 (26.10.09).

06 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL. Nombramientos. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 10 (21.04.09).

23 de Abril de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 44.789,40 Euros. Resultante Suscrito: 47.795,40 Euros. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A94366, I/A 9 ( 8.04.09).

21 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLUDA FOS VICENTE. Presidente: BOLUDA FOS VICENTE. Nombramientos. Consejero:BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Presidente: MILLER ALICANTE SL. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 8( 7.04.09).

20 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-PITARIPOLLES ISABEL. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 7 ( 7.04.09).

17 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Nombramientos. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL. Datosregistrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 5 ( 3.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n