Actos BORME de Terminal Polivalente Sureste Sl
31 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GAGO DE PEDRO JOAQUIN;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;NU脩EZ GARCIA GABRIEL.SecreNoConsj: OLIVERA MASSO PABLO. Liquidador: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN.Nombramientos. Liquidador: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 4210 , F 26,S 8, H A 94366, I/A 47 (23.12.21).
21 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GAGO DE PEDRO JOAQUIN;YBA脩EZRUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4210 , F 24, S 8, H A 94366, I/A 46(13.07.21).
30 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Datos registrales. T 4210 , F23, S 8, H A 94366, I/A 45 (19.11.20).
25 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Revocaciones. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Apo.Manc.:NU脩EZ GARCIA GABRIEL;YBA脩EZ RUBIO PABLO;LAZARO BA脩OS CARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAUREENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 4210 , F 23, S 8, H A94366, I/A 44 (17.02.20).
11 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS;CABELLOMU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 4210 , F 23, S 8, H A94366, I/A 43 (29.11.19).
26 de Julio de 2019Nombramientos. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 4210 , F 23, S 8, H A 94366, I/A 42 (18.07.19).
18 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNARMARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS.Datos registrales. T 4210 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 41 (11.07.19).
26 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 4178 , F 8, S 8, H A 94366, I/A 40 (15.04.19).
24 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;CABELLOMU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;AZNAR MARTINEZ JESUS;OVIEDO RAPOSOFRANCISCO JOSE;CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 4178 , F 8, S 8, H A 94366, I/A 39 (12.04.19).
22 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GARCIA LILIA IVONNE;ALVAREZ EMBARBA RAQUEL. Datos registrales. T 4178 , F 7,S 8, H A 94366, I/A 38 (10.04.19).
16 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 37 (8.04.19).
15 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 36 ( 4.04.19).
11 de Abril de 2019Nombramientos. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 35 (3.04.19).
10 de Abril de 2019Fe de erratas: Error en la inscripci贸n 31陋 en cuanto al cargo para el que ha sido nombrado don Pablo Olivera Masso, debiendo leerse"Secretario no consejero". Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 31 (19.12.18).
08 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;OVIEDORAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4178 , F 5, S 8, H A94366, I/A 33 (27.12.18).
Nombramientos. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Datos registrales. T 4178 , F 7, S 8, H A 94366, I/A 34 (28.12.18).
31 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANTOS RODRIGUEZCRISTINA. Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 32 (20.12.18).
28 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO. Nombramientos. Liquidador: OLIVERA MASSO PABLO.Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 31 (19.12.18).
17 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DELCARMEN. Nombramientos. Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO.Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 30 ( 8.05.18).
30 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 29 (21.12.15).
01 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Manc.: ORTS FUSTER LUISMANUEL. Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 28 (23.11.15).
18 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILISEMILIO. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTSFUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3764 , F 225, S 8, H A 94366, I/A 27 (10.06.15).
12 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 3764 , F 224, S 8, H A 94366, I/A 26 ( 4.05.15).
11 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3764 , F 223,S 8, H A 94366, I/A 25 ( 3.02.15).
10 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3764 , F 221, S 8, H A 94366, I/A 24 ( 2.02.15).
06 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3764 , F 221, S 8, H A 94366, I/A 23 (29.01.15).
22 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Sol.: BENAVENT QUILISEMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3764 , F 221, S 8, H A 94366, I/A 22 (13.05.14).
15 de Abril de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo 29潞.- El Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 3676 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 24 (7.04.14).
11 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 3676 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 23 ( 2.12.13).
10 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T3676 , F 21, S 8, H A 94366, I/A 21 (28.11.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3676 , F 21, S8, H A 94366, I/A 22 ( 2.12.13).
05 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3676 , F 19, S 8, H A 94366, I/A 19 (27.11.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILIS EMILIO. Datos registrales. T 3676 , F 21,S 8, H A 94366, I/A 20 (28.11.13).
04 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3676 , F 19, S 8, H A94366, I/A 18 (24.10.13).
21 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE.Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Nombramientos. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3676 , F 19, S 8, H A 94366, I/A 17 (10.05.13).
04 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A94366, I/A 16 (25.03.13).
13 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-PITA RIPOLLES ISABEL. Vicesecret.: GACITUAGA FERNANDEZ IGNACIO.Nombramientos. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO.
10 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A14 (29.07.10).
16 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: MILLER ALICANTE SL. Consejero: MILLER ALICANTE SL. Cons.Del.Man: MILLER ALICANTE SL.Consejero: BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Nombramientos. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE.Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A 13 ( 6.07.10).
27 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A 12 (17.11.09).
05 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. MUELL PONIENTE, MUELLE 23 - JUNTO ESTACION PASAJER (ALICANTE). Datos registrales. T2970 , F 80, S 8, H A 94366, I/A 11 (26.10.09).
06 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL. Nombramientos. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 10 (21.04.09).
23 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 44.789,40 Euros. Resultante Suscrito: 47.795,40 Euros. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A94366, I/A 9 ( 8.04.09).
21 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLUDA FOS VICENTE. Presidente: BOLUDA FOS VICENTE. Nombramientos. Consejero:BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Presidente: MILLER ALICANTE SL. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 8( 7.04.09).
20 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-PITARIPOLLES ISABEL. Datos registrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 7 ( 7.04.09).
17 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Nombramientos. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL. Datosregistrales. T 2970 , F 79, S 8, H A 94366, I/A 5 ( 3.04.09).