Actos BORME de Terminales Maritimas Del Sureste Sa
19 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVERA MASSO PABLO;SERRANO BALSEYRO ALVARO;SANTOS RODRIGUEZCRISTINA;CASTRESANA PEDRAZA PABLO;GONZALEZ LINARES FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 4517 , F 142, S 8, H A79833, I/A 84 (12.12.23).
15 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4517 , F 142, S 8, H A 79833, I/A 83 ( 6.11.23).
11 de Octubre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.859.514,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.960.486,00 Euros. Datos registrales. T 4517, F 142, S 8, H A 79833, I/A 82 ( 2.10.23).
27 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: DE DIEGO DUO ANA ROSA. Datos registrales. T 4517 , F 141, S 8, H A 79833, I/A 81 (18.04.23).
25 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNARMARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS.Datos registrales. T 4517 , F 141, S 8, H A 79833, I/A 80 (17.04.23).
16 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4517 , F 141, S 8, H A 79833, I/A 79 ( 5.01.23).
01 de Diciembre de 2022Fe de erratas: Error en el n煤mero de inscripci贸n que se public贸 como inscripci贸n 48陋, siendo la correcta la inscripci贸n 78陋. Datosregistrales. T 4391 , F 145, S 8, H A 79833, I/A 78 (17.11.22).
25 de Noviembre de 2022Reelecciones. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN.Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Otros conceptos: Modificaci贸n de la totalidad de los estatutos sociales. Ampliacion delobjeto social. La prestaci贸n de cualesquiera servicios portuarios o comerciales vinculados a la explotaci贸n de la terminal y aldesarrollo del negocio concesional, previa la obtenci贸n de las correspondientes autorizaciones administrativas por parte de la AutoridadPortuaria de Alicante. Datos registrales. T 4391 , F 145, S 8, H A 79833, I/A 48 (17.11.22).
13 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVERA MASSO PABLO;SERRANO BALSEYRO ALVARO;SANTOS RODRIGUEZCRISTINA;CASTRESANA PEDRAZA PABLO. Datos registrales. T 4391 , F 145, S 8, H A 79833, I/A 77 ( 6.06.22).
27 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4391 , F 144, S 8, H A 79833, I/A 76 (17.12.21).
16 de Septiembre de 2021Reelecciones. Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 4391 , F 144, S 8, H A 79833, I/A 75 ( 9.09.21).
20 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GAGO DE PEDRO JOAQUIN;YBA脩EZRUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A 79833, I/A 74(12.07.21).
26 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A 79833, I/A 73 (18.01.21).
30 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Datos registrales. T 4209 , F27, S 8, H A 79833, I/A 72 (20.11.20).
13 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER.Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER.Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4209 , F 27,S 8, H A 79833, I/A 71 ( 3.12.19).
12 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A 79833, I/A 70 ( 2.12.19).
10 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Revocaciones. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Apo.Manc.:NU脩EZ GARCIA GABRIEL;YBA脩EZ RUBIO PABLO;LAZARO BA脩OS CARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAUREENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A79833, I/A 69 (28.11.19).
26 de Julio de 2019Nombramientos. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Reelecciones. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL. Datosregistrales. T 4209 , F 26, S 8, H A 79833, I/A 68 (18.07.19).
18 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNARMARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS.Datos registrales. T 4209 , F 24, S 8, H A 79833, I/A 67 (11.07.19).
26 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3963 , F 209, S 8, H A 79833, I/A 66 (16.04.19).
24 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDORAPOSO FRANCISCO JOSE;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNARMARTINEZ JESUS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 65 (12.04.19).
22 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GARCIA LILIA IVONNE;ALVAREZ EMBARBA RAQUEL. Datos registrales. T 3963 , F208, S 8, H A 79833, I/A 64 (10.04.19).
16 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 63 (8.04.19).
12 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 62 ( 5.04.19).
11 de Abril de 2019Nombramientos. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 61 (3.04.19).
18 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3963 , F 207, S 8, H A 79833, I/A 60 (10.01.19).
08 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;OVIEDORAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 3963 , F 205, S 8,H A 79833, I/A 58 (27.12.18).
Nombramientos. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Datos registrales. T 3963 , F 207, S 8, H A 79833, I/A 59(28.12.18).
31 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LLANOS ALPERI JOSE MANUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANTOS RODRIGUEZCRISTINA. Datos registrales. T 3963 , F 205, S 8, H A 79833, I/A 57 (20.12.18).
28 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: OLIVERA MASSOPABLO. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 56 (19.12.18).
11 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DELCARMEN. VsecrNoConsj: FERNANDEZ MARTINEZ MARIA. Nombramientos. Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO.SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO. VsecrNoConsj: LLANOS ALPERI JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3963 ,F 204, S 8, H A 79833, I/A 55 ( 3.07.18).
09 de Julio de 2018Reelecciones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 54 ( 2.07.18).
14 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 53 ( 6.02.18).
18 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 52 (10.01.17).
29 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A79833, I/A 51 (19.07.16).
27 de Julio de 2016Reelecciones. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL. Datos registrales. T 3587 , F 156, S 8, H A 79833, I/A 50 (18.07.16).
10 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datosregistrales. T 3587 , F 155, S 8, H A 79833, I/A 49 ( 2.03.16).
02 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 3587 , F 155, S 8, H A 79833, I/A 48 (23.02.16).
22 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3587 , F 155, S 8, H A 79833, I/A 47 (14.01.16).
30 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 3587 , F 154, S 8, H A 79833, I/A 46 (21.12.15).
01 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Manc.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3587 , F154, S 8, H A 79833, I/A 45 (23.11.15).
22 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 3587 , F 154, S 8, H A 79833, I/A 44 (12.06.15).
17 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTSFUSTER LUIS MANUEL;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILIS EMILIO. Datos registrales. T 3587 , F 154, S 8,H A 79833, I/A 43 ( 9.06.15).
10 de Marzo de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3587 , F 154, S 8, HA 79833, I/A 42 ( 2.03.15).
11 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3587 , F 152,S 8, H A 79833, I/A 41 ( 3.02.15).
10 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 40 ( 2.02.15).
06 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 39 (29.01.15).
27 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 38 (19.01.15).
09 de Junio de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: PAZO ESPINOSA FRANCISCO DE ASIS. Apo.Sol.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Manc.: ORTSFUSTER LUIS MANUEL;BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO;POUSA POUSA ARTURO;OSUNAGOMEZ JUAN LUIS;BEJERANO TOME MANUEL. Apo.Manc.: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO;OVIEDO RAPOSOFRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 37 (30.05.14).
30 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 36 (22.01.14).
11 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 3587 , F 149, S 8, H A 79833, I/A 35 ( 2.12.13).
10 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T3587 , F 149, S 8, H A 79833, I/A 33 (28.11.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3587 , F 149,S 8, H A 79833, I/A 34 ( 2.12.13).
05 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 31 (27.11.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILIS EMILIO. Datos registrales. T 3587 , F149, S 8, H A 79833, I/A 32 (28.11.13).
04 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 30(24.10.13).
02 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZRODRIGO;EZQUERRA PLASENCIA FELIPE;BEJERANO TOME MANUEL;HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Secretario:HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;NU脩EZ GARCIAGABRIEL. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 29 (21.06.13).
25 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: EZQUERRA PLASENCIA FELIPE. Datos registrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 28 (17.06.13).
14 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 27 ( 3.01.13).
02 de Marzo de 2012Reelecciones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Otrosconceptos: Modificaci贸n de los estatutos sociales. Datos registrales. T 3495 , F 91, S 8, H A 79833, I/A 26 (22.02.12).
29 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO. Nombramientos. VsecrNoConsj: FERNANDEZ MARTINEZMARIA. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 25 (17.02.12).
10 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-PITA RIPOLLES ISABEL. Nombramientos. Secretario: HONRADO HONRADO MARIADEL CARMEN. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 24 (29.12.11).
27 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: GACITUAGA FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 23(15.12.11).
31 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: EZQUERRA PLASENCIA FELIPE;BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO;OVIEDO RAPOSOFRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 22 (22.12.10).
30 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS;BEJERANO TOME MANUEL. Datos registrales. T 3253 , F 137, S 8, H A79833, I/A 21 (21.12.10).
10 de Agosto de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: POUSA POUSA ARTURO. Datos registrales. T 3253 , F 137, S 8, H A 79833, I/A 20 (29.07.10).
22 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.820.000,00 Euros. Desembolsado: 2.820.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.820.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 17.820.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. =ARTICULO 帽7潞.- Acciones=.-. Datos registrales. T3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 19 (13.01.10).
27 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Presidente: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA.Consejero: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Cons.Del.Man: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA;BAEZA OCHOA DEOCARIZ RODRIGO. Nombramientos. Consejero: EZQUERRA PLASENCIA FELIPE;BEJERANO TOME MANUEL;HONRADOHONRADO MARIA DEL CARMEN.Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Reelecciones. Consejero: BAEZA OCHOADE OCARIZ RODRIGO. Datos registrales. T 3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 18 (17.11.09).
06 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. MUELL PONIENTE, MUELLE 23 - JUNTO ESTACION PASAJER (ALICANTE). Datos registrales. T3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 17 (28.10.09).
05 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 16 (26.10.09).
01 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL. Nombramientos. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 15 (20.03.09).
31 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLUDA FOS VICENTE. Presidente: BOLUDA FOS VICENTE. Nombramientos. Consejero:BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Presidente: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Datos registrales. T 3253 , F 135, S8, H A 79833, I/A 14 (18.03.09).
27 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Cons.Del.Man: MILLER ALICANTE SL. Consejero: MILLER ALICANTESL. Nombramientos. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL;BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Datos registrales. T3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 12 (13.03.09).
Nombramientos. Cons.Del.Man: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Datos registrales. T 3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 13(16.03.09).
25 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-PITARIPOLLES ISABEL. Datos registrales. T 3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 10 (12.03.09).
24 de Marzo de 2009Reelecciones. Consejero: BOLUDA FOS VICENTE. Presidente: BOLUDA FOS VICENTE. Consejero: BEJERANO TOME MANUEL.Datos registrales. T 3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 9 (11.03.09).