Buscador CIF Logo

Actos BORME Terminales Maritimas Del Sureste Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Terminales Maritimas Del Sureste Sa

Actos BORME Terminales Maritimas Del Sureste Sa - A53817359

Tenemos registrados 76 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Terminales Maritimas Del Sureste Sa con CIF A53817359

馃敊 Perfil de Terminales Maritimas Del Sureste Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Terminales Maritimas Del Sureste Sa

19 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVERA MASSO PABLO;SERRANO BALSEYRO ALVARO;SANTOS RODRIGUEZCRISTINA;CASTRESANA PEDRAZA PABLO;GONZALEZ LINARES FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 4517 , F 142, S 8, H A79833, I/A 84 (12.12.23).

15 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4517 , F 142, S 8, H A 79833, I/A 83 ( 6.11.23).

11 de Octubre de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.859.514,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.960.486,00 Euros. Datos registrales. T 4517, F 142, S 8, H A 79833, I/A 82 ( 2.10.23).

27 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: DE DIEGO DUO ANA ROSA. Datos registrales. T 4517 , F 141, S 8, H A 79833, I/A 81 (18.04.23).

25 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNARMARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS.Datos registrales. T 4517 , F 141, S 8, H A 79833, I/A 80 (17.04.23).

16 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4517 , F 141, S 8, H A 79833, I/A 79 ( 5.01.23).

01 de Diciembre de 2022
Fe de erratas: Error en el n煤mero de inscripci贸n que se public贸 como inscripci贸n 48陋, siendo la correcta la inscripci贸n 78陋. Datosregistrales. T 4391 , F 145, S 8, H A 79833, I/A 78 (17.11.22).

25 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN.Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Otros conceptos: Modificaci贸n de la totalidad de los estatutos sociales. Ampliacion delobjeto social. La prestaci贸n de cualesquiera servicios portuarios o comerciales vinculados a la explotaci贸n de la terminal y aldesarrollo del negocio concesional, previa la obtenci贸n de las correspondientes autorizaciones administrativas por parte de la AutoridadPortuaria de Alicante. Datos registrales. T 4391 , F 145, S 8, H A 79833, I/A 48 (17.11.22).

13 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVERA MASSO PABLO;SERRANO BALSEYRO ALVARO;SANTOS RODRIGUEZCRISTINA;CASTRESANA PEDRAZA PABLO. Datos registrales. T 4391 , F 145, S 8, H A 79833, I/A 77 ( 6.06.22).

27 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4391 , F 144, S 8, H A 79833, I/A 76 (17.12.21).

16 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 4391 , F 144, S 8, H A 79833, I/A 75 ( 9.09.21).

20 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GAGO DE PEDRO JOAQUIN;YBA脩EZRUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A 79833, I/A 74(12.07.21).

26 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A 79833, I/A 73 (18.01.21).

30 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Presidente: GAGO DE PEDRO JOAQUIN. Datos registrales. T 4209 , F27, S 8, H A 79833, I/A 72 (20.11.20).

13 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER.Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER.Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 4209 , F 27,S 8, H A 79833, I/A 71 ( 3.12.19).

12 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A 79833, I/A 70 ( 2.12.19).

10 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Revocaciones. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Apo.Manc.:NU脩EZ GARCIA GABRIEL;YBA脩EZ RUBIO PABLO;LAZARO BA脩OS CARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAUREENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 4209 , F 27, S 8, H A79833, I/A 69 (28.11.19).

26 de Julio de 2019
Nombramientos. Consejero: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Reelecciones. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL. Datosregistrales. T 4209 , F 26, S 8, H A 79833, I/A 68 (18.07.19).

18 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;AZNARMARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS.Datos registrales. T 4209 , F 24, S 8, H A 79833, I/A 67 (11.07.19).

26 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3963 , F 209, S 8, H A 79833, I/A 66 (16.04.19).

24 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDORAPOSO FRANCISCO JOSE;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNARMARTINEZ JESUS;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 65 (12.04.19).

22 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GARCIA LILIA IVONNE;ALVAREZ EMBARBA RAQUEL. Datos registrales. T 3963 , F208, S 8, H A 79833, I/A 64 (10.04.19).

16 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 63 (8.04.19).

12 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRALCARLOS. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 62 ( 5.04.19).

11 de Abril de 2019
Nombramientos. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3963 , F 208, S 8, H A 79833, I/A 61 (3.04.19).

18 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3963 , F 207, S 8, H A 79833, I/A 60 (10.01.19).

08 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;CABELLO MU脩OZ ANTONIO;OVIEDORAPOSO FRANCISCO JOSE;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS;CABELLO MU脩OZANTONIO;YBA脩EZ RUBIO PABLO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 3963 , F 205, S 8,H A 79833, I/A 58 (27.12.18).

Nombramientos. Apoderado: NEBLE HASTA IGNACIO ADULFO. Datos registrales. T 3963 , F 207, S 8, H A 79833, I/A 59(28.12.18).

31 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LLANOS ALPERI JOSE MANUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANTOS RODRIGUEZCRISTINA. Datos registrales. T 3963 , F 205, S 8, H A 79833, I/A 57 (20.12.18).

28 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: OLIVERA MASSOPABLO. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 56 (19.12.18).

11 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DELCARMEN. VsecrNoConsj: FERNANDEZ MARTINEZ MARIA. Nombramientos. Consejero: CABELLO MU脩OZ ANTONIO.SecreNoConsj: PEREZ-CRESPO PAYA FRANCISCO. VsecrNoConsj: LLANOS ALPERI JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3963 ,F 204, S 8, H A 79833, I/A 55 ( 3.07.18).

09 de Julio de 2018
Reelecciones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 54 ( 2.07.18).

14 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 53 ( 6.02.18).

18 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A 79833, I/A 52 (10.01.17).

29 de Julio de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3963 , F 204, S 8, H A79833, I/A 51 (19.07.16).

27 de Julio de 2016
Reelecciones. Consejero: NU脩EZ GARCIA GABRIEL. Datos registrales. T 3587 , F 156, S 8, H A 79833, I/A 50 (18.07.16).

10 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;LAZARO BA脩OS CARLOS. Datosregistrales. T 3587 , F 155, S 8, H A 79833, I/A 49 ( 2.03.16).

02 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: LAZARO BA脩OS CARLOS. Datos registrales. T 3587 , F 155, S 8, H A 79833, I/A 48 (23.02.16).

22 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3587 , F 155, S 8, H A 79833, I/A 47 (14.01.16).

30 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS.Nombramientos. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 3587 , F 154, S 8, H A 79833, I/A 46 (21.12.15).

01 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Manc.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3587 , F154, S 8, H A 79833, I/A 45 (23.11.15).

22 de Junio de 2015
Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 3587 , F 154, S 8, H A 79833, I/A 44 (12.06.15).

17 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTSFUSTER LUIS MANUEL;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILIS EMILIO. Datos registrales. T 3587 , F 154, S 8,H A 79833, I/A 43 ( 9.06.15).

10 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3587 , F 154, S 8, HA 79833, I/A 42 ( 2.03.15).

11 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3587 , F 152,S 8, H A 79833, I/A 41 ( 3.02.15).

10 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;AZNAR MARTINEZ JESUS;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 40 ( 2.02.15).

06 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: AZNAR MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 39 (29.01.15).

27 de Enero de 2015
Nombramientos. Apoderado: ARRIBAS PERLINES JAVIER. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 38 (19.01.15).

09 de Junio de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: PAZO ESPINOSA FRANCISCO DE ASIS. Apo.Sol.: ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Apo.Manc.: ORTSFUSTER LUIS MANUEL;BENAVENT QUILIS EMILIO. Apo.Sol.: BENAVENT QUILIS EMILIO;POUSA POUSA ARTURO;OSUNAGOMEZ JUAN LUIS;BEJERANO TOME MANUEL. Apo.Manc.: BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO;OVIEDO RAPOSOFRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 37 (30.05.14).

30 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3587 , F 150, S 8, H A 79833, I/A 36 (22.01.14).

11 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 3587 , F 149, S 8, H A 79833, I/A 35 ( 2.12.13).

10 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T3587 , F 149, S 8, H A 79833, I/A 33 (28.11.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ GARCIA GABRIEL;GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. Datos registrales. T 3587 , F 149,S 8, H A 79833, I/A 34 ( 2.12.13).

05 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: CABELLO MU脩OZ ANTONIO;BENAVENT QUILIS EMILIO;ORTS FUSTER LUIS MANUEL. Datosregistrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 31 (27.11.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE;BENAVENT QUILIS EMILIO. Datos registrales. T 3587 , F149, S 8, H A 79833, I/A 32 (28.11.13).

04 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 30(24.10.13).

02 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Consejero: BAEZA OCHOA DE OCARIZRODRIGO;EZQUERRA PLASENCIA FELIPE;BEJERANO TOME MANUEL;HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Secretario:HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS;NU脩EZ GARCIAGABRIEL. Presidente: GARCIA FAURE ENEBRAL CARLOS. SecreNoConsj: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 29 (21.06.13).

25 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: EZQUERRA PLASENCIA FELIPE. Datos registrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 28 (17.06.13).

14 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3587 , F 147, S 8, H A 79833, I/A 27 ( 3.01.13).

02 de Marzo de 2012
Reelecciones. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Otrosconceptos: Modificaci贸n de los estatutos sociales. Datos registrales. T 3495 , F 91, S 8, H A 79833, I/A 26 (22.02.12).

29 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO. Nombramientos. VsecrNoConsj: FERNANDEZ MARTINEZMARIA. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 25 (17.02.12).

10 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-PITA RIPOLLES ISABEL. Nombramientos. Secretario: HONRADO HONRADO MARIADEL CARMEN. VsecrNoConsj: SERRANO BALSEYRO ALVARO. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 24 (29.12.11).

27 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: GACITUAGA FERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 23(15.12.11).

31 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: EZQUERRA PLASENCIA FELIPE;BAEZA OCHOA DE OCARIZ RODRIGO;OVIEDO RAPOSOFRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3495 , F 90, S 8, H A 79833, I/A 22 (22.12.10).

30 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA GOMEZ JUAN LUIS;BEJERANO TOME MANUEL. Datos registrales. T 3253 , F 137, S 8, H A79833, I/A 21 (21.12.10).

10 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: POUSA POUSA ARTURO. Datos registrales. T 3253 , F 137, S 8, H A 79833, I/A 20 (29.07.10).

22 de Enero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.820.000,00 Euros. Desembolsado: 2.820.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.820.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 17.820.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. =ARTICULO 帽7潞.- Acciones=.-. Datos registrales. T3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 19 (13.01.10).

27 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Presidente: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA.Consejero: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Cons.Del.Man: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA;BAEZA OCHOA DEOCARIZ RODRIGO. Nombramientos. Consejero: EZQUERRA PLASENCIA FELIPE;BEJERANO TOME MANUEL;HONRADOHONRADO MARIA DEL CARMEN.Presidente: OVIEDO RAPOSO FRANCISCO JOSE. Reelecciones. Consejero: BAEZA OCHOADE OCARIZ RODRIGO. Datos registrales. T 3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 18 (17.11.09).

06 de Noviembre de 2009
Cambio de domicilio social. MUELL PONIENTE, MUELLE 23 - JUNTO ESTACION PASAJER (ALICANTE). Datos registrales. T3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 17 (28.10.09).

05 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 16 (26.10.09).

01 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL. Nombramientos. Consejero: OVIEDO RAPOSO FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 3253 , F 136, S 8, H A 79833, I/A 15 (20.03.09).

31 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLUDA FOS VICENTE. Presidente: BOLUDA FOS VICENTE. Nombramientos. Consejero:BOLUDA CORPORACION MARITIMA SL. Presidente: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Datos registrales. T 3253 , F 135, S8, H A 79833, I/A 14 (18.03.09).

27 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BEJERANO TOME MANUEL. Cons.Del.Man: MILLER ALICANTE SL. Consejero: MILLER ALICANTESL. Nombramientos. Consejero: VICIANA PEDROSA MANUEL;BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Datos registrales. T3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 12 (13.03.09).

Nombramientos. Cons.Del.Man: BOLUDA TERMINALES MARITIMAS SA. Datos registrales. T 3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 13(16.03.09).

25 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: HONRADO HONRADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-PITARIPOLLES ISABEL. Datos registrales. T 3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 10 (12.03.09).

24 de Marzo de 2009
Reelecciones. Consejero: BOLUDA FOS VICENTE. Presidente: BOLUDA FOS VICENTE. Consejero: BEJERANO TOME MANUEL.Datos registrales. T 3253 , F 135, S 8, H A 79833, I/A 9 (11.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n