Actos BORME de Termiser Servicios Integrales Sl
09 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LORENZO MORANTE ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ DE LEON PALOMA.Consejero: LORENZO RODENAS MANUEL;LORENZO MORANTE MARTA;LORENZO MORANTE MANUEL;LORENZO MORANTEANTONIO. Presidente: LORENZO RODENAS MANUEL. Apoderado: LORENZO MORANTE ANTONIO. Modificaciones estatutarias.12. Ejercicio y duraci贸n del cargo.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 35351 , F 110, S 8, H M 384958, I/A 43 (30.12.22).
11 de Febrero de 2021Revocaciones. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDITASSURANCE SL. Datos registrales. T 35351 , F 110, S 8, H M 384958, I/A 42 ( 4.02.21).
10 de Marzo de 2020Nombramientos. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35351 , F 110, S 8, H M 384958, I/A 41 ( 3.03.20).
15 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ ESPINOSA DAVID. Datos registrales. T 35351 , F 109, S 8, H M 384958, I/A 40 ( 8.11.19).
17 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: CAPDEVILA PAZ JESUS. Datos registrales. T 35351 , F 109, S 8, H M 384958, I/A 39 (10.10.19).
28 de Enero de 2019Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TERMISER SERVICIOS SL. Datos registrales. T 35351 , F 107, S 8, H M 384958,I/A 38 (18.01.19).
06 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA FLOR ENRIQUE ALFONSO. Datos registrales. T 35351 , F 107, S 8, H M 384958, I/A 36(24.08.18).
Nombramientos. Apoderado: CAPDEVILA PAZ JESUS. Datos registrales. T 35351 , F 107, S 8, H M 384958, I/A 37 (24.08.18).
07 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: ZAPATA GONZALEZ JOSE;SOLAR CADAVIECO JOSE LUIS;ZAPATA GONZALEZ JOSE. Apo.Sol.:RABANAL MOYA DIEGO. Datos registrales. T 35351 , F 107, S 8, H M 384958, I/A 35 (30.03.17).
27 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: MALFAZ BARRIGA PABLO. Datos registrales. T 35351 , F 106, S 8, H M 384958, I/A 34 (17.02.17).
27 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: LAFIRMA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35351 , F 106, S 8, H M 384958, I/A 33 (19.01.17).
21 de Diciembre de 2016Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ALM ASOCIADOS GLOBAL GESTION DE PATRIMONIO Y ACTIV. Datosregistrales. T 35351 , F 103, S 8, H M 384958, I/A 32 (12.12.16).
19 de Diciembre de 2016Otros conceptos: Adquisici贸n de parte del patrimonio de la Sociedad escindida "S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION,S.A.". Datos registrales. T 35351 , F 100, S 8, H M 384958, I/A 31 ( 7.12.16).
03 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: BELLIDO SAGARRA ENZO;ORTU脩O LASTRA RAUL. Datos registrales. T 21629 , F 225, S 8, H M384958, I/A 30 (25.10.16).
29 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL. Datos registrales. T 21629 , F 225, S 8, H M 384958, I/A 29(22.09.16).
23 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ PASTOR JAVIER. Datos registrales. T 21629 , F 225, S 8, H M 384958, I/A 28(15.09.16).
24 de Agosto de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: LORENZO RODENAS MANUEL. Datos registrales. T 21629 , F225, S 8, H M 384958, I/A 27 (16.08.16).
05 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA FLOR ENRIQUE ALFONSO;RABANAL MOYA DIEGO. Datos registrales. T 21629 , F 224, S 8, HM 384958, I/A 26 (28.03.16).
02 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ORTU脩O LASTRA RAUL. Datos registrales. T 21629 , F 224, S 8, H M 384958, I/A 25 (24.11.15).
07 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: UBEDA ROMERO PEDRO. Datos registrales. T 21629 , F 224, S 8, H M 384958, I/A 24 (30.10.14).
20 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PASTOR JAVIER. Datos registrales. T 21629 , F 223, S 8, H M 384958, I/A 23(12.08.14).
12 de Junio de 2014Nombramientos. Auditor: LAFIRMA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 21629 , F 223, S 8, H M 384958, I/A 22 ( 2.06.14).
04 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: PARRA JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 21629 , F 223, S 8, H M 384958, I/A 21 (22.03.12).
16 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: BELLIDO SAGARRA ENZO. Datos registrales. T 21629 , F 222, S 8, H M 384958, I/A 19 ( 5.03.12).
Nombramientos. Apoderado: BRAVO GARCIA RAUL. Datos registrales. T 21629 , F 222, S 8, H M 384958, I/A 20 ( 5.03.12).
10 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: ORBE GANGOITI KEPA. Datos registrales. T 21629 , F 221, S 8, H M 384958, I/A 17 (31.05.11).
Revocaciones. Apoderado: MOLINA ROA SALVADOR ALBERTO. Datos registrales. T 21629 , F 222, S 8, H M 384958, I/A 18(31.05.11).
27 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: MALFAZ BARRIGA PABLO. Datos registrales. T 21629 , F 220, S 8, H M 384958, I/A 14 (17.05.11).
Nombramientos. Apoderado: BARRENA SUSO JOSU. Datos registrales. T 21629 , F 220, S 8, H M 384958, I/A 15 (17.05.11).
Nombramientos. Apoderado: VICENTE PELAEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 21629 , F 221, S 8, H M 384958, I/A 16 (17.05.11).
26 de Agosto de 2010Nombramientos. Apoderado: ORBE GANGOITI KEPA. Datos registrales. T 21629 , F 160, S 8, H M 384958, I/A 11 (17.08.10).
Nombramientos. Apoderado: PARRA JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 21629 , F 160, S 8, H M 384958, I/A 12 (17.08.10).
Nombramientos. Apoderado: MOLINA ROA SALVADOR ALBERTO. Datos registrales. T 21629 , F 160, S 8, H M 384958, I/A 13(17.08.10).
07 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: HOYOS MARTINEZ MIGUEL-ANGEL. Datos registrales. T 21629 , F 159, S 8, H M 384958, I/A 9(25.06.10).
Nombramientos. Apoderado: UBEDA ROMERO PEDRO. Datos registrales. T 21629 , F 159, S 8, H M 384958, I/A 10 (25.06.10).
21 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: SOLAR CADAVIECO JOSE LUIS. Datos registrales. T 21629 , F 157, S 8, H M 384958, I/A 6(10.06.10).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTIN RAUL. Datos registrales. T 21629 , F 158, S 8, H M 384958, I/A 7 (10.06.10).
Nombramientos. Apoderado: ZAPATA GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 21629 , F 158, S 8, H M 384958, I/A 8 (10.06.10).