Actos BORME de Terra Mitica Parque Tematico De Benidorm Sa
27 de Diciembre de 2023Ampliacion del objeto social. La producci贸n de energ铆a el茅ctrica de tecnolog铆a solar fotovoltaica. Datos registrales. T 4554 , F 64,S 8, H A 46268, I/A 120 (19.12.23).
30 de Octubre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.670.121,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.041.452,00 Euros. Datos registrales. T4554 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 119 (20.10.23).
28 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Datos registrales. T 4554 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 118(20.03.23).
27 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Datos registrales. T 2790 , F 76, S 8, H A 46268, I/A 117(17.03.23).
23 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Nombramientos. Adm. Unico: GROUPE SANTA MARIA SAS.Datos registrales. T 2790 , F 76, S 8, H A 46268, I/A 116 (14.03.23).
06 de Febrero de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.670.121,00 Euros. Resultante Suscrito: 216.711.573,00 Euros. Datos registrales. T2790 , F 75, S 8, H A 46268, I/A 115 (27.01.23).
16 de Agosto de 2022Reelecciones. Adm. Unico: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Datos registrales. T 2790 , F 75, S 8, H A 46268, I/A 114 (5.08.22).
10 de Enero de 2022Nombramientos. Auditor: GEAUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2790 , F 75, S 8, H A 46268, I/A 113 (30.12.21).
05 de Enero de 2021Ampliacion del objeto social. actividades de hospedaje en el parque y su entorno. Datos registrales. T 2790 , F 75, S 8, H A46268, I/A 112 (24.12.20).
03 de Febrero de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.105.487,00 Euros. Resultante Suscrito: 233.381.694,00 Euros. Datos registrales. T2790 , F 74, S 8, H A 46268, I/A 111 (24.01.20).
30 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: AUGE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2790 , F 74, S 8, H A 46268, I/A 110 (22.01.20).
30 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: SANTA MARIA FRANCK OLIVIER. Datos registrales. T 2790 , F 74, S 8, H A 46268, I/A 109(22.01.19).
29 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: SANTA MARIA FRANCK OLIVIER. Datos registrales. T 2790 , F 72, S 8, H A 46268, I/A 108(21.01.19).
28 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: VALERA MU脩OZ JOAQUIN;VALERA MU脩OZ JOAQUIN. Datos registrales. T 2790 , F 72, S 8, H A46268, I/A 107 (19.12.18).
27 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: VALERA MU脩OZ JOAQUIN. Datos registrales. T 2790 , F 72, S 8, H A 46268, I/A 106 (19.07.18).
28 de Diciembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.105.487,00 Euros. Resultante Suscrito: 247.487.181,00 Euros. Datos registrales. T2790 , F 71, S 8, H A 46268, I/A 105 (19.12.17).
01 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: RONDA CALVO FRANCISCO. Con.Delegado: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Consejero:SANTA MARIA GEORGES PIERRE;VALERA MU脩OZ JOAQUIN;SANTA MARIA FRANCK OLIVIER;BATAOUCHE PEREZ ROBERT-EDGARD. Presidente: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Secretario: VALERA MU脩OZ JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Unico:SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5.- Domicilio social.. ARTICULO 8. Forma de lasacciones, suscripci贸n adquisici贸n y transmisi贸n de las mismas.. ARTICULO 12. Organos sociales.. ARTICULO 17. Constituci贸n de lamesa.. ARTICULO 20. Actas.. ARTICULO 25. Facultades del Director General.. ARTICULO 27. Formulaci贸n y aprobaci贸n de. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Derogado 铆ntegramente la"Secci贸n II. Consejo de Administraci贸n" del "Titulo III. Organos de la Sociedad" de los Estatutos Sociales, y consiguientemente, todoslos art铆culos que la integran, del 21 a 24, ambos incluidos, as铆 como el art铆culo 31 de los estatutos sociales.- Datos registrales. T2790 , F 71, S 8, H A 46268, I/A 104 (25.08.16).
25 de Mayo de 2016Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 11.499.956,00 Euros. Datos registrales. T 2790 , F 71, S 8, H A 46268, I/A103 (17.05.16).
25 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: AUGE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2790 , F 71, S 8, H A 46268, I/A 102 (15.01.16).
27 de Julio de 2015Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 5.000.040,00 Euros. Datos registrales. T 2790 , F 70, S 8, H A 46268, I/A101 (17.07.15).
08 de Mayo de 2015Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 5.000.040,00 Euros. Datos registrales. T 2790 , F 70, S 8, H A 46268, I/A100 (29.04.15).
08 de Enero de 2013Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14潞.- Convocatoria Junta General.- . P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩ginaweb corporativa: terramiticapark.com. Datos registrales. T 2790 , F 70, S 8, H A 46268, I/A 98 (28.12.12).
31 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 64.500.108,00 Euros. Desembolsado: 43.000.072,00 Euros. Resultante Suscrito: 261.592.668,00Euros. Resultante Desembolsado: 240.092.632,00 Euros. Datos registrales. T 2790 , F 69, S 8, H A 46268, I/A 97 (14.12.12).
20 de Septiembre de 2012Nombramientos. Auditor: AUGE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2790 , F 69, S 8, H A 46268, I/A 96 (10.09.12).
11 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: VALERA MU脩OZ JOAQUIN. Datos registrales. T 2790 , F 69, S 8, H A 46268, I/A 95 (31.08.12).
28 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: TINSER CARTERA SL;BANCAJA PARTICIPACIONES SL. Presidente: ESTUDIOS DEINVESTIGACION SERVICIO SL. Consejero: ESTUDIOS DE INVESTIGACION SERVICIO SL;SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOSDE LA COMUNIDAD VALEN. Vicesecret.: SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALEN. Consejero: RONDACALVO FRANCISCO. Secretario: RONDA CALVO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: SANTA MARIA GEORGESPIERRE;VALERA MU脩OZ JOAQUIN;SANTA MARIA FRANCK OLIVIER;BATAOUCHE PEREZ ROBERT-EDGARD;RONDA CALVOFRANCISCO. Datos registrales. T 2790 , F 68, S 8, H A 46268, I/A 91 (17.08.12).
Nombramientos. Presidente: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Secretario: VALERA MU脩OZ JOAQUIN. Datos registrales. T2790 , F 68, S 8, H A 46268, I/A 92 (17.08.12).
Nombramientos. Con.Delegado: SANTA MARIA GEORGES PIERRE. Datos registrales. T 2790 , F 68, S 8, H A 46268, I/A 93(17.08.12).
31 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2790 , F 68, S 8, H A 46268, I/A 89 (19.01.12).
26 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2790 , F 67, S 8, H A 46268, I/A 88 (16.01.12).
08 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: EDIFICACIONES CALPE SA;MONDUBER SA;RONDA CALVO FRANCISCO;PEREZ SUCHMATIAS;LOBON MARTIN LUIS;BANCAJA PARTICIPACIONES SL;FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA;CAJADE AHORROS DEL MEDITERRANEO;GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL. Secretario: RONDA CALVO FRANCISCO.Miem.Com.Ej.: CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO;LOBON MARTIN LUIS. Consejero: CAJA DE AHORROS DE VALENCIACASTELLON Y ALICANTE B;ESTUDIOS DE INVESTIGACION SERVICIO SL. Presidente: ESTUDIOS DE INVESTIGACIONSERVICIO SL. Miem.Com.Ej.: ESTUDIOS DE INVESTIGACION SERVICIO SL. Pres.Com.Ej.: ESTUDIOS DE INVESTIGACIONSERVICIO SL. Miem.Com.Ej.: SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALEN. Consejero: SOCIEDADPROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALEN. Sec.Com.Ej.: SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDADVALEN. Miem.Com.Ej.: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE B. Nombramientos. Consejero: SOCIEDADPROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALEN;BANCAJA PARTICIPACIONES SL;TINSER CARTERA SL;ESTUDIOS DEINVESTIGACION SERVICIO SL;RONDA CALVO FRANCISCO. Presidente: ESTUDIOS DE INVESTIGACION SERVICIO SL.Secretario: RONDA CALVO FRANCISCO. Vicesecret.: SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALEN.Modificaciones estatutarias. Articulo 11潞. Transmisi贸n de acciones. Art铆culo 21潞. Constituci贸n y Composici贸n. Articulo 22潞. R茅gimende funcionamiento . Art铆culo 24潞. Consejero Delegado. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 4潞.- Objeto Social. Datos registrales. T 2790, F 66, S 8, H A 46268, I/A 86 (27.01.11).
17 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: CUENCA PEREZ ANTONIO MIGUEL. Apoderado: NAVARRO MARTINEZ MARIA ELISA. Apo.Man.Soli: DETORRES ROMO JUAN JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO MARTINEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 2790 , F66, S 8, H A 46268, I/A 85 ( 4.11.10).
08 de Octubre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE TORRES ROMO JUAN JOSE. Datos registrales. T 2790 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 83(28.09.09).
13 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: BANCAJA PARTICIPACIONES SL. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: CAJA DE AHORROS DEVALENCIA CASTELLON Y ALICANTE B. Datos registrales. T 2790 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 82 ( 3.08.09).
11 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2790 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 81 (30.07.09).
03 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Sec.Com.Ej.: LOBON MARTIN LUIS. Nombramientos. Sec.Com.Ej.: SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOSDE LA COMUNIDAD VALEN. Datos registrales. T 2790 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 80 (22.05.09).
04 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: FITZGERALD JOHN FRANCIS. Apo.Manc.: FITZGERALD JOHN FRANCIS. Datos registrales. T 2790 ,F 64, S 8, H A 46268, I/A 79 (20.04.09).
29 de Abril de 2009Revocaciones. Apoderado: MILLET SERRANO MARIA LOURDES ISABEL. Apo.Manc.: MILLET SERRANO MARIA LOURDESISABEL. Datos registrales. T 2790 , F 64, S 8, H A 46268, I/A 78 (17.04.09).