Actos BORME de Terra Natura Sa
16 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 83, S 8, H A 98929, I/A 47( 9.11.23).
30 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 83, S 8, H A 98929, I/A 46(21.11.22).
04 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 83, S 8, H A 98929, I/A 45(26.10.21).
15 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 83, S 8, H A 98929, I/A 44( 3.12.20).
28 de Octubre de 2020Reelecciones. Adm. Solid.: FUERTES FERNANDEZ TOMAS;FUERTES FERNANDEZ JOSE;FUERTES FERNANDEZ JUANA.Datos registrales. T 4033 , F 83, S 8, H A 98929, I/A 43 (20.10.20).
12 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 83, S 8, H A 98929, I/A 42( 2.12.19).
28 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 82, S 8, H A 98929, I/A 41(19.12.18).
17 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4033 , F 82, S 8, H A 98929, I/A 40( 8.11.17).
14 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: ZAPATA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: ZAPATA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 4033 , F 82, S 8, H A 98929, I/A 39 ( 6.06.17).
13 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO. Apo.Sol.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO. Datosregistrales. T 4033 , F 82, S 8, H A 98929, I/A 38 ( 1.06.17).
18 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 3737 , F 82, S 8, H A 98929, I/A 36 (4.05.17).
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: DIAZ GARCIA BARTOLOME. Datos registrales. T 3737 , F 82, S 8, H A 98929, I/A 37 ( 8.05.17).
10 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: FUERTES GOMEZ AUGUSTO;ZAPATA GARCIA FRANCISCO JAVIER;PEREA ESTEVE LUIS.Apo.Manc.: FUERTES GOMEZ AUGUSTO;ZAPATA GARCIA FRANCISCO JAVIER;PEREA ESTEVE LUIS. Datos registrales. T
05 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: FUERTES GOMEZ AUGUSTO. Apo.Manc.: FUERTES GOMEZ AUGUSTO. Datos registrales. T 3737, F 8, S 8, H A 98929, I/A 34 (25.04.17).
23 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3737 , F 8, S 8, H A 98929, I/A 33(15.12.16).
26 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: FUERTES GOMEZ AUGUSTO. Datos registrales. T 3737 , F 8, S 8, H A 98929, I/A 32 (19.10.16).
25 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;ZAPATA GARCIA FRANCISCOJAVIER. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;ZAPATA GARCIA FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 3737 , F 7, S 8, H A 98929, I/A 31 (17.10.16).
27 de Julio de 2016Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DOMINGUEZ ALONSO. Datos registrales. T 3737 , F 7, S 8, H A 98929, I/A 30 (18.07.16).
22 de Julio de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3737 , F 7, S 8, H A 98929, I/A 29(14.07.16).
23 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL;VIS HOTELES SL;AGRIFU SA;CEFU SA. Presidente:GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL. Vicepresid.: VIS HOTELES SL. Secretario: AGRIFU SA. Co.De.Ma.So: GRUPOCORPORATIVO FUERTES SL;CEFU SA. VsecrNoConsj: MELGAR MORAIS JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: FUERTESFERNANDEZ TOMAS;FUERTES FERNANDEZ JOSE;FUERTES FERNANDEZ JUANA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO10.- Transmisi贸n de acciones.. ARTICULO 12.- Organos de gobierno de la Sociedad.. ARTICULO 17.- Funcionamiento Junta general.ARTICULO 18.- Acta acuerdos sociales.- . ARTICULO 21.- Administraci贸n de la sociedad.- . ARTICULO 22.- Retribuci贸n y duraci贸n delcargo.- . ARTICULO 23.- Regulaci贸n consejo de administraci贸n.- . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 3737 , F 5, S 8, H A 98929, I/A 28 (16.06.16).
02 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3737 , F 5, S 8, H A 98929, I/A 27(24.11.14).
07 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: FUERTES GOMEZ AUGUSTO. Datos registrales. T 3737 , F 5, S 8, H A 98929, I/A 25 (30.10.14).
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;BILBAO LAREDO LEIRE. Datos registrales. T 3737 , F 5, S8, H A 98929, I/A 26 (31.10.14).
26 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;DIAZ GARCIA BARTOLOME.Datos registrales. T 3737 , F 5, S 8, H A 98929, I/A 24 (19.09.14).
20 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VIS HOTELES SL. Presidente: VIS HOTELES SL. Consejero: GRUPO CORPORATIVO FUERTESSL. Vicepresid.: GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL. Consejero: AGRIFU SA. Secretario: AGRIFU SA. Consejero: CEFUSA;COLORTEX SA;GESTION DE PROYECTOS ARANTIA SL;ACTION PARK MULTIFORMA GRUPO SL. Co.De.Ma.So: GRUPOCORPORATIVO FUERTES SL;CEFU SA. Nombramientos. VsecrNoConsj: MELGAR MORAIS JUAN JOSE. Consejero: GRUPOCORPORATIVO FUERTES SL;VIS HOTELES SL;AGRIFU SA;CEFU SA. Presidente: GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL.Vicepresid.: VIS HOTELES SL. Secretario: AGRIFU SA. Co.De.Ma.So: GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL;CEFU SA. Datosregistrales. T 3369 , F 20, S 8, H A 98929, I/A 22 (12.12.13).
Otros conceptos: Modificaci贸n de los estatutos sociales.- Cambio de objeto social. a) La promoci贸n, organizaci贸n y contrataci贸nde cuantas actividades requiera la construcci贸n puesta en funcionamiento y explotaci贸n del Parque Tem谩tico denominado Terra Naturay de cuantas instalaciones y actividades haya o se desarrollen en el mismo. b) La construcci贸n, instalaci贸n, gesti贸n y explo. Datosregistrales. T 3369 , F 20, S 8, H A 98929, I/A 23 (13.12.13).
26 de Septiembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 32.576.362,83 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:12.251.300,00 Euros. Desembolsado: 12.251.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.251.300,00 Euros. Resultante Desembolsado:12.251.300,00 Euros. Datos registrales. T 3369 , F 19, S 8, H A 98929, I/A 21 (18.09.13).
14 de Marzo de 2013Modificaciones estatutarias. Art铆culo 15潞.- Forma de convocatoria de la Junta General.. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n dela p谩gina web corporativa: terranatura.com. Datos registrales. T 3369 , F 19, S 8, H A 98929, I/A 20 ( 4.03.13).
02 de Diciembre de 2011Revocaciones. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESSL. Datos registrales. T 3369 , F 19, S 8, H A 98929, I/A 19 (22.11.11).
05 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;BILBAO LAREDO LEIRE.Datos registrales. T 3369 , F 18, S 8, H A 98929, I/A 17 (26.09.11).
27 de Abril de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ-RODENAS GARCIA-BALIBREA FRANCISCO JOSE;GAFORIO NEBREDA JOSEALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO. Datos registrales. T 3369 , F 18, S 8, H A 98929, I/A 16 (13.04.11).
16 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;RUANO GOMEZ CARLOS.Apo.Sol.: RUANO GOMEZ CARLOS;GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO. Datos registrales. T3369 , F 18, S 8, H A 98929, I/A 14 ( 2.12.10).
17 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;PEREZ-RODENAS GARCIA-BALIBREA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3369 , F 18, S 8, H A 98929, I/A 13 ( 4.11.10).
13 de Abril de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 38.365.117,14 Euros. Resultante Suscrito: 25.327.282,86 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 7.249.079,97 Euros. Desembolsado: 7.249.079,97 Euros. Resultante Suscrito: 32.576.362,83 Euros. ResultanteDesembolsado: 32.576.362,83 Euros. Datos registrales. T 3369 , F 17, S 8, H A 98929, I/A 12 (31.03.10).
24 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: VIS HOTELES SL. Nombramientos. Co.De.Ma.So: CEFU SA. Datos registrales. T 3369 , F 17,S 8, H A 98929, I/A 11 (14.12.09).
18 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SL. Datos registrales. T 3369 , F 17, S 8, H A 98929, I/A 10 ( 6.11.09).
14 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;RUANO GOMEZ CARLOS.Apo.Sol.: GAFORIO NEBREDA JOSE ALBERTO;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;RUANO GOMEZ CARLOS. Datos registrales. T
13 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 634.200,00 Euros. Desembolsado: 634.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 63.692.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 63.692.400,00 Euros. Datos registrales. T 3051 , F 91, S 8, H A 98929, I/A 8 (30.03.09).
07 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: TABERNER MOLINERO MIGUEL FERNANDO;CAMBRA MATAIX JOSE LUIS;TORMO SANTONJAGONZALO;COTINO ESCRIBA VICENTE;RIBARROCHA RIBARROCHA ALFONSO;FUERTES FERNANDEZ TOMAS;FUERTESFERNANDEZ JOSE;CANOVAS BALLESTA JUAN;FUERTES GOMEZ AUGUSTO;FUERTES QUINTANILLA RAFAEL;CANOVASFUERTES MARIA JOSE. Presidente: TABERNER MOLINERO MIGUEL FERNANDO. Vicepresid.: FUERTES FERNANDEZ TOMAS.Secretario: CANOVAS FUERTES MARIA JOSE. Cons.Del.Sol: TABERNER MOLINERO MIGUEL FERNANDO;FUERTESFERNANDEZ TOMAS. Nombramientos. Consejero: VIS HOTELES SL. Presidente: VIS HOTELES SL. Consejero: GRUPOCORPORATIVO FUERTES SL. Vicepresid.: GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL. Consejero: AGRIFU SA. Secretario: AGRIFU SA.Consejero: CEFU SA;COLORTEX SA;SISTEMAS GLOBALES INMOBILIARIOS SL;ACTION PARK MULTIFORMA GRUPO SL.Co.De.Ma.So: VIS HOTELES SL;GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL. Datos registrales. T 3051 , F 90, S 8, H A 98929, I/A 7(26.03.09).