Actos BORME de The Good Burger Company Sl
27 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 219, S 8, H M 561076, I/A 40 (19.12.23).
21 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 219, S 8, H M 561076, I/A 38 (14.12.22).
03 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 31175 ,F 218, S 8, H M 561076, I/A 37 (27.12.21).
26 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTIN GIL BELEN;MARTIN GIL MARIA BELEN. Apo.Manc.: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datosregistrales. T 31175 , F 218, S 8, H M 561076, I/A 36 (19.08.21).
13 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ MELGAR EDUARDO;IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIAFERNANDO;IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO;IGLESIAS NIETO FERNANDOMANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO;SABIDO GARCIA FERNANDO;IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;IGLESIAS NIETOFERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO;SABIDO GARCIA FERNANDO;HERNANDEZ RAMIREZ SUSANA. Datosregistrales. T 31175 , F 216, S 8, H M 561076, I/A 35 ( 6.05.21).
12 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN GIL MARIA BELEN. Nombramientos. Adm. Unico: RESTALIA GRUPO DEEURORESTAURACION SL. Representan: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA. Datos registrales. T 31175 , F 215, S 8, H M561076, I/A 34 ( 5.05.21).
22 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ZARCO CARLA. Datos registrales. T 31175 , F 214, S 8, H M 561076, I/A 33 (15.02.21).
28 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 214, S 8, H M 561076, I/A 32 (18.12.20).
16 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: SABIDO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 31175 , F 213, S 8, H M 561076, I/A 31 (9.03.20).
15 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: SABIDO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 31175 , F 211, S 8, H M 561076, I/A 28 (8.01.20).
Nombramientos. Apo.Manc.: IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;ANTON FAURA RAUL. Datos registrales. T 31175 , F 213, S8, H M 561076, I/A 29 ( 8.01.20).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ HIPOLA JAVIER;ANTON FAURA RAUL. Apoderado: SANSO-RUBERT GONZALEZ ANA.Datos registrales. T 31175 , F 213, S 8, H M 561076, I/A 30 ( 8.01.20).
23 de Mayo de 2019Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 211, S 8, H M 561076, I/A 27 (16.05.19).
23 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VARANDA IGNACIO. Datos registrales. T 31175 , F 211, S 8, H M 561076, I/A 26(16.01.19).
18 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: SANSO-RUBERT GONZALEZ ANA. Datos registrales. T 31175 , F 210, S 8, H M 561076, I/A 25(10.01.19).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOTO GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 31175 , F 209, S 8, H M 561076, I/A 24 (13.06.17).
07 de Febrero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.280.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 320.200,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 31175 , F 209, S 8, H M 561076, I/A 23 (31.01.17).
11 de Julio de 2016Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ VARANDA IGNACIO;ANTON FAURA RAUL;CASADO ALVAREZ CRISTINA;MARTIN GILMARIA BELEN;MADRID RACERO ROSA;DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ HIPOLAJAVIER;ANTON FAURA RAUL;GONZALEZ VARANDA IGNACIO. Apo.Manc.: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datos registrales. T31175 , F 208, S 8, H M 561076, I/A 22 ( 1.07.16).
25 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.601.000,00 Euros. Datos registrales. T 31175 , F 207, S8, H M 561076, I/A 21 (18.05.16).
28 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: SOTO GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 31175 , F 206, S 8, H M 561076, I/A 20 (21.04.16).
23 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN GIL MARIA BELEN.Datos registrales. T 31175 , F 205, S 8, H M 561076, I/A 18 (15.03.16).
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ VIZCANO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 31175 , F 206, S 8, H M 561076, I/A 19(15.03.16).
25 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datos registrales. T 31175 , F 124, S 8, H M 561076, I/A 15 (17.11.15).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VARANDA IGNACIO;ANTON FAURA RAUL;CASADO ALVAREZ CRISTINA;LOPEZVIZCANO JOSE ALBERTO;MARTIN GIL MARIA BELEN;MADRID RACERO ROSA;DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Datosregistrales. T 31175 , F 205, S 8, H M 561076, I/A 16 (17.11.15).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA TRIAS MARIA ISABEL. Datos registrales. T 31175 , F 205, S 8, H M 561076, I/A 17(17.11.15).
30 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VIZCAINO JOSE-ALBERTO. Datos registrales. T 31175 , F 123, S 8, H M 561076, I/A 14(22.09.15).
17 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: ROY MORALES ANA MARIA;ROY MORALES ANA MARIA. Datos registrales. T 31175 , F 123, S 8, HM 561076, I/A 13 ( 9.07.15).
19 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: DAMIANO REDONDO SILVIA. Datos registrales. T 31175 , F 123, S 8, H M 561076, I/A 12 (12.06.15).
19 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTIN GIL BELEN. Datos registrales. T 31175 , F 121, S 8, H M 561076, I/A 11 ( 8.05.15).
08 de Mayo de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.- Modificado el objeto social.. Cambio de objeto social. - Eldesarrollo, gesti贸n y explotaci贸n por cualquier t铆tulo de todo tipo de negocios de hosteler铆a y restauraci贸n, tanto directamente comomediante la concesi贸n de franquicias y licencias; y la realizaci贸n de cualesquiera actuaciones directamente relacionadas... Datosregistrales. T 31175 , F 121, S 8, H M 561076, I/A 10 (27.04.15).
10 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA TRIAS MARIA ISABEL. Datos registrales. T 31175 , F 120, S 8, H M 561076, I/A 9 (1.12.14).
01 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RESTALIA GENERAL MANAGEMENT SL;DONADO ESCUDERO VIRGINIA;PARDO ESCRIBANOJESUS. Presidente: RESTALIA GENERAL MANAGEMENT SL. Vicepresid.: PARDO ESCRIBANO JESUS. Con.Delegado: DONADOESCUDERO VIRGINIA. SecreNoConsj: ARENAS BOCANEGRA EDUARDO. Representan: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA.VsecrNoConsj: JIMENEZ MARISCAL SALVADOR. Nombramientos. Adm. Unico: DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Datosregistrales. T 31175 , F 120, S 8, H M 561076, I/A 8 (21.11.14).
06 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: MORENO CARRASCO VICENTE. Apo.Manc.: MORENO CARRASCO VICENTE;PEREZ TENORIOCARLOS LEON;PARDO ESCRIBANO JESUS;MORENO CARRASCO VICENTE. Datos registrales. T 31175 , F 119, S 8, H M561076, I/A 7 (29.07.14).
24 de Marzo de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 98.030,00 Euros. Resultante Suscrito: 101.030,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:299.970,00 Euros. Resultante Suscrito: 401.000,00 Euros. Datos registrales. T 31175 , F 118, S 8, H M 561076, I/A 6 (17.03.14).
05 de Febrero de 2014Otros conceptos: MODIFICACION DE LAS FACULTADES DELEGADAS EN D脩A.VIRGINIA DONADO ESCUDERO COMOCONSEJERO DELEGADO EN VIRTUD DE ACUERDO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE CAUSO LA INSCRIPCION 4 DE LAHOJA SOCIAL. Datos registrales. T 31175 , F 118, S 8, H M 561076, I/A 5 (29.01.14).
29 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ CAPITANJOSE MARIA. SecreNoConsj: ARENAS BOCANEGRA EDUARDO. VsecrNoConsj: JIMENEZ MARISCAL SALVADOR. Consejero:RESTALIA GENERAL MANAGEMENT SL;DONADO ESCUDERO VIRGINIA;PARDO ESCRIBANO JESUS. Presidente: RESTALIAGENERAL MANAGEMENT SL. Vicepresid.: PARDO ESCRIBANO JESUS. Con.Delegado: DONADO ESCUDERO VIRGINIA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 31175 , F 117, S 8, H M 561076, I/A 4 (21.01.14).
06 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: ROY MORALES ANA MARIA. Datos registrales. T 31175 , F 116, S 8, H M 561076, I/A 3 (28.10.13).
30 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: PARDO ESCRIBANO JESUS;MORENO CARRASCO VICENTE;PEREZ TENORIO CARLOS LEON.Datos registrales. T 31175 , F 114, S 8, H M 561076, I/A 2 (23.07.13).
25 de Julio de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.04.13. Objeto social: LA EXPLOTACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADACON EL RAMO DE LA HOSTELERIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA MISMA. Domicilio: AVDA DE EUROPA 19 3& -EDIFICIO 2 (POZUELO DE ALARCON). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RESTALIAGRUPO DE EURORESTAURACION SL. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA. Apoderado:MORENO CARRASCO VICENTE;ROY MORALES ANA MARIA. Apo.Manc.: MORENO CARRASCO VICENTE;PEREZ TENORIOCARLOS LEON. Apoderado: DAMIANO REDONDO SILVIA. Datos registrales. T 31175 , F 107, S 8, H M 561076, I/A 1 (17.07.13).