Buscador CIF Logo

Actos BORME The Good Burger Company Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera The Good Burger Company Sl

Actos BORME The Good Burger Company Sl - B86740297

Tenemos registrados 39 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para The Good Burger Company Sl con CIF B86740297

馃敊 Perfil de The Good Burger Company Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de The Good Burger Company Sl

27 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 219, S 8, H M 561076, I/A 40 (19.12.23).

21 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 219, S 8, H M 561076, I/A 38 (14.12.22).

03 de Enero de 2022
Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 31175 ,F 218, S 8, H M 561076, I/A 37 (27.12.21).

26 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: MARTIN GIL BELEN;MARTIN GIL MARIA BELEN. Apo.Manc.: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datosregistrales. T 31175 , F 218, S 8, H M 561076, I/A 36 (19.08.21).

13 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ MELGAR EDUARDO;IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIAFERNANDO;IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO;IGLESIAS NIETO FERNANDOMANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO;SABIDO GARCIA FERNANDO;IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;IGLESIAS NIETOFERNANDO MANUEL;SABIDO GARCIA FERNANDO;SABIDO GARCIA FERNANDO;HERNANDEZ RAMIREZ SUSANA. Datosregistrales. T 31175 , F 216, S 8, H M 561076, I/A 35 ( 6.05.21).

12 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN GIL MARIA BELEN. Nombramientos. Adm. Unico: RESTALIA GRUPO DEEURORESTAURACION SL. Representan: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA. Datos registrales. T 31175 , F 215, S 8, H M561076, I/A 34 ( 5.05.21).

22 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ZARCO CARLA. Datos registrales. T 31175 , F 214, S 8, H M 561076, I/A 33 (15.02.21).

28 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 214, S 8, H M 561076, I/A 32 (18.12.20).

16 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: SABIDO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 31175 , F 213, S 8, H M 561076, I/A 31 (9.03.20).

15 de Enero de 2020
Nombramientos. Apoderado: SABIDO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 31175 , F 211, S 8, H M 561076, I/A 28 (8.01.20).

Nombramientos. Apo.Manc.: IGLESIAS NIETO FERNANDO MANUEL;ANTON FAURA RAUL. Datos registrales. T 31175 , F 213, S8, H M 561076, I/A 29 ( 8.01.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ HIPOLA JAVIER;ANTON FAURA RAUL. Apoderado: SANSO-RUBERT GONZALEZ ANA.Datos registrales. T 31175 , F 213, S 8, H M 561076, I/A 30 ( 8.01.20).

23 de Mayo de 2019
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31175 , F 211, S 8, H M 561076, I/A 27 (16.05.19).

23 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VARANDA IGNACIO. Datos registrales. T 31175 , F 211, S 8, H M 561076, I/A 26(16.01.19).

18 de Enero de 2019
Nombramientos. Apoderado: SANSO-RUBERT GONZALEZ ANA. Datos registrales. T 31175 , F 210, S 8, H M 561076, I/A 25(10.01.19).

23 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: SOTO GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 31175 , F 209, S 8, H M 561076, I/A 24 (13.06.17).

07 de Febrero de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.280.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 320.200,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 31175 , F 209, S 8, H M 561076, I/A 23 (31.01.17).

11 de Julio de 2016
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ VARANDA IGNACIO;ANTON FAURA RAUL;CASADO ALVAREZ CRISTINA;MARTIN GILMARIA BELEN;MADRID RACERO ROSA;DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ HIPOLAJAVIER;ANTON FAURA RAUL;GONZALEZ VARANDA IGNACIO. Apo.Manc.: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datos registrales. T31175 , F 208, S 8, H M 561076, I/A 22 ( 1.07.16).

25 de Mayo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.601.000,00 Euros. Datos registrales. T 31175 , F 207, S8, H M 561076, I/A 21 (18.05.16).

28 de Abril de 2016
Nombramientos. Apoderado: SOTO GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 31175 , F 206, S 8, H M 561076, I/A 20 (21.04.16).

23 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN GIL MARIA BELEN.Datos registrales. T 31175 , F 205, S 8, H M 561076, I/A 18 (15.03.16).

Revocaciones. Apoderado: LOPEZ VIZCANO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 31175 , F 206, S 8, H M 561076, I/A 19(15.03.16).

25 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: MARTIN GIL MARIA BELEN. Datos registrales. T 31175 , F 124, S 8, H M 561076, I/A 15 (17.11.15).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VARANDA IGNACIO;ANTON FAURA RAUL;CASADO ALVAREZ CRISTINA;LOPEZVIZCANO JOSE ALBERTO;MARTIN GIL MARIA BELEN;MADRID RACERO ROSA;DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Datosregistrales. T 31175 , F 205, S 8, H M 561076, I/A 16 (17.11.15).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA TRIAS MARIA ISABEL. Datos registrales. T 31175 , F 205, S 8, H M 561076, I/A 17(17.11.15).

30 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VIZCAINO JOSE-ALBERTO. Datos registrales. T 31175 , F 123, S 8, H M 561076, I/A 14(22.09.15).

17 de Julio de 2015
Revocaciones. Apoderado: ROY MORALES ANA MARIA;ROY MORALES ANA MARIA. Datos registrales. T 31175 , F 123, S 8, HM 561076, I/A 13 ( 9.07.15).

19 de Junio de 2015
Revocaciones. Apoderado: DAMIANO REDONDO SILVIA. Datos registrales. T 31175 , F 123, S 8, H M 561076, I/A 12 (12.06.15).

19 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: MARTIN GIL BELEN. Datos registrales. T 31175 , F 121, S 8, H M 561076, I/A 11 ( 8.05.15).

08 de Mayo de 2015
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.- Modificado el objeto social.. Cambio de objeto social. - Eldesarrollo, gesti贸n y explotaci贸n por cualquier t铆tulo de todo tipo de negocios de hosteler铆a y restauraci贸n, tanto directamente comomediante la concesi贸n de franquicias y licencias; y la realizaci贸n de cualesquiera actuaciones directamente relacionadas... Datosregistrales. T 31175 , F 121, S 8, H M 561076, I/A 10 (27.04.15).

10 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: GARCIA TRIAS MARIA ISABEL. Datos registrales. T 31175 , F 120, S 8, H M 561076, I/A 9 (1.12.14).

01 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: RESTALIA GENERAL MANAGEMENT SL;DONADO ESCUDERO VIRGINIA;PARDO ESCRIBANOJESUS. Presidente: RESTALIA GENERAL MANAGEMENT SL. Vicepresid.: PARDO ESCRIBANO JESUS. Con.Delegado: DONADOESCUDERO VIRGINIA. SecreNoConsj: ARENAS BOCANEGRA EDUARDO. Representan: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA.VsecrNoConsj: JIMENEZ MARISCAL SALVADOR. Nombramientos. Adm. Unico: DONADO ESCUDERO VIRGINIA. Datosregistrales. T 31175 , F 120, S 8, H M 561076, I/A 8 (21.11.14).

06 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apoderado: MORENO CARRASCO VICENTE. Apo.Manc.: MORENO CARRASCO VICENTE;PEREZ TENORIOCARLOS LEON;PARDO ESCRIBANO JESUS;MORENO CARRASCO VICENTE. Datos registrales. T 31175 , F 119, S 8, H M561076, I/A 7 (29.07.14).

24 de Marzo de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 98.030,00 Euros. Resultante Suscrito: 101.030,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:299.970,00 Euros. Resultante Suscrito: 401.000,00 Euros. Datos registrales. T 31175 , F 118, S 8, H M 561076, I/A 6 (17.03.14).

05 de Febrero de 2014
Otros conceptos: MODIFICACION DE LAS FACULTADES DELEGADAS EN D脩A.VIRGINIA DONADO ESCUDERO COMOCONSEJERO DELEGADO EN VIRTUD DE ACUERDO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE CAUSO LA INSCRIPCION 4 DE LAHOJA SOCIAL. Datos registrales. T 31175 , F 118, S 8, H M 561076, I/A 5 (29.01.14).

29 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ CAPITANJOSE MARIA. SecreNoConsj: ARENAS BOCANEGRA EDUARDO. VsecrNoConsj: JIMENEZ MARISCAL SALVADOR. Consejero:RESTALIA GENERAL MANAGEMENT SL;DONADO ESCUDERO VIRGINIA;PARDO ESCRIBANO JESUS. Presidente: RESTALIAGENERAL MANAGEMENT SL. Vicepresid.: PARDO ESCRIBANO JESUS. Con.Delegado: DONADO ESCUDERO VIRGINIA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 31175 , F 117, S 8, H M 561076, I/A 4 (21.01.14).

06 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: ROY MORALES ANA MARIA. Datos registrales. T 31175 , F 116, S 8, H M 561076, I/A 3 (28.10.13).

30 de Julio de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: PARDO ESCRIBANO JESUS;MORENO CARRASCO VICENTE;PEREZ TENORIO CARLOS LEON.Datos registrales. T 31175 , F 114, S 8, H M 561076, I/A 2 (23.07.13).

25 de Julio de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.04.13. Objeto social: LA EXPLOTACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADACON EL RAMO DE LA HOSTELERIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA MISMA. Domicilio: AVDA DE EUROPA 19 3& -EDIFICIO 2 (POZUELO DE ALARCON). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RESTALIAGRUPO DE EURORESTAURACION SL. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ CAPITAN JOSE MARIA. Apoderado:MORENO CARRASCO VICENTE;ROY MORALES ANA MARIA. Apo.Manc.: MORENO CARRASCO VICENTE;PEREZ TENORIOCARLOS LEON. Apoderado: DAMIANO REDONDO SILVIA. Datos registrales. T 31175 , F 107, S 8, H M 561076, I/A 1 (17.07.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n