Actos BORME de The Grill Concept Sl
30 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AMEREST SP ZOO. Representan: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO. Nombramientos.Liquidador: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 41149 , F 103, S 8, H M659956, I/A 18 (23.08.22).
27 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: PASCUAL SENTIERI JOSE DAVID. Datos registrales. T 41149 , F 102, S 8, H M 659956, I/A 17(20.07.21).
11 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: ROSADO ALCANTARA FRANCISCO MANUEL;DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T41149 , F 102, S 8, H M 659956, I/A 16 ( 4.06.21).
02 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: RANDALL CHANDLER MARK. Nombramientos. Representan: ZAMARRIPA ESCAMILLAEDUARDO. Datos registrales. T 38285 , F 39, S 8, H M 659956, I/A 14 (23.02.21).
Revocaciones. Apoderado: COLLADO RODRIGUEZ JESUS;COLLADO RODRIGUEZ JESUS. Datos registrales. T 38285 , F 39, S8, H M 659956, I/A 15 (23.02.21).
16 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA. Datos registrales. T 38285 , F 39, S 8, H M 659956, I/A 13 (7.11.20).
21 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ZAMARRIPA ESCAMILLA EDUARDO;SANCHEZ MORENO ISMAEL;TARRERO MARTOS JAIME.Datos registrales. T 38285 , F 35, S 8, H M 659956, I/A 12 (14.08.20).
27 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 163 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 38285 , F 35, S 8, H M 659956,I/A 11 (20.03.20).
17 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA DEL VALLE FERNANDEZ SIMAL IGNACIO. Datos registrales. T 38285 , F 32, S 8, H M659956, I/A 10 (10.06.19).
18 de Marzo de 2019Otros conceptos: Se modifica el error material cometido en la inscripci贸n 6陋 de la hoja de esta sociedad, consistente en unadiscrepancia entre el importe que aparece en n煤mero y el que se rese帽a en letra, en la forma de ejercicio indicada a las facultadesdescritas en el apartado 2.2.5(i)de la lista de facultades. Datos registrales. T 38285 , F 31, S 8, H M 659956, I/A 9 (11.03.19).
14 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ MARTA;BOCETA MARTIN ALVARO. Datos registrales. T 38285 , F 31, S 8, H M659956, I/A 8 ( 7.03.19).
20 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: CHANDLER MARK RANDALL;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;COLLADO RODRIGUEZJESUS;GORGUES CARNICE DAVID;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;RIVERA CAMPOS ANGELICA;OLIVARESALVAREZ FERNANDO;HERNANDEZ LOPEZ JUAN RAMON;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA;RIZZO KUKUROVVERONICA;CAMPA PARRAMON GLORIA;SANJUAN MATONS LOURDES;CATON ORDOZGOITI ROCIO;GORGUES CARNICEDAVID;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;ROIGETAMARIT JOSE;CAMPA PARRAMON GLORIA;SANJUAN MATONS LOURDES;BODET GOMEZ NURIA;CONTRERAS JAIMESGLADYS MARIA;CANALES MILANES DAVID;MUR MORELLO NURIA;RODES SALA CRISTIAN;MAESTRO GARCIA-DONAS JOSEMANUEL;DAVID JUSTO RODA. Apo.Man.Soli: ROSADO ALCANTARA FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 38285 , F 31, S8, H M 659956, I/A 7 (12.12.18).
07 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: PIECHNA KRZYSZTOF. Nombramientos. Apoderado: RANDALL CHANDLER MARK;PATO-CASTELTADEO MARIA ELENA;PIECHNA KRZYSZTOF;DAVID JUSTO RODA;BLASCO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER;ROIGE TAMARITJOSE;OLIVARES ALVAREZ FERNANDO;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;MONEDEROMATEO ALBERTO;ROSADO ALCANTARA FRANCISCO MANUEL;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA;RIZZO KUKUROVVERONICA;CAMPA PARRAMON GLORIA;DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS;SANJUAN MATONS LOURDES;RIVERA CAMPOSANGELICA;OLIVARES ALVAREZ FERNANDO;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;PINILLA RAMOS ABRAHAM. Datos registrales. T36885 , F 127, S 8, H M 659956, I/A 6 (30.10.18).
26 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: BOLINSKI PIOTR;BOLINSKI PIOTR. Nombramientos. Apoderado: PIECHNA KRZYSZTOF. Datosregistrales. T 36885 , F 121, S 8, H M 659956, I/A 5 (15.06.18).
23 de Mayo de 2018Cambio de domicilio social. C/ ENRIQUE GRANADOS 6 - EDIFICIO B, NIVEL 2, OFICI (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 36885 , F 121, S 8, H M 659956, I/A 3 (10.05.18).
Nombramientos. Apoderado: SIMON MONTELONGO JOSE MANUEL;PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES. Datos registrales. T36885 , F 121, S 8, H M 659956, I/A 4 (10.05.18).
04 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. C/ ENRIQUE GRANADOS 6 - EDIFICIO B, NIVEL 1, OFICI (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 36885 , F 100, S 8, H M 659956, I/A 1 (26.12.17).
10 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: ROSADO ALCANTARA FRANCISCO. Datos registrales. T 1484 , F 206, S 8, H L 29786, I/A 6 (3.05.17).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MAESTRO GARCIA-DONAS JOSE MANUEL;JUSTO RODA DAVID. Datos registrales. T 1484 , F 205,S 8, H L 29786, I/A 5 ( 7.03.17).
27 de Enero de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA. Apo.Sol.: PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA. Apo.Manc.:BOLINSKI PIOTR. Apo.Sol.: BOLINSKI PIOTR. Apo.Manc.: COLLADO RODRIGUEZ JESUS. Apo.Sol.: COLLADO RODRIGUEZJESUS. Apo.Manc.: GORGUES CARNICE DAVID. Apo.Sol.: GORGUES CARNICE DAVID. Apo.Manc.: JA脩EZ BARCENAS MARIADEL CARMEN. Apo.Sol.: JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN. Apo.Manc.: RIVERA CAMPOS ANGELICA. Apo.Sol.: RIVERACAMPOS ANGELICA. Apo.Manc.: OLIVARES ALVAREZ FERNANDO. Apo.Sol.: OLIVARES ALVAREZ FERNANDO. Apo.Manc.:HERNANDEZ LOPEZ JUAN RAMON. Apo.Sol.: HERNANDEZ LOPEZ JUAN RAMON. Apo.Manc.: CONTRERAS JAIMES GLADYSMARIA. Apo.Sol.: CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA. Apo.Manc.: RIZZO KUKUROV VERONICA. Apo.Sol.: RIZZO KUKUROVVERONICA. Apo.Manc.: CAMPA PARRAMON GLORIA. Apo.Sol.: CAMPA PARRAMON GLORIA. Apo.Manc.: SANJUAN MATONSLOURDES. Apo.Sol.: SANJUAN MATONS LOURDES;FERNANDEZ-PICAZO RODRIGUEZ MARIA;CHIQUERO MIELGOVICTOR;BOCOS MARTIN MARIA TERESA;AMILLO TORRANO BEATRIZ;CATON ORDOZGOITI ROCIO. Apo.Manc.: RANDALLCHANDLER MARK. Apo.Sol.: RANDALL CHANDLER MARK. Datos registrales. T 1478 , F 76, S 8, H L 29786, I/A 3 (19.01.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: COLLADO RODRIGUEZ JESUS;JA脩EZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;BOLINSKI PIOTR;ROIGETAMARIT JOSE;CAMPA PARRAMON GLORIA;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA;SANJUAN MATONS LOURDES;NURIABODET GOMEZ;CANALES MILLANES DAVID;MUR MORELLO NURIA;RODES SALA CRISTIAN;PATO-CASTEL TADEO MARIAELENA;GORGUES CARNICE DAVID. Datos registrales. T 1484 , F 204, S 8, H L 29786, I/A 4 (19.01.17).
21 de Noviembre de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.09.16. Objeto social: a) La compraventa, conservaci贸n, fabricaci贸n, transformaci贸n ydistribuci贸n de productos alimenticios, reposter铆a, helader铆a, productos l谩cteos y sus derivados, as铆 como cualquier otra actividadrelacionada directa o indirectamente, con la industrializaci贸n y comercio del ramo de la alimentaci贸n, ya. Domicilio: POLIG CAMI DELSFRARES S/N - CALLE E, ESQ. CALLE K (LLEIDA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:PASTIFICIO SERVICE SL. Nombramientos. Adm. Unico: AMREST SP ZOO. Datos registrales. T 1478 , F 68, S 8, H L 29786, I/A 1(14.11.16).