Buscador CIF Logo

Actos BORME Thermo Ramsey Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Thermo Ramsey Sa

Actos BORME Thermo Ramsey Sa - A28204030

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Thermo Ramsey Sa con CIF A28204030

🔙 Perfil de Thermo Ramsey Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Thermo Ramsey Sa

12 de Junio de 2023
Modificaciones estatutarias. 22.. 25. . Datos registrales. T 27131 , F 170, S 8, H M 36647, I/A 43 ( 5.06.23).

07 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTIN GARRIDO RAQUEL.Reelecciones. Adm. Solid.: VAN DER ZANDE PETRUS THOMAS ADRIANUS. Datos registrales. T 27131 , F 170, S 8, H M 36647,I/A 42 (31.05.21).

04 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: GRAY GILLIAN MARGARET;CAMERON EUAN DANEY ROSS;STROMMER BARBARA;KOCZORMIKLOS. Datos registrales. T 27131 , F 169, S 8, H M 36647, I/A 41 (28.01.21).

26 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: KOCZOR MIKLOS;BABICZ KRISZTINA;STROMMER BARBARA;DE SOUSA CARLOS;SYEDWAQAS;YOUNG MARK. Datos registrales. T 27131 , F 168, S 8, H M 36647, I/A 40 (18.12.19).

Nombramientos. Apoderado: TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL. Datos registrales. T 27131 , F 168, S 8, H M 36647, I/A 39(18.12.19).

12 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: BARROSO RODRIGUEZ ANGEL;DE CARDENAS SMITH CARLOS;PAZ-ARES RODRIGUEZTERESA;ANA SUAREZ CAPEL;PUENTE ARANA SANTIAGO. Datos registrales. T 27131 , F 167, S 8, H M 36647, I/A 38 ( 2.06.17).

13 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: SUAREZ CAPEL ANA. Consejero: BOROWIEC FREDERIQUE;MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS.Presidente: MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Consejero: VAN DER ZANDE PETRUS THOMAS ADRIANUS. Co.De.Ma.So:MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: VAN DER ZANDE PETRUS THOMAS ADRIANUS;MINGUITOBORRALLO JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. eliminar los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de los Estatutos Sociales,- reenumerar los artículos 37 (nuevo 29), 38 (nuevo 30), 39 (nuevo 31), 40 (nuevo 32), 41 (nuevo 33), 42 (nuevo 34), 43 (nuevo 35), 44(nuevo 36) y 45 (nuevo 37) de los Estatutos Sociales. y - modificar los artículos. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Datos registrales. T 27131 , F 166, S 8, H M 36647, I/A 37 (2.12.16).

04 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: ASENSIO LAHUERTA ALBERTO;JIMENEZ MEDINA JOSE LUIS;MINGUEZ RASCON JUAN JOSE;GOMEZJARAS CARLOS;MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ASENSIO LAHUERTA ALBERTO;JIMENEZMEDINA JOSE LUIS;MINGUEZ RASCON JUAN JOSE;GOMEZ JARAS CARLOS;MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 27131 , F 165, S 8, H M 36647, I/A 36 (23.04.15).

03 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOODIE IAIN ALASDAIR KEITH. SecreNoConsj: ASENSIO LAHUERTA ALBERTO.Nombramientos. Secretario: SUAREZ CAPEL ANA. Consejero: BOROWIEC FREDERIQUE. Reelecciones. Consejero: MINGUITOBORRALLO JOSE LUIS. Presidente: MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Consejero: VAN DER ZANDE PETRUS THOMASADRIANUS. Co.De.Ma.So: MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 27131 , F 164, S 8, H M 36647, I/A 35(23.02.15).

11 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apoderado: SABATE GONZALEZ ENRIQUE;DE CARDENAS SMITH PATRICIO;DE CARDENAS GUILLENSANTIAGO;SABATE GONZALEZ ENRIQUE;CORTIÑAS VAZQUEZ MARIA TERESA;DE CARDENAS GUILLEN SANTIAGO;SABATE

14 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: COLEY JAMES ROBERT EWEN. Nombramientos. Consejero: MOODIE IAIN ALASDAIR KEITH.Datos registrales. T 27131 , F 161, S 8, H M 36647, I/A 33 ( 3.01.13).

22 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: VINDEL MAESO ANGEL. Presidente: VINDEL MAESO ANGEL. Consejero: COLEY JAMES ROBERTEWEN;VAN DER ZANDE PETRUS THOMAS ADRIANUS. Revocaciones. Apoderado: VINDEL MAESO ANGEL;MINGUEZ RASCONJUAN JOSE;ASENSIO LAHUERTA ALBERTO. Nombramientos. Consejero: MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Presidente:MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Consejero: COLEY JAMES ROBERT EWEN;VAN DER ZANDE PETRUS THOMAS ADRIANUS.Co.De.Ma.So: MINGUITO BORRALLO JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: JIMENEZ MEDINA JOSE LUIS;MINGUEZ RASCON JUANJOSE;GOMEZ JARAS CARLOS;SABATE GONZALEZ ENRIQUE;ASENSIO LAHUERTA ALBERTO;MARTINEZ MARTINEZANTONIO;BODAS MORALES BERNABE;LINT TORRAU MIGUEL. Reelecciones. SecreNoConsj: ASENSIO LAHUERTA ALBERTO.Datos registrales. T 2060 , F 192, S 8, H M 36647, I/A 32 (12.01.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información