Actos BORME de Thyssenkrupp Airport Services Sl
09 de Mayo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 4068 , F 95, S 8, H AS 35191, I/A 37 (30.04.18).
08 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PFURR ALEXANDER. Presidente: PFURR ALEXANDER. Nombramientos. Presidente: MEDINAALVAREZ IGNACIO. Datos registrales. T 4068 , F 95, S 8, H AS 35191, I/A 36 (27.02.18).
08 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL JOSE. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL JOSE.Nombramientos. Apo.Manc.: S. DE CONINCK PHILIP WILLY. Apo.Sol.: S. DE CONINCK PHILIP WILLY;L.V. DELOBELLE INGE.Apo.Manc.: L.V. DELOBELLE INGE. Datos registrales. T 4068 , F 94, S 8, H AS 35191, I/A 35 (31.01.18).
22 de Diciembre de 2017Nombramientos. Consejero: S. DE CONINCK PHILIP WILLY. Datos registrales. T 4068 , F 93, S 8, H AS 35191, I/A 34 (15.12.17).
30 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: SASTRE VIESCA AIDA. Apo.Sol.: SASTRE VIESCA AIDA. Datos registrales. T 4068 , F 92, S 8, H AS35191, I/A 33 (22.06.17).
15 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ SOLARES VERONICA. Apo.Manc.: GONZALEZ SOLARES VERONICA. Nombramientos.Apo.Sol.: ROBLES GARCIA IGNACIO. Apo.Manc.: ROBLES GARCIA IGNACIO. Datos registrales. T 4068 , F 91, S 8, H AS 35191,I/A 32 ( 7.02.17).
30 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GIESEN BRITTA. Nombramientos. Consejero: MEDINA ALVAREZ IGNACIO. Datos registrales. T4068 , F 90, S 8, H AS 35191, I/A 30 (20.06.16).
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4068 , F 90, S 8, H AS 35191,I/A 31 (20.06.16).
17 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Presidente: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Consejero:KIRNER PETER KLAUS. Nombramientos. Consejero: GIESEN BRITTA. Datos registrales. T 4068 , F 90, S 8, H AS 35191, I/A 28 (9.06.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Apo.Manc.: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Nombramientos.Presidente: PFURR ALEXANDER. Datos registrales. T 4068 , F 90, S 8, H AS 35191, I/A 29 ( 9.06.15).
15 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: ALVAREZ ARIAS DEOTINO. Apo.Sol.: ALVAREZ ARIAS DEOTINO. Datos registrales. T 4068 , F 90, S8, H AS 35191, I/A 27 ( 7.04.15).
22 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL JOSE. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL JOSE.Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL JOSE. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL JOSE.Datos registrales. T 4068 , F 89, S 8, H AS 35191, I/A 26 (10.04.14).
03 de Julio de 2013Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3521 , F 225, S 8, H AS 35191,I/A 25 (24.06.13).
26 de Marzo de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ ALEMANY MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: GONZALEZ ALEMANY MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.:ROCKHOLTZ CARSTEN. Apo.Sol.: ROCKHOLTZ CARSTEN. Apo.Manc.: DE SANTIAGO ALONSO PABLO. Apo.Sol.: DE SANTIAGOALONSO PABLO. Apo.Manc.: MEDINA ALVAREZ IGNACIO. Apo.Sol.: MEDINA ALVAREZ IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.:MEDINA ALVAREZ IGNACIO. Apo.Manc.: MEDINA ALVAREZ IGNACIO. Datos registrales. T 3521 , F 222, S 8, H AS 35191, I/A 24(19.03.13).
31 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCKHOLTZ CARSTEN;GONZALEZ ALEMANY MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero:L.V. DELOBELLE INGE;KIRNER PETER KLAUS. Datos registrales. T 3521 , F 222, S 8, H AS 35191, I/A 23 (22.01.13).
29 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3521 , F 221, S 8, H AS 35191, I/A 22 (17.10.12).
20 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GESSNER TORSTEN GEORG ROBERT. Datos registrales. T 3521 , F 221, S 8, H AS 35191, I/A 21( 8.06.12).
08 de Julio de 2011Reelecciones. Consejero: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Datos registrales. T 3521 , F 220, S 8, H AS 35191, I/A 19(27.06.11).
Revocaciones. Apo.Manc.: ALVARGONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO. Apo.Sol.: ALVARGONZALEZ RODRIGUEZALEJANDRO. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SOLARES VERONICA. Apo.Sol.: GONZALEZ SOLARES VERONICA.Datos registrales. T 3521 , F 220, S 8, H AS 35191, I/A 20 (27.06.11).
06 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: GUILLOT RIGNAULT YVETTE. Apo.Manc.: SESMA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: SESMASANCHEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3521 , F 220, S 8, H AS 35191, I/A 18 (25.08.10).
04 de Mayo de 2010Nombramientos. Consejero: GESSNER TORSTEN GEORG ROBERT. Datos registrales. T 3521 , F 138, S 8, H AS 35191, I/A 17(23.04.10).
26 de Octubre de 2009Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL.Datos registrales. T 3521 , F 138, S 8, H AS 35191, I/A 16 (14.10.09).
08 de Abril de 2009Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. I.- Promoci贸n, construcci贸n porcuenta propia y ajena y compra-venta de toda clase de bienes inmuebles, as铆 como su explotaci贸n, incluyendo urbanizaciones, localesindustriales y obra civil en general. II.- Los servicios de instalaci贸n, manipulaci贸n y mantenimiento de cualquier tipo de estructura me.Datos registrales. T 3521 , F 138, S 8, H AS 35191, I/A 15 (27.03.09).