Buscador CIF Logo

Actos BORME Tim We Servicios De Telecomunicaciones Moviles Y Afines Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tim We Servicios De Telecomunicaciones Moviles Y Afines Sl

Actos BORME Tim We Servicios De Telecomunicaciones Moviles Y Afines Sl - B91656165

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tim We Servicios De Telecomunicaciones Moviles Y Afines Sl con CIF B91656165

馃敊 Perfil de Tim We Servicios De Telecomunicaciones Moviles Y Afines Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tim We Servicios De Telecomunicaciones Moviles Y Afines Sl

22 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Cons.Del.Man: SALVI DIOGO;SALGADO PAULO JORGE PASSOS. Datos registrales. T 33037 , F 164, S 8, H M594730, I/A 9 (15.11.21).

19 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apoderado: FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL;FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL;MARTINHA MARTABRUGNINI DE SOUSA UVA;SANTOS BRUNO MIGUEL FIGUEIREDO SALVADO DOS;MATOS COSTA NUNO JOSE;BARREIROSDO NASCIMENTO JOSE PEDRO;FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL;SANCHA JIMENEZ JUAN CARLOS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: BRUGNINI DE SOUSA UVA MARTINHA MARTA;AHRENS TEXEIRA JOSE MARIA GRACA;CARVALHO SALTAO LUISMIGUEL. Datos registrales. T 33037 , F 163, S 8, H M 594730, I/A 8 (12.08.20).

16 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRAS CALCADO CARVALHO RICARDO MANUEL. Cons.Del.Sol: BRAS CALCADO CARVALHORICARDO MANUEL. Nombramientos. Representan: GUTIERREZ RUEDA ANTONIO JESUS. Consejero: APSE CONSULTANT

29 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ARRABE ASESORES SA. Representan: FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL. Consejero:FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 33037 , F 161, S 8, H M 594730, I/A 6 (22.07.19).

09 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MARTINHA MARTA BRUGNINI DE SOUSA UVA;SANTOS BRUNO MIGUEL FIGUEIREDO SALVADODOS;MATOS COSTA NUNO JOSE;BARREIROS DO NASCIMENTO JOSE PEDRO;FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL;SANCHAJIMENEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 33037 , F 158, S 8, H M 594730, I/A 5 (28.09.18).

Revocaciones. Apoderado: BRUGNINI DE SOUSA UVA MARTINHA MARTA;FIGUEIREDO SALVADO DOS SANTOS BRUNOMIGUEL;VALENCA GONCALVES JOSE ANTONIO;RIBEIRO COSTA MARCO AURELIO;ALMEIDA FERNANDES MENDES CALFRANCISCO MANUEL;DA GLORIA LEITAO JOAO RICARDO;SANCHA JIMENEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 33037 , F160, S 8, H M 594730, I/A 5 (28.09.18).

18 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: BRUGNINI DE SOUSA UVA MARTINHA MARTA;FIGUEIREDO SALVADO DOS SANTOS BRUNOMIGUEL;VALENCA GONCALVES JOSE ANTONIO;RIBEIRO COSTA MARCO AURELIO;ALMEIDA FERNANDES MENDES CALFRANCISCO MANUEL;DA GLORIA LEITAO JOAO RICARDO;SANCHA JIMENEZ JUAN CARLOS;TEXEIRA SALVI DIOGOAHRENS;BRAS CALCADO CARVALHO RICARDO MANUEL;FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 33037 , F157, S 8, H M 594730, I/A 4 ( 8.11.16).

13 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TEIXEIRA SALVI DIOGO AHRENS. Nombramientos. SecreNoConsj: ARRABE ASESORES SA.Consejero: BRAS CALCADO CARVALHO RICARDO MANUEL;TEXEIRA SALVI DIOGO AHRENS;FERRER GARCERAN MIGUELANGEL. Presidente: TEXEIRA SALVI DIOGO AHRENS. Cons.Del.Sol: BRAS CALCADO CARVALHO RICARDO MANUEL;TEXEIRASALVI DIOGO AHRENS. Representan: FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL. Modificaciones estatutarias. DEROGACION YAPROBACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 33037 , F 155, S 8, H M 594730, I/A 3 ( 4.10.16).

04 de Agosto de 2015
Cambio de domicilio social. C/ SEGUNDO MATA 1 1& - OFICINA 3 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 33037 , F155, S 8, H M 594730, I/A 2 (28.07.15).

02 de Julio de 2015
Nombramientos. Apoderado: FERRER GARCERAN MIGUEL ANGEL. Reelecciones. Adm. Unico: TEIXEIRA SALVI DIOGOAHRENS. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 8. Duraci贸n.-. Datos registrales. T 4914 , F 30, S 8, H SE 79146,I/A 2 (23.06.15).

Otros conceptos: Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificaci贸n literal para traslado de domicilio social a Pozuelo de Alarc贸n -MADRID.- Datos registrales. T4914 , F 30, S 8, H SE 79146, I/A 2 t (23.06.15).

19 de Diciembre de 2014
Reapertura hoja registral. Datos registrales. T 4914 , F 29, S 8, H SE 79146, I/A 1 3 (11.12.14).

22 de Mayo de 2013
Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 4914 , F 29, S 8, H SE 79146,I/A 1 b ( 1.12.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n