Actos BORME de Tintas Arzubialde Sl
14 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: FAURA BUSTO ALBERTO. Datos registrales. T 794 , F 95, S 8, H LO 11820, I/A 43 ( 3.11.23).
27 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SANCHEZ GERARDO ANTONIO;GOMEZ SANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 794 ,F 95, S 8, H LO 11820, I/A 41 (16.03.23).
Revocaciones. Apo.Manc.: GAONA RODRIGUEZ JESUS VICTORIANO;GONZALEZ SANCHEZ GERARDO ANTONIO;GOMEZSANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 794 , F 95, S 8, H LO 11820, I/A 42 (16.03.23).
16 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: AUDITING B. G.ASSOCIATES SL. Datos registrales. T 794 , F 94, S 8, H LO 11820, I/A 40 ( 5.01.23).
11 de Abril de 2022Fe de erratas: El administrador único, don LUIS JOVE PONS, fue nombrado para su cargo, el día 30/09/2015, por TIEMPOINDEFINIDO, no por plazo de seis años como por error se publicó. Datos registrales. T 794 , F 94, S 8, H LO 11820, I/A 39 (1.04.22).
28 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: AUDITING B. G.ASSOCIATES SL. Datos registrales. T 794 , F 94, S 8, H LO 11820, I/A 38 (21.10.19).
23 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: MONTON MOLINA CARLOS. Datos registrales. T 794 , F 94, S 8, H LO 11820, I/A 37 ( 4.01.19).
19 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: GAONA RODRIGUEZ JESUS VICTORIANO;GONZALEZ SANCHEZ GERARDO ANTONIO;GOMEZSANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 794 , F 94, S 8, H LO 11820, I/A 36 (12.04.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: FAURA BUSTO ALBERTO;JOVE PONS LUIS. Datos registrales. T 794 , F 93, S 8, H LO 11820, I/A35 (26.02.18).
02 de Junio de 2017Ampliación de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.100.000,00 Euros. Datos registrales. T 794 , F 92, S 8, HLO 11820, I/A 34 (16.05.17).
07 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Auditor: CC AUDTORES SLP. Nombramientos. Auditor: AUDITING B. G.ASSOCIATES SL. Datos registrales.T 794 , F 92, S 8, H LO 11820, I/A 33 (31.03.17).
22 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVACREUS LUONA SLU. Presidente: NAVACREUS LUONA SLU. Consejero: FAURA BUSTOALBERTO. Secretario: FAURA BUSTO ALBERTO. Consejero: ANGERRI CASTELLS PERE. Nombramientos. Adm. Unico: JOVEPONS LUIS. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo VIGESIMO-SEXTO.- El ejercicio social económico de laSociedad es de doce meses, que se contará desde el primero de octubre de cada año al 30 de septiembre del año siguiente.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 794 , F92, S 8, H LO 11820, I/A 32 (14.12.15).
28 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: REDONDO HIERRO GONZALO;REDONDO HIERRO GONZALO;REDONDO HIERROGONZALO;REDONDO HIERRO ALVARO;BECERRA BASTERRECHEA JESUS;GONZALEZ SANCHEZ GERARDOANTONIO;SORIANO CUÑAT AGUSTIN;JIMENEZ LOSANTOS JOSE LUIS;REDONDO HIERRO GONZALO;MONTON MOLINA
31 de Julio de 2015Pérdida del caracter de unipersonalidad. Reducción de capital. Importe reducción: 6.716.285,00 Euros. Resultante Suscrito:27.815,00 Euros. Ampliación de capital. Capital: 972.185,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T698 , F 152, S 8, H LO 11820, I/A 30 (24.07.15).
28 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: JOVE PONS LUIS;MONTON MOLINA CARLOS;FAURA BUSTO ALBERTO. Datos registrales. T 698 , F152, S 8, H LO 11820, I/A 29 (18.05.15).
05 de Marzo de 2015Declaración de unipersonalidad. Socio único: NAVACREUS LUONA SLU. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ECHAVARRILOPEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: REDONDO CORTINA MODESTO;ANEXA CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DEREGIME;SALAFRANCA MIGUEL JOSE IGNACIO. Con.Delegado: ANEXA CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DEREGIME;SALAFRANCA MIGUEL JOSE IGNACIO. Consejero: INTERCHIP SA. Consj. Supl.: REDONDO HIERRO GONZALO.Presidente: ANEXA CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIME. Cons.Del.Sol: INTERCHIP SA. L. Asesor: ECHAVARRILOPEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Auditor: CC AUDTORES SLP. Consejero: NAVACREUS LUONA SLU. Presidente:NAVACREUS LUONA SLU. Consejero: FAURA BUSTO ALBERTO. Secretario: FAURA BUSTO ALBERTO. Consejero: ANGERRICASTELLS PERE. Datos registrales. T 698 , F 151, S 8, H LO 11820, I/A 28 (11.02.15).
27 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE & TOUCHE SA. Datos registrales. T 698 , F 151, S 8, H LO 11820, I/A 27 (17.12.13).
24 de Octubre de 2013Otros conceptos: Sustituido don José María Trueba Cortés por don LORENZO CANO SANCHEZ, como persona física representantede Anexa Capital, Sociedad de Capital Riesgo de RS, SA, en el cargo de consejera, presidente y consejera delegada de la mercantilTINTAS ARZUBIALDE, SL. Datos registrales. T 698 , F 151, S 8, H LO 11820, I/A 26 (15.10.13).
24 de Septiembre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE & TOUCHE SA. Datos registrales. T 698 , F 151, S 8, H LO 11820, I/A 25 (17.09.13).
11 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CASADO VICENTE PEDRO. Secretario: CASADO VICENTE PEDRO. Con.Delegado: CASADOVICENTE PEDRO. Presidente: REDONDO CORTINA MODESTO. VsecrNoConsj: ECHAVARRI LOPEZ FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. SecreNoConsj: ECHAVARRI LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: INTERCHIP SA. ConsejSuplen: REDONDOHIERRO GONZALO. Presidente: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRES. Cons.Del.Sol: INTERCHIPSA. Modificaciones estatutarias. Artículo 25º.- Cuando la administración y representación de la Sociedad se encomiende a unConsejo de Administración, serán de aplicación las siguientes normas de funcionamiento:El Consejo elegirá a su Presidente y alSecretario, y en sucaso, un Vicesecretario siempre que estos nombramientos no. Datos registrales. T 698 , F 149, S 8, H LO 11820,I/A 24 (30.09.11).
25 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: MONTON MOLINA CARLOS. Datos registrales. T 698 , F 149, S 8, H LO 11820, I/A 23 (16.02.11).
22 de Octubre de 2010Nombramientos. L. Asesor: ECHAVARRI LOPEZ JAVIER. VsecrNoConsj: ECHAVARRI LOPEZ JAVIER. Con.Delegado: CAJA DEAHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRES;CASADO VICENTE PEDRO;SALAFRANCA MIGUEL JOSE IGNACIO.Datos registrales. T 698 , F 148, S 8, H LO 11820, I/A 22 (13.10.10).
19 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: IBARRA CUCALON JOSE JOAQUIN. Con.Delegado: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADADESARROLLO EMPRES. Nombramientos. Consejero: SALAFRANCA MIGUEL JOSE IGNACIO. Cambio de objeto social. Suobjeto social es: La fabricación, compra-venta, importación y exportación de tintas, barnices, lacas y demás productos químicos,auxiliares para las Industrias de Artes Gráficas; y pinturas para toda clase de usos. La sociedad podrá desarrollar las actividadesenumeradas bien en modo directo, o b. Datos registrales. T 698 , F 148, S 8, H LO 11820, I/A 20 ( 7.10.10).
Nombramientos. Apoderado: REDONDO HIERRO GONZALO. Datos registrales. T 698 , F 148, S 8, H LO 11820, I/A 21 ( 7.10.10).
11 de Marzo de 2010Nombramientos. Auditor: DELOITTE & TOUCHE SA. Datos registrales. T 698 , F 147, S 8, H LO 11820, I/A 18 ( 2.03.10).
26 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: BECERRA BASTERRECHEA JESUS. Datos registrales. T 698 , F 146, S 8, H LO 11820, I/A 14(14.08.09).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ GERARDO ANTONIO. Datos registrales. T 698 , F 147, S 8, H LO 11820, I/A15 (14.08.09).
Nombramientos. Apoderado: SORIANO CUÑAT AGUSTIN. Datos registrales. T 698 , F 147, S 8, H LO 11820, I/A 16 (14.08.09).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ LOSANTOS JOSE LUIS. Datos registrales. T 698 , F 147, S 8, H LO 11820, I/A 17(14.08.09).
28 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: REDONDO HIERRO GONZALO. Datos registrales. T 698 , F 145, S 8, H LO 11820, I/A 12 (17.07.09).
Revocaciones. Apo.Sol.: REDONDO HIERRO GONZALO. Nombramientos. Apoderado: REDONDO HIERROGONZALO;REDONDO HIERRO ALVARO. Datos registrales. T 698 , F 146, S 8, H LO 11820, I/A 13 (17.07.09).
01 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: REDONDO HIERRO GONZALO. Datos registrales. T 698 , F 145, S 8, H LO 11820, I/A 11 (16.06.09).