Actos BORME de Tirapa Obras Y Promociones Sl
21 de Enero de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.473.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 318.200,00 Euros. Datos registrales. T 36782 ,F 210, S 8, H M 498100, I/A 11 (14.01.19).
12 de Febrero de 2018Ampliacion del objeto social. La adquisici贸n de fincas urbanas y rusticas, edificaciones urbanas, industriales, comerciales, terrenos,su parcelaci贸n y urbanizaci贸n. - La explotaci贸n en forma de venta de fincas urbanas y rusticas, edificaciones urbanas industriales ocomerciales, terrenos, solares para edificar y de fincas rusti. Datos registrales. T 36782 , F 210, S 8, H M 498100, I/A 10 ( 2.02.18).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIERES ROYO JOSE ANTONIO;GOMEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL;ESPA脩A ARBONA JOSEVICENTE. Datos registrales. T 27641 , F 59, S 8, H M 498100, I/A 9 (25.01.18).
07 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 4 - NATEA BUSINESS PARK, EDIF (ALCOBENDAS). Datos registrales. T27641 , F 58, S 8, H M 498100, I/A 8 (27.11.17).
09 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 791.320,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.791.320,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 5潞. Capital social.-. Datos registrales. T 27641 , F 58, S 8, H M 498100, I/A 7 (27.04.17).
24 de Noviembre de 2016Nombramientos. Con.Delegado: GUALLAR URE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 27641 , F 57, S 8, H M 498100, I/A 6(15.11.16).
07 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRANZ JUAN JOSE TOMAS;ORTIZ SORRIBES ELOY;FABREGAT GIL ENRIQUE;GARCIALLIBEROS FERNAUD JAVIER;PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA SANTIAGO;TIMOR GUILLEN FRANCISCO. Secretario: PUIGDE LA BELLACASA ALBEROLA SANTIAGO. Con.Delegado: GUALLAR URE脩A FERNANDO. Nombramientos. Secretario:GUALLAR URE脩A FERNANDO. Reelecciones. Consejero: MIERES ROYO JUAN MANUEL;ESPA脩A ARBONA JOSE VICENTE.Presidente: MIERES ROYO JUAN MANUEL. Consejero: GUALLAR URE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 27641 , F 56, S 8, HM 498100, I/A 5 (28.09.16).
01 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: MIERES ROYO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 27641 , F 55, S 8, H M 498100, I/A 4 (22.05.15).
11 de Abril de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 27641 , F 55, S 8,H M 498100, I/A 3 ( 3.04.14).
04 de Mayo de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Datos registrales. T 27641 , F 54, S 8, HM 498100, I/A 2 (23.04.12).
21 de Abril de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 2.03.10. Objeto social: TOLOS LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON TODO TIPO DECONSTRUCCION Y TEMAS INMOBILIARIAS. Domicilio: C/ GUSTAVO FERNANDEZ BALBUENA 11 (MADRID). Capital: 100.000,00Euros. Nombramientos. Consejero: MIERES ROYO JUAN MANUEL;GUALLAR URE脩A FERNANDO;HERRANZ JUAN JOSETOMAS;ORTIZ SORRIBES ELOY;FABREGAT GIL ENRIQUE;GARCIA LLIBEROS FERNAUD JAVIER;PUIG DE LA BELLACASAALBEROLA SANTIAGO;ESPA脩A ARBONA JOSE VICENTE;TIMOR GUILLEN FRANCISCO. Presidente: MIERES ROYO JUANMANUEL. Secretario: PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA SANTIAGO. Con.Delegado: GUALLAR URE脩A FERNANDO. Datosregistrales. T 27641 , F 50, S 8, H M 498100, I/A 1 ( 9.04.10).