Actos BORME de Tirstrup Pv Ii Sl
30 de Enero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41353 , F 80, S 8, H M 732982, I/A 5 (23.01.23).
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Adm. Unico: SONNEDIX ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 41353 , F 80, S 8, H M 732982, I/A 4 (15.12.22).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE;FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 41353 , F 78, S 8, H M 732982, I/A 3 (26.04.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NORMANN MARC. Nombramientos. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIAMASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA, 108, PLANTA 12 (MADRID). Datosregistrales. T 41353 , F 78, S 8, H M 732982, I/A 2 (25.03.21).
22 de Mayo de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Manc.: GANDIA
14 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: NORMANN MARC. Datosregistrales. T 10391, L 7672, F 171, S 8, H V 178890, I/A 6 ( 7.05.20).
05 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 10391, L 7672, F 171, S 8, H V 178890, I/A 4(26.10.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: KARTES TILLMAN KLAUS WILLY. Apo.Sol.: WICKE RICHARD. Datos registrales. T 10391, L 7672, F171, S 8, H V 178890, I/A 5 (26.10.18).
05 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: WICKE RICHARD. Datos registrales. T 10391, L 7672, F 171, S 8, H V 178890, I/A 3 (29.08.18).
04 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFICINA 305 (ALFAFAR). Datos registrales. T 10391, L 7672, F171, S 8, H V 178890, I/A 2 (27.11.17).
12 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 1139 , F 210, S 8, H L 22587, I/A 14 ( 3.07.17).
10 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1139 , F 210, S 8, H L 22587, I/A 13 ( 3.03.17).
07 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Manc.: WICKERICHARD;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1139 , F 209, S 8, H L 22587, I/A 12 (28.02.17).
28 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GAARNLARSEN LARS CHRISTIAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 1139 , F 209, S 8, H L 22587, I/A 11 (17.06.16).
15 de Julio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: SORIA SORJUS JOSE;YOSHIDA NATALIE;CAJA RUIZ I脩IGO;MESTRE BONCOMPTE BLANCA. Datosregistrales. T 1139 , F 208, S 8, H L 22587, I/A 8 ( 1.07.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1139 , F 208,S 8, H L 22587, I/A 9 ( 3.07.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD. Apo.Manc.: KARTES TILLMAN KLAUS WILLY. Datos registrales. T 1139 , F 209, S8, H L 22587, I/A 10 ( 7.07.15).
01 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 1139 , F 207, S 8, H L 22587, I/A 6(21.07.14).
Nombramientos. Apoderado: NEXUS ENERGIA SA;NEXUS ENERGIA SA. Datos registrales. T 1139 , F 207, S 8, H L 22587, I/A 7(21.07.14).
22 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROARK SOLAR SPAIN I SL. Nombramientos. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARNLARSEN LARS CHRISTIAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios.Se modifica el art. 8潞 de los Estatutos sociales.. Datos registrales. T 1139 , F 206, S 8, H L 22587, I/A 5(12.11.12).