Actos BORME de Tocosa 2007 Corporation Sl
09 de Mayo de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 119, S 8, H CS 37634, I/A 18 (27.04.23).
17 de Junio de 2022Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GLOBAL FRETUM SL. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 118, S 8, H CS 37634,I/A 17 (10.06.22).
24 de Mayo de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el Articulo 24潞 de los estatutos sociales, al modificar la fecha decierre del ejercicio social.. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 118, S 8, H CS 37634, I/A 16 ( 6.05.22).
11 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: TORRES FORNER MARIA;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;TORRES FORNER DAVID. Datosregistrales. T 1675, L 1236, F 118, S 8, H CS 37634, I/A 15 ( 4.03.22).
17 de Febrero de 2022Otros conceptos: ANULACION Y SUPRESION DEL ARTICULO 6潞 DE LOS ESTUTOS SOCIALES,. Datos registrales. T 1675, L1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 12 (10.02.22).
Nombramientos. Apoderado: PALLARES MARIA DIANA. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 13(10.02.22).
Nombramientos. Apoderado: NOLLA VILLALONGA XAVIER. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 14(10.02.22).
20 de Diciembre de 2021Revocaciones. Auditor: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTASAUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 11(13.12.21).
10 de Diciembre de 2021Modificaciones estatutarias. Modificado el Art铆culo 7潞 de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 1675, L 1236, F 114, S 8, HCS 37634, I/A 10 ( 2.12.21).
19 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES FORNER DAVID;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;SALA TORRES MARIAJOSE;TORRES VERDECHO JOSEFINA. Vicepresid.: TORRES FERRER MARIA ASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHOJOSEFINA. Consejero: TORRES CORELL JOSE;TORRES FERRER CRISTIAN. Presidente: TORRES CORELL JOSE.Nombramientos. Adm. Unico: GLOBAL FRETUM SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: CAMBIO DOMICILIO.MOD. ART. 3. MODIFICACION ARTICULO 19潞. MODIFICACION ARTICULO 20. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ PADRE ROQUE MELCHOR S/N(CHILCHES). Datos registrales. T 1675, L 1236, F 114, S 8, H CS 37634, I/A 9 (12.11.21).
08 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES FERRER CRISTIAN;TORRES CORELL JOSE;TORRES FERRER MARIAASUNCION;SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES VERDECHO JOSEFINA. Presidente: TORRES CORELL JOSE. Vicepresid.:TORRES FERRER MARIA ASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHO JOSEFINA. Consejero: TORRES FORNER DAVID.Nombramientos. Consejero: TORRES CORELL JOSE;TORRES VERDECHO JOSEFINA;SALA TORRES MARIA JOSE;TORRESFERRER MARIA ASUNCION;TORRES FORNER DAVID;TORRES FERRER CRISTIAN. Presidente: TORRES CORELL JOSE.Vicepresid.: TORRES FERRER MARIA ASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHO JOSEFINA. Datos registrales. T 1675, L1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 8 ( 2.06.21).
02 de Abril de 2020Reelecciones. Auditor: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 7 (24.03.20).
17 de Mayo de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: AMPLIACION OBJETO. MOD.ART. Cambio de objeto social. Lacompraventa, gesti贸n y administraci贸n de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes enterritorio espa帽ol, mediante la correspondiente organizaci贸n de medios materiales y personales, todo ello con la salvedad de loestablecido en la Ley 35/2003 de 4 de N. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 6 ( 8.05.19).
22 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES CORELL CARLOS. Secretario: TORRES CORELL CARLOS. Vicepresid.: TORRESVERDECHO JOSEFINA. Nombramientos. Consejero: TORRES FERRER CRISTIAN. Vicepresid.: TORRES FERRER MARIAASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHO JOSEFINA. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 5(12.06.17).
09 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 112, S 8, H CS 37634, I/A 4 (28.02.17).
05 de Agosto de 2015Nombramientos. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 112, S 8,H CS 37634, I/A 3 (29.07.15).
07 de Mayo de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO por cambio de domicilio.. Cambio de domicilio social.POLIG INDUSTRIAL AGRICOLA 2 (ALMENARA). Datos registrales. T 1675, L 1236, F 112, S 8, H CS 37634, I/A 2 (29.04.15).
08 de Abril de 2015Revocaciones. CONSEJERO: TORRES CORELL CARLOS. PRESIDENTE: TORRES CORELL CARLOS. CONSEJERO: TORRESCORELL JOSE. VICEPRESIDEN: TORRES CORELL JOSE. CONSEJERO: TORRES VERDECHO JOSEFINA. SECRETARIO:TORRES VERDECHO JOSEFINA. CONSEJERO: SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;TORRESFORNER DAVID. Nombramientos. CONSEJERO: TORRES CORELL CARLOS. SECRETARIO: TORRES CORELL CARLOS.CONSEJERO: TORRES CORELL JOSE. PRESIDENTE: TORRES CORELL JOSE. CONSEJERO: TORRES VERDECHO JOSEFINA.VICEPRESIDEN: TORRES VERDECHO JOSEFINA. CONSEJERO: SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIAASUNCION;TORRES FORNER DAVID. Datos registrales. T 42223 , F 12, S 8, H B 404672, I/A 11 (23.03.15).
22 de Octubre de 2014Revocaciones. APODERADO: LOZANO PUIG CAMIL. Datos registrales. T 42223 , F 12, S 8, H B 404672, I/A 10 (15.10.14).
12 de Agosto de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: TORRES FORNER DAVID;SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIAASUNCION. Datos registrales. T 42223 , F 11, S 8, H B 404672, I/A 9 ( 2.08.13).
07 de Mayo de 2013Nombramientos. APODERADO: LOZANO PUIG CAMIL. Datos registrales. T 42223 , F 11, S 8, H B 404672, I/A 8 (25.04.13).
22 de Abril de 2013Modificaciones estatutarias. ART.22:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 42223 , F 10, S 8, H B 404672, I/A 7 (12.04.13).
27 de Diciembre de 2012Modificaciones estatutarias. ART. 24 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEOCTUBRE Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 42223 , F 10, S 8, H B 404672, I/A 6(19.12.12).
05 de Marzo de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42223 , F 10, S 8, H B404672, I/A 5 (22.02.12).
13 de Septiembre de 2011Modificaciones estatutarias. ART.22:MODIFICACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 42223 , F 10, S 8, H B 404672, I/A 4 (31.08.11).
22 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.493.920,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.533.920,00 Euros. Datos registrales. T 42223 , F 5, S8, H B 404672, I/A 3 ( 9.08.11).
10 de Diciembre de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.11.10. Objeto social: LAS ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA,GESTION YADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES Y NORESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL,SALVO INSTITUCIONES INVERSION COLECTIVA,ETC. Domicilio: CL GRAN VIACORTS CATALANES Num.754 P.PR (BARCELONA). Capital: 40.000,00 Euros. Datos registrales. T 42223 , F 1, S 8, H B 404672,I/A 1 (29.11.10).
Nombramientos. CONSEJERO: TORRES CORELL CARLOS. PRESIDENTE: TORRES CORELL CARLOS. CONSEJERO: TORRESCORELL JOSE. VICEPRESIDEN: TORRES CORELL JOSE. CONSEJERO: TORRES VERDECHO JOSEFINA. SECRETARIO:TORRES VERDECHO JOSEFINA. CONSEJERO: SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;TORRESFORNER DAVID. Datos registrales. T 42223 , F 1, S 8, H B 404672, I/A 1 (29.11.10).
Nombramientos. APODERADO: TORRES FORNER MARIA;SALA TORRES MARIA JOSE. Datos registrales. T 42223 , F 4, S 8, HB 404672, I/A 2 (29.11.10).