Buscador CIF Logo

Actos BORME Tocosa 2007 Corporation Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tocosa 2007 Corporation Sl

Actos BORME Tocosa 2007 Corporation Sl - B65445140

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Castellon para Tocosa 2007 Corporation Sl con CIF B65445140

馃敊 Perfil de Tocosa 2007 Corporation Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Castellon

Actos BORME de Tocosa 2007 Corporation Sl

09 de Mayo de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 119, S 8, H CS 37634, I/A 18 (27.04.23).

17 de Junio de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GLOBAL FRETUM SL. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 118, S 8, H CS 37634,I/A 17 (10.06.22).

24 de Mayo de 2022
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el Articulo 24潞 de los estatutos sociales, al modificar la fecha decierre del ejercicio social.. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 118, S 8, H CS 37634, I/A 16 ( 6.05.22).

11 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: TORRES FORNER MARIA;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;TORRES FORNER DAVID. Datosregistrales. T 1675, L 1236, F 118, S 8, H CS 37634, I/A 15 ( 4.03.22).

17 de Febrero de 2022
Otros conceptos: ANULACION Y SUPRESION DEL ARTICULO 6潞 DE LOS ESTUTOS SOCIALES,. Datos registrales. T 1675, L1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 12 (10.02.22).

Nombramientos. Apoderado: PALLARES MARIA DIANA. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 13(10.02.22).

Nombramientos. Apoderado: NOLLA VILLALONGA XAVIER. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 14(10.02.22).

20 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Auditor: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTASAUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 115, S 8, H CS 37634, I/A 11(13.12.21).

10 de Diciembre de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificado el Art铆culo 7潞 de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 1675, L 1236, F 114, S 8, HCS 37634, I/A 10 ( 2.12.21).

19 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES FORNER DAVID;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;SALA TORRES MARIAJOSE;TORRES VERDECHO JOSEFINA. Vicepresid.: TORRES FERRER MARIA ASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHOJOSEFINA. Consejero: TORRES CORELL JOSE;TORRES FERRER CRISTIAN. Presidente: TORRES CORELL JOSE.Nombramientos. Adm. Unico: GLOBAL FRETUM SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: CAMBIO DOMICILIO.MOD. ART. 3. MODIFICACION ARTICULO 19潞. MODIFICACION ARTICULO 20. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ PADRE ROQUE MELCHOR S/N(CHILCHES). Datos registrales. T 1675, L 1236, F 114, S 8, H CS 37634, I/A 9 (12.11.21).

08 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES FERRER CRISTIAN;TORRES CORELL JOSE;TORRES FERRER MARIAASUNCION;SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES VERDECHO JOSEFINA. Presidente: TORRES CORELL JOSE. Vicepresid.:TORRES FERRER MARIA ASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHO JOSEFINA. Consejero: TORRES FORNER DAVID.Nombramientos. Consejero: TORRES CORELL JOSE;TORRES VERDECHO JOSEFINA;SALA TORRES MARIA JOSE;TORRESFERRER MARIA ASUNCION;TORRES FORNER DAVID;TORRES FERRER CRISTIAN. Presidente: TORRES CORELL JOSE.Vicepresid.: TORRES FERRER MARIA ASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHO JOSEFINA. Datos registrales. T 1675, L1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 8 ( 2.06.21).

02 de Abril de 2020
Reelecciones. Auditor: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 7 (24.03.20).

17 de Mayo de 2019
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: AMPLIACION OBJETO. MOD.ART. Cambio de objeto social. Lacompraventa, gesti贸n y administraci贸n de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes enterritorio espa帽ol, mediante la correspondiente organizaci贸n de medios materiales y personales, todo ello con la salvedad de loestablecido en la Ley 35/2003 de 4 de N. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 6 ( 8.05.19).

22 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES CORELL CARLOS. Secretario: TORRES CORELL CARLOS. Vicepresid.: TORRESVERDECHO JOSEFINA. Nombramientos. Consejero: TORRES FERRER CRISTIAN. Vicepresid.: TORRES FERRER MARIAASUNCION. Secretario: TORRES VERDECHO JOSEFINA. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 5(12.06.17).

09 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTASAUDITORES SLP. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 112, S 8, H CS 37634, I/A 4 (28.02.17).

05 de Agosto de 2015
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1675, L 1236, F 112, S 8,H CS 37634, I/A 3 (29.07.15).

07 de Mayo de 2015
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO por cambio de domicilio.. Cambio de domicilio social.POLIG INDUSTRIAL AGRICOLA 2 (ALMENARA). Datos registrales. T 1675, L 1236, F 112, S 8, H CS 37634, I/A 2 (29.04.15).

08 de Abril de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: TORRES CORELL CARLOS. PRESIDENTE: TORRES CORELL CARLOS. CONSEJERO: TORRESCORELL JOSE. VICEPRESIDEN: TORRES CORELL JOSE. CONSEJERO: TORRES VERDECHO JOSEFINA. SECRETARIO:TORRES VERDECHO JOSEFINA. CONSEJERO: SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;TORRESFORNER DAVID. Nombramientos. CONSEJERO: TORRES CORELL CARLOS. SECRETARIO: TORRES CORELL CARLOS.CONSEJERO: TORRES CORELL JOSE. PRESIDENTE: TORRES CORELL JOSE. CONSEJERO: TORRES VERDECHO JOSEFINA.VICEPRESIDEN: TORRES VERDECHO JOSEFINA. CONSEJERO: SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIAASUNCION;TORRES FORNER DAVID. Datos registrales. T 42223 , F 12, S 8, H B 404672, I/A 11 (23.03.15).

22 de Octubre de 2014
Revocaciones. APODERADO: LOZANO PUIG CAMIL. Datos registrales. T 42223 , F 12, S 8, H B 404672, I/A 10 (15.10.14).

12 de Agosto de 2013
Nombramientos. APODERAD.SOL: TORRES FORNER DAVID;SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIAASUNCION. Datos registrales. T 42223 , F 11, S 8, H B 404672, I/A 9 ( 2.08.13).

07 de Mayo de 2013
Nombramientos. APODERADO: LOZANO PUIG CAMIL. Datos registrales. T 42223 , F 11, S 8, H B 404672, I/A 8 (25.04.13).

22 de Abril de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.22:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 42223 , F 10, S 8, H B 404672, I/A 7 (12.04.13).

27 de Diciembre de 2012
Modificaciones estatutarias. ART. 24 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEOCTUBRE Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 42223 , F 10, S 8, H B 404672, I/A 6(19.12.12).

05 de Marzo de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRINCIPAL 1950 ECONOMISTAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42223 , F 10, S 8, H B404672, I/A 5 (22.02.12).

13 de Septiembre de 2011
Modificaciones estatutarias. ART.22:MODIFICACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 42223 , F 10, S 8, H B 404672, I/A 4 (31.08.11).

22 de Agosto de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.493.920,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.533.920,00 Euros. Datos registrales. T 42223 , F 5, S8, H B 404672, I/A 3 ( 9.08.11).

10 de Diciembre de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.11.10. Objeto social: LAS ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA,GESTION YADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES Y NORESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL,SALVO INSTITUCIONES INVERSION COLECTIVA,ETC. Domicilio: CL GRAN VIACORTS CATALANES Num.754 P.PR (BARCELONA). Capital: 40.000,00 Euros. Datos registrales. T 42223 , F 1, S 8, H B 404672,I/A 1 (29.11.10).

Nombramientos. CONSEJERO: TORRES CORELL CARLOS. PRESIDENTE: TORRES CORELL CARLOS. CONSEJERO: TORRESCORELL JOSE. VICEPRESIDEN: TORRES CORELL JOSE. CONSEJERO: TORRES VERDECHO JOSEFINA. SECRETARIO:TORRES VERDECHO JOSEFINA. CONSEJERO: SALA TORRES MARIA JOSE;TORRES FERRER MARIA ASUNCION;TORRESFORNER DAVID. Datos registrales. T 42223 , F 1, S 8, H B 404672, I/A 1 (29.11.10).

Nombramientos. APODERADO: TORRES FORNER MARIA;SALA TORRES MARIA JOSE. Datos registrales. T 42223 , F 4, S 8, HB 404672, I/A 2 (29.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n