Buscador CIF Logo

Actos BORME Tolsan Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tolsan Sociedad Anonima

Actos BORME Tolsan Sociedad Anonima - A02031789

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Tolsan Sociedad Anonima con CIF A02031789

馃敊 Perfil de Tolsan Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Tolsan Sociedad Anonima

08 de Febrero de 2023
Nombramientos. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Datos registrales. T 976, L 740, F 46, S 8, H AB 919, I/A 19 (31.01.23).

16 de Agosto de 2021
Reelecciones. Presidente: SANCHEZ HERRAEZ RAMON. Cons.Del.Sol: SANCHEZ HERRAEZ RAMON. Consejero: SANCHEZHERRAEZ RAMON. Secretario: SANCHEZ HERRAEZ JESUS. Cons.Del.Sol: SANCHEZ HERRAEZ JESUS. Consejero: SANCHEZHERRAEZ JESUS. Cons.Del.Sol: SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO. Consejero: SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO. Datos registrales.T 976, L 740, F 46, S 8, H AB 919, I/A 18 ( 6.08.21).

24 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: SANCHEZ HERRAEZ RAMON;SANCHEZ HERRAEZ JESUS;SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO.Nombramientos. Cons.Del.Sol: SANCHEZ HERRAEZ RAMON;SANCHEZ HERRAEZ JESUS;SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO.Reelecciones. Consejero: SANCHEZ HERRAEZ RAMON;SANCHEZ HERRAEZ JESUS;SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO.Presidente: SANCHEZ HERRAEZ RAMON. Secretario: SANCHEZ HERRAEZ JESUS. Datos registrales. T 942, L 706, F 158, S 8, HAB 919, I/A 17 (14.10.16).

29 de Febrero de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 223.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 301.500,00 Euros. Otros conceptos:Renumeracion de las acciones de la Sociedad. Datos registrales. T 942, L 706, F 158, S 8, H AB 919, I/A 16 (22.02.16).

08 de Abril de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 525.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 525.000,00 Euros. Fe de erratas: Rectificada lainscripci贸n 13& en cuanto al numero de acciones que integran el total capital social. Datos registrales. T 914, L 678, F 147, S 8, H AB919, I/A 15 ( 1.04.14).

20 de Febrero de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 242.608,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:1.050.000,00 Euros. Desembolsado: 1.050.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.050.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:1.050.000,00 Euros. Datos registrales. T 283, L 47, F 42, S 8, H AB 919, I/A 13 ( 9.02.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PADILLA GOMEZ GERMAN. Cons.Del.Man: PADILLA GOMEZ GERMAN. Datos registrales. T 914,L 678, F 147, S 8, H AB 919, I/A 14 ( 9.02.12).

11 de Octubre de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 60.400,00 Euros. Desembolsado: 60.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 242.608,00 Euros.Resultante Desembolsado: 242.608,00 Euros. Cambio de objeto social. La fabricaci贸n y/o comercializaci贸n al por mayor y menor detoldos, p茅rgolas de madera, techos m贸viles, carpinter铆a de aluminio, mobiliario de jard铆ny terraza, lonas para piscinas, estores, cortinasde interior, dom贸tica, puertas autom谩ticas, persianas, sombrillas, r贸tulos luminosos, arquitectura t. Fusi贸n por absorci贸n.Sociedades absorbidas: PALIUM SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 283, L 47, F 40, S 8, H AB 919, I/A 11 ( 3.10.11).

10 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PADILLA GOMEZ GERMAN;SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO;SANCHEZ HERRAEZJESUS;SANCHEZ HERRAEZ RAMON. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ HERRAEZ RAMON;SANCHEZ HERRAEZJESUS;SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO;PADILLA GOMEZ GERMAN. Presidente: SANCHEZ HERRAEZ RAMON. Secretario:SANCHEZ HERRAEZ JESUS. Cons.Del.Man: SANCHEZ HERRAEZ RAMON;SANCHEZ HERRAEZ JESUS;SANCHEZ HERRAEZANTONIO;PADILLA GOMEZ GERMAN. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 17潞.- La Sociedad estar谩regida y administrada por un Consejo de Administraci贸n, compuesto por un m铆nimo de tres y un m谩ximo de siete miembros. Laorganizaci贸n y funcionamiento del Consejo de Administraci贸n se sujetar谩 a las siguientes reglas: 1. El Consejo de. Datos registrales.T 283, L 47, F 39, S 8, H AB 919, I/A 10 (29.09.11).

16 de Marzo de 2011
Reelecciones. Adm. Solid.: PADILLA GOMEZ GERMAN;SANCHEZ HERRAEZ ANTONIO;SANCHEZ HERRAEZ JESUS;SANCHEZHERRAEZ RAMON. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 43.777,34 Euros. Desembolsado: 43.777,34 Euros. Resultante Suscrito:176.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 176.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 49.985,36 Euros. Desembolsado:49.985,36 Euros. Resultante Suscrito: 182.208,00 Euros. Resultante Desembolsado: 182.208,00 Euros. Datos registrales. T 283, L47, F 38, S 8, H AB 919, I/A 9 ( 7.03.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n