Actos BORME de Tomas Mintegui Uriguen Sociedad Anonima
04 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: RUIZ GARCIA IGNACIO JAVIER;RUIZ GARCIA IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 1244 , F 91, S8, H BI 3477,A , I/ 25 .(28.07.22).
01 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Presidente: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Consejero: DEL RIOGRANDES RAMON. Secretario: DEL RIO GRANDES RAMON. Consejero: MORENO LARA LUIS ALBERTO. Nombramientos.SecreNoConsj: SANCHEZ AMORES YERA. Consejero: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS;CRUZA VIGURI IGNACIO;DEL RIOGRANDES RAMON;MORENO LARA LUIS ALBERTO. Presidente: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1244 , F 91,S 8, H BI 3477,A , I/ 24 .(24.11.21).
31 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ AMORES YERA;RUIZ GARCIA IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 1244 , F 90, S 8, HBI 3477,A , I/ 23 .(19.05.21).
12 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CRUZA VIGURI IGNACIO. Con.Delegado: CRUZA VIGURI IGNACIO. Datos registrales. T 1244 , F90, S 8, H BI 3477,A , I/ 22 .( 3.05.21).
28 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RUIZ GARCIA IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 1244 , F 89, S 8, H BI 3477,A , I/ 21.(20.11.19).
11 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ AMORES YERA. Datos registrales. T 1244 , F 88, S 8, H BI 3477,A , I/ 19 .( 4.07.18).
Revocaciones. Gerente: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1244 , F 89, S 8, H BI 3477,A , I/ 20 .( 4.07.18).
30 de Diciembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 149.997,58 Euros. Desembolsado: 149.997,58 Euros. Resultante Suscrito: 381.130,16 Euros.Resultante Desembolsado: 381.130,16 Euros. Datos registrales. T 1244 , F 87, S 8, H BI 3477,A , I/ 18 .(20.12.16).
18 de Noviembre de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: DEL RIO GRANDES RAMON;SANCHEZ SIMON JOSE LUIS;CRUZAVIGURI IGNACIO MARIA. Secretario: DEL RIO GRANDES RAMON. Presidente: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Con.Delegado:CRUZA VIGURI IGNACIO MARIA. Consejero: MORENO LARA LUIS ALBERTO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ SIMONJOSE LUIS. Presidente: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Consejero: DEL RIO GRANDES RAMON. Secretario: DEL RIO GRANDESRAMON. Consejero: MORENO LARA LUIS ALBERTO;CRUZA VIGURI IGNACIO. Con.Delegado: CRUZA VIGURI IGNACIO.Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 149.997,58 Euros. Desembolsado: 149.997,58 Euros. Resultante Suscrito: 231.132,58 Euros.Resultante Desembolsado: 231.132,58 Euros. Datos registrales. T 1244 , F 86, S 8, H BI 3477,A , I/ 17 .( 5.11.15).
26 de Diciembre de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SCMR TENENCIA TMU SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1244 , F 86, S8, H BI 3477,A , I/ 16 .(12.12.11).
26 de Octubre de 2009Reelecciones. Consejero: CRUZA VIGURI IGNACIO MARIA;DEL RIO GRANDES RAMON;SANCHEZ SIMON JOSE LUIS;MORENOLARA LUIS ALBERTO. Presidente: SANCHEZ SIMON JOSE LUIS. Secretario: DEL RIO GRANDES RAMON. Con.Delegado: CRUZAVIGURI IGNACIO MARIA. Modificaciones estatutarias. Queda modificado el art铆culo 20潞 de los Estatutos Sociales,en cuanto a que