Actos BORME de Tomenider Sl
21 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 566 , F 138, S 8, H LU 19669, I/A 15 (10.11.23).
20 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: DUARTE VASCONCELOS GUIMARAES CILIA JOAO. Nombramientos. Consejero: DOS SANTOSFERNANDES DE OLIVEIRA MARGARIDA RITA. Datos registrales. T 566 , F 138, S 8, H LU 19669, I/A 13 (10.10.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: TEIXEIRA SOARES DE ALMEIDA RUI MANUEL. Nombramientos. Consejero: PEIXOTO VANZELLER FERNANDO. Datos registrales. T 566 , F 138, S 8, H LU 19669, I/A 14 (10.10.23).
09 de Octubre de 2023Otros conceptos: Modificado el poder de la inscripci贸n 4陋 adjunta, por la inscripci贸n 11潞 de la sociedad de esta Hoja, 煤nicamente, enel sentido de incluir el n煤mero NIE vigente de D. Paulo Jorge Francisco Andr茅 como apoderado del Grupo B, siendo el n煤mero de NIEvigente el siguiente: Y7837901K. Datos registrales. T 533 , F 5, S 8, H LU 19669, I/A 11 (29.09.23).
24 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 533 , F 4, S 8, H LU 19669, I/A 10 (17.11.22).
26 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 533 , F 3, S 8, H LU 19669, I/A 9 (19.09.22).
27 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 533 , F 3, S 8, H LU 19669, I/A 8 (14.10.21).
03 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 533 , F 2, S 8, H LU 19669, I/A 7 (25.11.20).
08 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINS VALADA MARIA INES. Nombramientos. Consejero: VIEIRA AGUAS MIGUEL PASCOA.Datos registrales. T 533 , F 2, S 8, H LU 19669, I/A 6 (21.08.20).
24 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINS VALADA MARIA INES. Nombramientos. Apo.Manc.: VIEIRA AGUAS MIGUEL PASCOA.Datos registrales. T 533 , F 2, S 8, H LU 19669, I/A 5 (17.08.20).
21 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORAIS ARAGONEZ PEDRO DANIEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO ANDREPAULO JORGE;MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ REIJA RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS. Datos registrales. T 520 ,F 136, S 8, H LU 19669, I/A 4 ( 9.07.20).
08 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 520 , F 135, S 8, H LU 19669, I/A 3 (30.10.19).
06 de Junio de 2019Fe de erratas: En el BORME de fecha 1 de abril de 2019, se public贸 el nombramiento como presidente de DON AMEIJENDARODRIGUEZ JOSE MARIA, debiendo tenerse por no publicado. Datos registrales. T 520 , F 131, S 8, H LU 19669, I/A 1 (20.03.19).
01 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VERGARA GORKA;SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL;LAVILLA RUBIRACARLOS;ALONSO DURAN ALFONSO. VsecrNoConsj: TATO SUAREZ CARMEN. SecreNoConsj: REGOJO BALBOA PEDROJESUS. Presidente: VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Consejero: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Presidente: AMEIJENDA RODRIGUEZJOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: MESQUITA-SOARES MOUTINHO LUIS MIGUEL;TEIXEIRA SOARES DE ALMEIDA RUIMANUEL;MARTINS VALADA MARIA INES;DUARTE VASCONCELOS GUIMARAES CILIA JOAO. Presidente: MESQUITA-SOARESMOUTINHO LUIS MIGUEL;AMEIJENDA RODRIGUEZ JOSE MARIA. Consejero: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Con.Delegado:MARZAN VAZQUEZ RAFAEL. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL O CEAO, RUA DA INDUSTRIA 94 (LUGO). Datosregistrales. T 520 , F 131, S 8, H LU 19669, I/A 1 (20.03.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ REIJA RAFAEL;MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS;GARCIAVERGARA GORKA;SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL;WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;MORAIS ARAGONEZ PEDRO DANIEL;VAZQUEZ REIJA RAFAEL;VAZQUEZ MARZANCARLOS;CARVALHO DE SOUSA ANDRE;SEQUEIRA DE ALMEIDA DOMINGOS MIGUEL;RODRIGUES MARQUES JONIMARLON;VILAS BOAS GARRIDO EDUARDO MANUEL;ORTEGA CARVALHO JORGE;WIRZ RODRIGUEZ NICOLASALBERTO;MESQUITA-SOARES MOUTINHO LUIS MIGUEL;TEIXEIRA SOARES DE ALMEIDA RUI MANUEL;MARTINS VALADAMARIA INES;DUARTE VASCONCELOS GUIMARAES CILIA JOAO. Datos registrales. T 520 , F 135, S 8, H LU 19669, I/A 2(21.03.19).
13 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CURTO IZQUIERDO ALBERTO. Secretario: SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL. Nombramientos.SecreNoConsj: REGOJO BALBOA PEDRO JESUS. VsecrNoConsj: TATO SUAREZ CARMEN. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero:ALONSO DURAN ALFONSO. Datos registrales. T 33974 , F 112, S 8, H M 611389, I/A 8 ( 2.12.16).
11 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 33974 , F 107, S8, H M 611389, I/A 6 ( 3.05.16).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LAVILLA RUBIRA CARLOS;GARCIA VERGARA GORKA;SANTA-EULALIA YARTEGABRIEL;GANDARIAS GELLER PATRICIO ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Presidente:VAZQUEZ REIJA RAFAEL. Consejero: MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS;GARCIA VERGARAGORKA;CURTO IZQUIERDO ALBERTO;LAVILLA RUBIRA CARLOS;SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL. Secretario: SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL. Modificaciones estatutarias. 1. Modificaci贸n de la redacci贸n de la totalidad de los estatutos sociales,con la excepci贸n del art铆culo 2潞 de los mismos, as铆 como su refundici贸n.- . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 33974 , F 108, S 8, H M 611389, I/A 7 ( 3.05.16).
25 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ REIJA RAFAEL;MARZAN VAZQUEZ RAFAEL;VAZQUEZ MARZAN CARLOS;GARCIAVERGARA GORKA;SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL;WIRZ RODRIGUEZ NICOLAS ALBERTO. Datos registrales. T 33974 , F104, S 8, H M 611389, I/A 3 (15.04.16).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.558.693,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.562.193,00 Euros. Datos registrales. T 33974 , F 106, S8, H M 611389, I/A 4 (15.04.16).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Capital: 637.807,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.200.000,00Euros. Datos registrales. T 33974 , F 106, S 8, H M 611389, I/A 5 (15.04.16).
18 de Enero de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORPFIN CAPITAL FUND IV FCR DE REGIMEN SIMPLIFICAD.Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ATALAYA SEVILLANO MARIA TERESA. Nombramientos. Adm. Solid.: LAVILLA RUBIRACARLOS;GARCIA VERGARA GORKA;SANTA-EULALIA YARTE GABRIEL;GANDARIAS GELLER PATRICIO ALEJANDRO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social.C/ SERRANO 57, PLANTA 5& (MADRID). Cambio de objeto social. La adquisici贸n, trasmisi贸n, gesti贸n y administraci贸n de accioneso participaciones sociales o cualesquiera otros instrumentos financieros representativos de una participaci贸n en los fondos propios deotras sociedades o que otorgan una participaci贸n en los resultados de otras sociedades. Datos registrales. T 33974 , F 104, S 8, H M611389, I/A 2 (11.01.16).
02 de Noviembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.09.15. Objeto social: a.- La compra, venta, alquiler, parcelaci贸n y urbanizaci贸n desolares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificaci贸n de los mismos y a su enajenaci贸n, 铆ntegramente,en forma parcial o en r茅gimen de propiedad horizontal. CNAE 6810. b.- La compra, suscripci贸n, .. Domicilio: C/ ZURBARAN - N潞9,LOCAL DERECHA (MADRID). Capital: 3.500,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MEDITERRANEANSEARCH SL. Nombramientos. Adm. Unico: ATALAYA SEVILLANO MARIA TERESA. Datos registrales. T 33974 , F 103, S 8, H M611389, I/A 1 (26.10.15).