Buscador CIF Logo

Actos BORME Tower Net Infraestructuras Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tower Net Infraestructuras Sl

Actos BORME Tower Net Infraestructuras Sl - B87895801

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tower Net Infraestructuras Sl con CIF B87895801

馃敊 Perfil de Tower Net Infraestructuras Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tower Net Infraestructuras Sl

16 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: BOLA脩A HERRERO MAURICIO;LINDNER MAXIMILIAN;TAULLET FERRANDO EDUARDO;FRAGADIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO;RIVERA PEREZ ANGEL. Datos registrales. T 38556 , F 203, S 8, H M 653586, I/A 18 ( 8.08.23).

24 de Julio de 2023
Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 24 1潞 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 38556 , F 202, S 8, H M 653586,I/A 17 (17.07.23).

21 de Marzo de 2023
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/1. Datos registrales. T 38556 , F 198, S 8, H M 653586, I/A 15(13.03.23).

17 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LOPEZ MU脩OZ JOSE-ANTONIO;LINDNER MAXIMILIAN. Nombramientos. Adm. Mancom.:LOPEZ MU脩OZ JOSE ANTONIO;BOTELLA PEDRAZA ALVARO. Datos registrales. T 38556 , F 198, S 8, H M 653586, I/A 14(10.03.23).

11 de Octubre de 2021
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38556 , F 195, S 8, H M 653586,I/A 12 ( 4.10.21).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Mancom.: LOPEZ MU脩OZJOSE-ANTONIO. Apoderado: LOPEZ MU脩OZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 38556 , F 195, S 8, H M 653586, I/A 13 (4.10.21).

20 de Mayo de 2021
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 259 - D, TOLLE ESPACIO PLN (MADRID). Datos registrales. T 38556 ,F 195, S 8, H M 653586, I/A 11 (13.05.21).

10 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO;RIVERA PEREZ ANGEL;ORTEGA MARTINEZ ANTONIO

09 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apoderado: REYES RAMIREZ LEONARDO. Datos registrales. T 38556 , F 194, S 8, H M 653586, I/A 9 ( 2.10.19).

07 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA MARTINEZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 38556 , F 193, S 8, H M 653586, I/A 8(30.09.19).

27 de Septiembre de 2019
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GUNALTA ITG SL. Datos registrales. T 38556 , F 193, S 8, H M 653586, I/A 7(19.09.19).

17 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: OYA ORTEGA JOSE CARLOS. Presidente: OYA ORTEGA JOSE CARLOS. Consejero: MARTINEZQUIROS BEATRIZ;MONFORTE CONSULTORIA DE TELECOMUNICACIONES SL;INVERSIONES LOCUA SL;SPOTTING BRANDSTECHNOLOGIES SL. Cons.Del.Sol: MONFORTE CONSULTORIA DE TELECOMUNICACIONES SL. SecreNoConsj: BARRIOSMARTOS MARIA TERESA. Representan: OYA ORTEGA JOSE CARLOS;DE LUCAS SANCHEZ MIGUEL;MONFORTE MARIMONJORGE. Nombramientos. Adm. Mancom.: LINDNER MAXIMILIAN;FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO. Apoderado: BOLA脩AHERRERO MAURICIO;LINDNER MAXIMILIAN;TAULLET FERRANDO EDUARDO;FRAGA DIAZ-CHIRON JUANFRANCISCO;RIVERA PEREZ ANGEL;REYES RAMIREZ LEONARDO;ORTEGA MARTINEZ ANTONIO JESUS. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 38556 , F189, S 8, H M 653586, I/A 5 (10.07.19).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA NIETO NUBIOLA PABLO;CABEZUELA GONZALEZ OSCAR;PEREZ-ARDA PRECIOSOPAULA;DE LEYVA MERIDA AMPARO;OLMOS GARCIA MERCEDES. Datos registrales. T 38556 , F 193, S 8, H M 653586, I/A 6(10.07.19).

17 de Abril de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 545.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 582.500,00 Euros. Datos registrales. T 38556 , F 188, S 8,H M 653586, I/A 4 (10.04.19).

10 de Abril de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 37.500,00 Euros. Datos registrales. T 38556 , F 187, S 8, H M653586, I/A 3 ( 3.04.19).

02 de Abril de 2019
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Datos registrales. T 36379 , F149, S 8, H M 653586, I/A 2 (26.03.19).

18 de Octubre de 2017
Nombramientos. Cons.Del.Sol: MONFORTE CONSULTORIA DE TELECOMUNICACIONES SL. Fe de erratas: SE OMITIO PORERROR EN LA INSCRIPCION 1陋 LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE "MONFORTE CONSULTORIA DETELECOMUNICACIONES SL" COMO CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO. Datos registrales. T 36379 , F 141, S 8, H M 653586,I/A 1 (29.09.17).

09 de Octubre de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 31.07.17. Objeto social: El montaje, mantenimiento, explotaci贸n de emplazamientos deradio y troncales de comunicaciones y la prestaci贸n y explotaci贸n de toda clase de servicios de telecomunicaciones.. Domicilio: CMNODE LAS CEUDAS 2 BIS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Capital: 30.000,00 Euros. Nombramientos. Representan: MONFORTEMARIMON JORGE;OYA ORTEGA JOSE CARLOS;DE LUCAS SANCHEZ MIGUEL. SecreNoConsj: BARRIOS MARTOS MARIATERESA. Consejero: OYA ORTEGA JOSE CARLOS. Presidente: OYA ORTEGA JOSE CARLOS. Consejero: MARTINEZ QUIROSBEATRIZ;MONFORTE CONSULTORIA DE TELECOMUNICACIONES SL;INVERSIONES LOCUA SL;SPOTTING BRANDSTECHNOLOGIES SL. Datos registrales. T 36379 , F 141, S 8, H M 653586, I/A 1 (29.09.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n