Buscador CIF Logo

Actos BORME Tpih Iberia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tpih Iberia Sl

Actos BORME Tpih Iberia Sl - B87829230

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tpih Iberia Sl con CIF B87829230

馃敊 Perfil de Tpih Iberia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tpih Iberia Sl

26 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Representan: HERNANDEZ CANUT Y FERNANDEZ ESPA脩A JUAN YAGO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error enla inscripci贸n 16陋 la publicaci贸n del nombramiento de HERNANDEZ CANUT Y FERNANDEZ ESPA脩A JUAN YAGO comorepresentante. Datos registrales. T 36060 , F 68, S 8, H M 647974, I/A 16 ( 3.03.21).

Nombramientos. Representan: BUCH TORRALVA MAXIMO HARTWIG. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 17陋 lapublicaci贸n del nombramiento de BUCH TORRALVA MAXIMO HARTWIG como representante. Datos registrales. T 36060 , F 69, S8, H M 647974, I/A 17 ( 3.03.21).

19 de Mayo de 2023
Cambio de domicilio social. C/ PINAR 7 - 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36060 , F 71, S 8, H M 647974, I/A 20(11.05.23).

10 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Secretario: URRECHA SARRIA I脩IGO. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ DIEZ ISABEL. VsecrNoConsj:SALVADOR ALAMAR LUCIA. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZ ISABEL;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PIRES DOS SANTOSFRANCISCO IPO;SALVADOR ALAMAR LUCIA. Cambio de domicilio social. C/ PINAR 7, 5潞 IZQUIERDA, (MADRID). Datosregistrales. T 36060 , F 68, S 8, H M 647974, I/A 15 ( 3.03.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: REINDERS ARJAN. Nombramientos. Consejero: J Y HERNANDEZ CANUT BUFETE DEABOGADOS SLP. Datos registrales. T 36060 , F 68, S 8, H M 647974, I/A 16 ( 3.03.21).

Ceses/Dimisiones. Presidente: HARDY ROBERT ANDREW. Nombramientos. Consejero: REINDERS ARJAN;LILY ANDBEECHTREE CONSULTING SL. Con.Delegado: LILY AND BEECHTREE CONSULTING SL. Presidente: J Y HERNANDEZ CANUTBUFETE DE ABOGADOS SLP. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 27 de los Estatutos sociales.. Datos

Revocaciones. Apo.Sol.: PARDO BRULL SALVADOR;POLTORAKINA OLGA;GOMEZ-FERRER NAVARRO CLARA;GOMEZ-FERRER NAVARRO CLARA. Apoderado: TAMARIT SERRANO LUCIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ DIEZISABEL;SCHULTZ DOUGLAS;PIRES DOS SANTOS FRANCISCO IPO;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA. Apo.Manc.:HARDY ROBERT ANDREW;SCHULTZ DOUGLAS;REINDERS ARJAN;J Y HERNANDEZ CANUT BUFETE DE ABOGADOSSLP;HARDY ROBERT ANDREW;SCHULTZ DOUGLAS;REINDERS ARJAN;J Y HERNANDEZ CANUT BUFETE DE ABOGADOSSLP;GOMEZ DIEZ ISABEL;SALVADOR ALAMAR LUCIA. Datos registrales. T 36060 , F 70, S 8, H M 647974, I/A 18 ( 3.03.21).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SALVADOR ALAMAR LUCIA. Revocaciones. Apo.Sol.: SALVADOR ALAMAR LUCIA.Apo.Manc.: SALVADOR ALAMAR LUCIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: PELAEZ VARA JULIA. Apo.Man.Soli: PELAEZ VARAJULIA. Apo.Manc.: PELAEZ VARA JULIA;REY HERNANDEZ DIEGO. Apo.Sol.: PELAEZ VARA JULIA;REY HERNANDEZDIEGO;PELAEZ VARA JULIA;REY HERNANDEZ DIEGO. Datos registrales. T 36060 , F 70, S 8, H M 647974, I/A 19 ( 3.03.21).

06 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Auditor: ETL GLOBAL AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 36060 , F 67, S 8, H M 647974, I/A 14(29.10.19).

12 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apoderado: TAMARIT SERRANO LUCIA. Datos registrales. T 36060 , F 67, S 8, H M 647974, I/A 13 ( 5.02.19).

09 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ-FERRER NAVARRO CLARA. Datos registrales. T 36060 , F 65, S 8, H M 647974, I/A 11(27.04.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: BARAJAS DEL ROSAL JAVIER. Datos registrales. T 36060 , F 66, S 8, H M 647974, I/A 12 (27.04.18).

30 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRAY GEORGE CHRISTOPHER. Presidente: GRAY GEORGE CHRISTOPHER. Nombramientos.Consejero: REINDERS ARJAN. Datos registrales. T 36060 , F 64, S 8, H M 647974, I/A 9 (23.04.18).

Nombramientos. Presidente: HARDY ROBERT ANDREW. Datos registrales. T 36060 , F 64, S 8, H M 647974, I/A 10 (23.04.18).

16 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRUSCOTT ANDREW JOHN. Nombramientos. Consejero: HARDY ROBERT ANDREW. Datosregistrales. T 36060 , F 64, S 8, H M 647974, I/A 8 ( 7.11.17).

17 de Julio de 2017
Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 1陋 en cuanto a la redacci贸n de art铆culo 29 de los Estatutos Sociales. Datosregistrales. T 36060 , F 63, S 8, H M 647974, I/A 7 (10.07.17).

15 de Junio de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.05.17. Objeto social: consignacin. Domicilio: C/ GOYA 6 (MADRID). Capital: 3.000,00Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TURIA PORT INVESTMENTS HOLDINGS C.V. Nombramientos.Consejero: GRAY GEORGE CHRISTOPHER;SCHULTZ DOUGLAS;TRUSCOTT ANDREW JOHN. Datos registrales. T 36060 , F 58,S 8, H M 647974, I/A 1 ( 8.06.17).

Nombramientos. Presidente: GRAY GEORGE CHRISTOPHER. Secretario: URRECHA SARRIA I脩IGO. Datos registrales. T 36060, F 61, S 8, H M 647974, I/A 2 ( 8.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: PARDO BRULL SALVADOR. Datos registrales. T 36060 , F 61, S 8, H M 647974, I/A 3 ( 8.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: BARAJAS DEL ROSAL JAVIER. Datos registrales. T 36060 , F 61, S 8, H M 647974, I/A 4 ( 8.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: POLTORAKINA OLGA. Datos registrales. T 36060 , F 62, S 8, H M 647974, I/A 5 ( 8.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ-FERRER NAVARRO CLARA. Datos registrales. T 36060 , F 63, S 8, H M 647974, I/A 6 (8.06.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n