Actos BORME de Tracoesa Transport Sa
31 de Octubre de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 37022 , F 31, S 8, H M 48416, I/A 78 (23.10.18).
29 de Mayo de 2018Otros conceptos: ANEXO AL PROYECTO DE FUSION DE MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SACOMO ABSORBENTE Y SCANWELL LOGISTICS SPAIN SL , SCANWELL LOGISTICS PAMPLONA SA Y TRACOESA TRANSPORTSA, COMO ABSORBIDAS. Datos registrales. T 2811 , F 34, S 8, H M 48416, I/A 1-M (21.05.18).
24 de Mayo de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SA.Datos registrales. T 37022 , F 30, S 8, H M 48416, I/A 77 (14.05.18).
04 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: DELGADO PARRA FRANCISCO;CABEZA RIVAS FRANCISCO;DELGADO PARRA FRANCISCO. Datosregistrales. T 37022 , F 30, S 8, H M 48416, I/A 76 (23.03.18).
06 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ MAURA GARCIA ALVARO. Nombramientos. Representan: FERRER MU脩OZ-SECAJAVIER. Datos registrales. T 37022 , F 30, S 8, H M 48416, I/A 75 (26.02.18).
07 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: CERVERA GARNICA RAMIRO. Adm. Unico: MARITIMA DEL ESTRECHO SA. Nombramientos.Representan: PEREZ MAURA GARCIA ALVARO. Adm. Unico: MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SA.Datos registrales. T 30209 , F 168, S 8, H M 48416, I/A 74 (26.01.18).
23 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: BOU GIL JOSE ANTONIO;DELGADO PARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 30209 , F 168, S 8,H M 48416, I/A 73 (15.02.17).
10 de Febrero de 2017Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 48 (COSLADA). Datos registrales. T 30209 , F 168, S 8, H M 48416, I/A 72( 2.02.17).
10 de Octubre de 2016Revocaciones. Apoderado: CABEZA BALENZATEGUI CAROLINA. Datos registrales. T 30209 , F 167, S 8, H M 48416, I/A 71(29.09.16).
09 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MU脩OZ MARIA. Datos registrales. T 30209 , F 167, S 8, H M 48416, I/A 70 (29.01.16).
29 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30209 , F 167, S 8, H M 48416, I/A 69 (18.12.15).
16 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: LARA NAVARRO JORDI. Datos registrales. T 30209 , F 166, S 8, H M 48416, I/A 67 ( 8.04.15).
Revocaciones. Apoderado: GRANDAS VERGARA GINES. Datos registrales. T 30209 , F 167, S 8, H M 48416, I/A 68 ( 8.04.15).
17 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30209 , F 166, S 8, H M 48416, I/A 66 (10.12.14).
17 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30209 , F 165, S 8, H M 48416, I/A 65 ( 8.09.14).
14 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30209 , F 165, S 8, H M 48416, I/A 64 ( 5.08.14).
24 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: BOU GIL JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30209 , F 165, S 8, H M 48416, I/A 63 (15.04.14).
08 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: CABEZA RIVAS FRANCISCO. Datos registrales. T 30209 , F 164, S 8, H M 48416, I/A 62 ( 1.04.14).
23 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: CIA GARCIA DOMINGO. Datos registrales. T 30209 , F 163, S 8, H M 48416, I/A 61 (16.12.13).
24 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: SAEZ GAITAN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 30209 , F 163, S 8, H M 48416, I/A 60(17.10.13).
20 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA VILLALBA CARLOS;MONTESINOS ZAMORANO ADELA. Datos registrales. T 30209 , F163, S 8, H M 48416, I/A 59 ( 9.08.13).
19 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: ESTACIO JIMENEZ MIGUEL. Apo.Sol.: MORENO BRIBIAN IGNACIO RAMON. Apoderado: PUEBLAARRIBAS GABRIEL. Datos registrales. T 30209 , F 163, S 8, H M 48416, I/A 58 (12.04.13).
22 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: ESTACIO JIMENEZ MIGUEL;MORENO LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 30209 , F 162, S 8, H M48416, I/A 57 (14.02.13).
20 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: CIA GARCIA DOMINGO. Datos registrales. T 30209 , F 162, S 8, H M 48416, I/A 56 (13.02.13).
01 de Febrero de 2013Otros conceptos: NO VIGENCIA DE ASIENTO EN RELACION A LA SOCIEDAD "TRACOESA BARCELONA SL". Datosregistrales. T 17995 , F 224, S 8, H M 48416, I/A 54-M (23.01.13).
Nombramientos. Apoderado: CABEZA BALENZATEGUI CAROLINA. Datos registrales. T 30209 , F 162, S 8, H M 48416, I/A 55(25.01.13).
09 de Enero de 2013Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TRACOESA BARCELONA SL. Datos registrales. T 17995 , F 224, S 8, H M 48416,I/A 54 (28.12.12).
24 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: ESPINOSA ADAMEZ VICENTE;MORENO BRIBIAN IGNACIO;PUEBLA ARRIBAS GABRIEL;ESTACIOJIMENEZ MIGUEL;MORENO LOPEZ PABLO. Apo.Sol.: CERVERA GARNICA RAMIRO. Apo.Man.Soli: MORENO BRIBIAN IGNACIORAMON. Datos registrales. T 17995 , F 224, S 8, H M 48416, I/A 53 (13.08.12).
06 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: PEREDA FERNANDEZ ROLANDO;SUAREZ MARTINEZ CRISTINA. Datos registrales. T 17995 , F224, S 8, H M 48416, I/A 52 (26.07.12).
20 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: GRANDAS VERGARA GINES. Datos registrales. T 17995 , F 223, S 8, H M 48416, I/A 51 (11.06.12).
29 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: DELGADO PARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 17995 , F 223, S 8, H M 48416, I/A 50(12.03.12).
14 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: CHOVA FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA;POZO MORENO YOLANDA. Datos registrales. T 17995 ,F 222, S 8, H M 48416, I/A 49 ( 2.03.12).
12 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: PEREDA FERNANDEZ ROLANDO;SUAREZ MARTINEZ CRISTINA. Datos registrales. T 17995 , F222, S 8, H M 48416, I/A 48 (28.02.12).
23 de Diciembre de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MARITIMA DEL ESTRECHO SA. Datos registrales. T 17995 , F 222, S 8, H M48416, I/A 47 ( 7.12.11).
10 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: MORENO LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 17995 , F 221, S 8, H M 48416, I/A 46 (27.10.11).
07 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: FRAILE BARTOLOME GREGORIO. Consejero: CERVERA PEREZ RAMIRO;CABEZA RIVASFRANCISCO. Presidente: CERVERA PEREZ RAMIRO. Con.Delegado: CABEZA RIVAS FRANCISCO. Consejero: CERVERA
26 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO BRIBIAN IGNACIO RAMON. Nombramientos. Presidente: CERVERA PEREZ RAMIRO.Con.Delegado: CABEZA RIVAS FRANCISCO. Consejero: CERVERA GARNICA RAMIRO. Apoderado: CERVERA GARNICARAMIRO. Reelecciones. Consejero: CERVERA PEREZ RAMIRO;CABEZA RIVAS FRANCISCO. Datos registrales. T 17995 , F219, S 8, H M 48416, I/A 44 (14.10.11).
08 de Abril de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17995 , F 219, S 8, H M 48416, I/A 43 (26.03.10).
18 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17995 , F 218, S 8, H M 48416, I/A 42 ( 8.03.10).
02 de Febrero de 2010Otros conceptos: EMISION DE TITULOS MULTIPLES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN ELCAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T 17995 , F 46, S 8, H M 48416, I/A 31/M (22.01.10).
11 de Diciembre de 2009Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 17995 , F218, S 8, H M 48416, I/A 41 (30.11.09).