Buscador CIF Logo

Actos BORME Tradicarne Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tradicarne Sociedad Limitada

Actos BORME Tradicarne Sociedad Limitada - B40228348

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Segovia para Tradicarne Sociedad Limitada con CIF B40228348

馃敊 Perfil de Tradicarne Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Segovia

Actos BORME de Tradicarne Sociedad Limitada

03 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AVIGASE AVICOLA GANADERA SEGOVIANA SCL. Nombramientos. Liquidador: AVIGASEAVICOLA GANADERA SEGOVIANA SCL. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 250 , F 113, S 8, H SG 5299, I/A19 (23.08.19).

21 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: CARNICERO BUJARRABAL FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: SEGOVIA ADANERO MANUEL ANTONIO.Datos registrales. T 250 , F 113, S 8, H SG 5299, I/A 18 (14.11.16).

03 de Marzo de 2016
Nombramientos. Auditor: CARNICERO BUJARRABAL, FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: SEGOVIA ADANERO, MANUELANTONIO. Datos registrales. T 250 , F 112, S 8, H SG 5299, I/A 17 (25.02.16).

21 de Octubre de 2015
Reelecciones. Adm. Unico: AVIGASE,AVICOLA GANADERA SEGOVIANA SCL. Datos registrales. T 250 , F 112, S 8, H SG 5299,I/A 16 ( 7.10.15).

14 de Octubre de 2014
Nombramientos. Auditor: CARNICERO BUJARRABAL, FRANCISCO JAVIER;SEGOVIA ADANERO, MANUEL ANTONIO. Datosregistrales. T 250 , F 112, S 8, H SG 5299, I/A 15 ( 7.10.14).

31 de Julio de 2013
Nombramientos. Auditor: CARNICERO BUJARRABAL, FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: SEGOVIA ADANERO, MANUELANTONIO. Datos registrales. T 250 , F 112, S 8, H SG 5299, I/A 14 (22.07.13).

29 de Julio de 2013
Nombramientos. Auditor: CARNICERO BUJARRABAL, FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: SEGOVIA ADANERO, MANUELANTONIO. Datos registrales. T 250 , F 112, S 8, H SG 5299, I/A 13 (22.07.13).

19 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORENTE PARAMIO VICENTE;BERNABE MARTIN JOSE MARIA;OLTRA MARTINEZ JESUSANTONIO;PALOMO GIL LUIS FERNANDO;ARAGONESES FUENTES JESUS MARIA;MARTIN SANZ LORENZO;GOMEZ LAGUNAGONZALO;MARTIN SANCHEZ SEGUNDO. Presidente: LLORENTE PARAMIO VICENTE. Vicepresid.: BERNABE MARTIN JOSEMARIA. Secretario: OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: AVIGASE AVICOLA GANADERASEGOVIANA SCL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador煤nico. Datos registrales. T 250 , F 111, S 8, H SG 5299, I/A 12 (10.05.11).

24 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA. Datos registrales. T 250 , F 111, S 8, HSG 5299, I/A 11 (15.03.11).

29 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO;LLORENTE PARAMIO VICENTE;BERNABE MARTIN JOSEMARIA;GOMEZ LAGUNA GONZALO;MON AMPUDIA JORGE. Datos registrales. T 250 , F 111, S 8, H SG 5299, I/A 10 (16.12.10).

15 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: MATEOS AMANN MARCOS;OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO;LLORENTE PARAMIOVICENTE;BERNABE MARTIN JOSE MARIA;GOMEZ LAGUNA GONZALO. Datos registrales. T 250 , F 110, S 8, H SG 5299, I/A 9 (5.10.10).

06 de Septiembre de 2010
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 20脫.- Toda Junta General deber谩 ser convocada mediante anuncio publicado en uno o dosdiarios de circulaci贸n en el t茅rmino municipal en el que 茅ste situado el domicilio social. Entre la convocatoria y la fecha prevista para lacelebraci贸n de la reuni贸n deber谩 existir un plazo de, al menos,. Datos registrales. T 250 , F 110, S 8, H SG 5299, I/A 8 (26.08.10).

26 de Octubre de 2009
Nombramientos. Aud.Supl.: SEGOVIA ADANERO MANUEL ANTONIO. Auditor: CARNICERO BUJARRABAL FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 250 , F 110, S 8, H SG 5299, I/A 7 (15.10.09).

29 de Junio de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.701.993,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.635.093,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: TRADICION CASTILLA SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 238 , F 164, S 8, H SG 5299, I/A 6 (16.06.09).

22 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO;MATEOS AMANN MARCOS;ARTALEJO ROLDAN JAVIERALFREDO.Presidente: OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO. Secretario: ARTALEJO ROLDAN JAVIER ALFREDO. Nombramientos.Consejero: LLORENTE PARAMIO VICENTE;BERNABE MARTIN JOSE MARIA;OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO;PALOMO GILLUIS FERNANDO;ARAGONESES FUENTES JESUS MARIA;MARTIN SANZ LORENZO;GOMEZ LAGUNA GONZALO;MARTINSANCHEZ SEGUNDO;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA. Presidente: LLORENTE PARAMIO VICENTE.Vicepresid.: BERNABE MARTIN JOSE MARIA. Secretario: OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO. Datos registrales. T 238 , F 163, S8, H SG 5299, I/A 4 (10.06.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: MATEOS AMANN MARCOS;OLTRA MARTINEZ JESUS ANTONIO;LLORENTE PARAMIOVICENTE;BERNABE MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 238 , F 163, S 8, H SG 5299, I/A 5 (10.06.09).

20 de Enero de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 930.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 933.100,00 Euros. Datos registrales. T 238 , F 162, S 8, HSG 5299, I/A 3 ( 9.01.09).

07 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ GUTIERREZ GREGORIO. Datos registrales. T 238 , F 162, S 8, H SG 5299, I/A 2(23.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n