Actos BORME de Tradilo Inversiones Sociedad Limitada
30 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 1019, L 783, F 189, S 8,H AB 9505, I/A 55 (22.11.23).
19 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO ACACIO JUAN MARCOS;CANO ESPEJO JESUS;ROLDAN PASTOR FERNANDO. Datosregistrales. T 1019, L 783, F 189, S 8, H AB 9505, I/A 54 (12.07.23).
04 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN DOMINGO MARCOS. Nombramientos. Consejero: LENBE INVERSIONES SOCIEDADLIMITADA. Otros conceptos: MARTIN DOMINGO, MARCOS, ha sido nombrado representante de la sociedad LENBEINVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA que a su vez es Consejero de la sociedad TRADILO INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 1019, L 783, F 188, S 8, H AB 9505, I/A 53 (28.03.23).
30 de Diciembre de 2021Ampliación de capital. Capital: 3.600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.260.000,00 Euros. Datos registrales. T 1019, L 783, F188, S 8, H AB 9505, I/A 52 (23.12.21).
14 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: SEGOVIA MARTINEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1019, L 783, F 188, S 8, H AB 9505, I/A51 ( 7.04.21).
12 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: HERGUETA ORTEGA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1019, L 783, F 187, S 8, H AB 9505, I/A49 ( 5.04.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: ESCRIBANO CARO MARIA DEL PILAR. Otros conceptos: Revocado el poder otorgado a favor de DonJuan Diaz Gualda, en escritura autorizada el día 30 de Septiembre de 2.014, ante el Notario de Villarrobledo, Doña RuperezParacuellos, María Esther, número 1.013 de protocolo. Datos registrales. T 1019, L 783, F 188, S 8, H AB 9505, I/A 50 ( 5.04.21).
07 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ LOPEZ VICENTA;CANO ESPEJO JESUS;LABORDA CAMACHO JOSEANTONIO;FERNANDEZ MOLINA MIGUEL ANGEL;HERGUETA ORTEGA JOSE ANTONIO;CUEVAS ALBARES MARIA LORETO.Otros conceptos: REVOCADOS los poderes otorgados a favor de Don Marcos López Castillo, Jesus Camacho Fernández, AntonioContreras Almendros, Caridad Montero Ruiz, Juan Molina Cabrera y María Loreto Cuevas Albares, en escritura otorgada el día 2 deJulio de 2.007, ante el Notario Don Ramirez López, José Manuel, número 1030 de protocolo. Datos registrales. T 1019, L 783, F 187,S 8, H AB 9505, I/A 48 (29.03.21).
17 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 1019, L 783, F 187, S8, H AB 9505, I/A 47 (10.11.20).
10 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: MARTIN OLMOS FEDERICO. Datos registrales. T 1019, L 783, F 187, S 8, H AB 9505, I/A 46(30.10.20).
27 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO ACACIO NATALIA;MARTIN FERRIOL ANTONIO;MONTERO RUIZ MARCOS.Con.Delegado: MONTERO ACACIO ANTONIO. Consejero: MONTERO ACACIO ANTONIO. Presidente: MARTIN OLMOS FEDERICO.Consejero: MARTIN OLMOS FEDERICO;MARTIN SANCHO FEDERICO. Nombramientos. Consejero: MONTERO RUIZMARCOS;MONTERO ACACIO ANTONIO;MARTIN FERRIOL ANTONIO;MONTERO ACACIO NATALIA;MONTERO ACACIO JUANMARCOS;MARTIN SANCHO FEDERICO;MARTIN SANCHO MARIA;MARTIN DOMINGO MARCOS. Presidente: MONTERO RUIZMARCOS. Con.Delegado: MONTERO ACACIO ANTONIO. Reelecciones. SecreNoConsj: CUEVAS ALBARES MARIA LORETO.Datos registrales. T 992, L 756, F 176, S 8, H AB 9505, I/A 44 (20.07.20).
Ampliación de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.660.000,00 Euros. Datos registrales. T 992, L 756, F 176,S 8, H AB 9505, I/A 45 (20.07.20).
21 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PESCADOR FEDERICO. Nombramientos. Consejero: MARTIN SANCHO FEDERICO.Datos registrales. T 992, L 756, F 176, S 8, H AB 9505, I/A 43 (13.08.19).
07 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: CANO ESPEJO JESUS. Datos registrales. T 992, L 756, F 176, S 8, H AB 9505, I/A 42 (30.05.18).
04 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MOLINA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 988, L 752, F 195, S 8, H AB 9505, I/A41 (26.03.18).
13 de Diciembre de 2017Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 981, L 745, F134, S 8, H AB 9505, I/A 39 ( 4.12.17).
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 988, L 752, F 195, S 8, H AB 9505, I/A 40( 4.12.17).
06 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: MONTERO ACACIO JUAN MARCOS. Datos registrales. T 981, L 745, F 134, S 8, H AB 9505, I/A 38(28.09.17).
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 980, L 744, F84, S 8, H AB 9505, I/A 37 (17.03.17).
02 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTIN OLMOS FEDERICO. Datos registrales. T 980, L 744, F 84, S 8, H AB 9505, I/A 36(23.02.17).
21 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: LOPEZ NIEVES ARGIMIRO. Datos registrales. T 960, L 724, F 42, S 8, H AB 9505, I/A 34 (14.02.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN FERRIOL ANTONIO. Datos registrales. T 980, L 744, F 84, S 8, H AB 9505, I/A 35 (14.02.17).
20 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: SEGOVIA MARTINEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 960, L 724, F 42, S 8, H AB 9505, I/A32 (13.07.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ GUALDA JUAN. Datos registrales. T 960, L 724, F 42, S 8, H AB 9505, I/A 33 (13.07.16).
06 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: PEGO BOVE ALBERT. Datos registrales. T 960, L 724, F 42, S 8, H AB 9505, I/A 31 (30.10.15).
28 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PESCADOR FEDERICO. Presidente: MARTIN PESCADOR FEDERICO. Consejero:MONTERO RUIZ MARCOS;MONTERO ACACIO ANTONIO;MONTERO ACACIO ANTONIO;MARTIN OLMOS FEDERICO;MARTINFERRIOL ANTONIO;MONTERO ACACIO NATALIA. Cons.Del.Sol: MARTIN OLMOS FEDERICO;MONTERO RUIZ MARCOS.Vicepresid.: MONTERO RUIZ MARCOS. Vicesecret.: MARTIN OLMOS FEDERICO. Nombramientos. Consejero: MARTIN OLMOSFEDERICO;MONTERO ACACIO ANTONIO;MARTIN PESCADOR FEDERICO;MONTERO RUIZ MARCOS;MARTIN FERRIOLANTONIO;MONTERO ACACIO NATALIA. Presidente: MARTIN OLMOS FEDERICO. Con.Delegado: MONTERO ACACIO ANTONIO.Reelecciones. SecreNoConsj: CUEVAS ALBARES MARIA LORETO. Datos registrales. T 900, L 664, F 187, S 8, H AB 9505, I/A 30(21.09.15).
21 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ GUALDA JUAN;ESCRIBANO CARO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 900, L 664, F 187, S8, H AB 9505, I/A 29 (15.10.14).
15 de Octubre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ CASTILLO MARCOS;CAMACHO FERNANDEZ JESUS;MOLINA CABRERA JUAN. Datosregistrales. T 900, L 664, F 187, S 8, H AB 9505, I/A 28 ( 8.10.14).
08 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CASTILLO MARCOS. Datos registrales. T 900, L 664, F 187, S 8, H AB 9505, I/A 27 ( 2.08.13).
20 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: MONTERO ACACIO ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: CUEVAS ALBARES MARIALORETO. Datos registrales. T 900, L 664, F 187, S 8, H AB 9505, I/A 26 (13.02.13).
10 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: CONTRERAS ALMENDROS ANTONIO;MONTERO RUIZ CARIDAD;CUEVAS ALBARES MARIA LORETO.Datos registrales. T 852, L 616, F 70, S 8, H AB 9505, I/A 25 (29.10.10).
29 de Enero de 2010Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9º.- Corresponde al Consejo de Administración la representación de la Sociedad, en juicioy fuera de él, con plena capacidad para obligarse y con todas las facultades deadministración y disposición sobre toda clase de bienes,sin más limitaciones que los casos expresamente reservados a la. Datos registrales. T 852, L 616, F 70, S 8, H AB 9505, I/A 24(20.01.10).