Buscador CIF Logo

Actos BORME Trafico Ingenieria Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Trafico Ingenieria Sa

Actos BORME Trafico Ingenieria Sa - A33088758

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Trafico Ingenieria Sa con CIF A33088758

🔙 Perfil de Trafico Ingenieria Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Trafico Ingenieria Sa

18 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Presidente: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO.Nombramientos. Consejero: IMMELE ROBERT SYLVAIN. Presidente: IMMELE ROBERT SYLVAIN. Datos registrales. T 3842 , F116, S 8, H AS 7218, I/A 74 ( 9.09.14).

10 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA;FERNANDEZ MATEO LUIS. Datos registrales. T 3842 , F 115,S 8, H AS 7218, I/A 73 (28.02.14).

28 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: DOMENECH MONTES HELENA. Datos registrales. T 3842 , F 115, S 8, H AS 7218, I/A 72 (19.08.13).

04 de Junio de 2013
Declaración de unipersonalidad. Socio único: TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA. Datos registrales. T 3842 , F 115, S 8,H AS 7218, I/A 71 (27.05.13).

14 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: OLANO RUIPEREZ LETICIA. Datos registrales. T 3842 , F 115, S 8, H AS 7218, I/A 70 ( 3.12.12).

30 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CANSECO MARTA. Datos registrales. T 3842 , F 114, S 8, H AS 7218, I/A 69 (19.11.12).

09 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: DE LAS CUEVAS TERAN FERNANDO;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;JIMENEZ-VELASCOMAZARIO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ FALCON AMANDO. Apo.Sol.: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Apo.Manc.: DELBARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO;ESCRIBA GALLEGO ALFREDO. Apo.Sol.: ESCRIBA GALLEGO ALFREDO. Apo.Manc.: VALERORODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Sol.: VALERO RODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Manc.: ZUBIRIA FUREST BARBARA SOFIA. Apo.Sol.:ZUBIRIA FUREST BARBARA SOFIA;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO. Apo.Manc.: SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO.Apo.Sol.: LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER;GIL MATA JAVIER.Apo.Sol.: GIL MATA JAVIER;GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO;MARTINEZJURADO LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Apo.Sol.:FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T 3842 , F 114, S 8, H AS 7218, I/A 68 (27.09.12).

27 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Apo.Manc.: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Apo.Sol.:ESCRIBA GALLEGO ALFREDO. Apo.Manc.: ESCRIBA GALLEGO ALFREDO. Apo.Sol.: VALERO RODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Manc.:VALERO RODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Sol.: MARTINEZ TAUS PABLO. Apo.Manc.: MARTINEZ TAUS PABLO. Apo.Sol.: SAAVEDRAOBERMANN FERNANDO. Apo.Manc.: SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO. Apo.Sol.: GARCIA JIMENEZ MARTA. Apo.Manc.:GARCIA JIMENEZ MARTA. Apo.Sol.: GIL MATA JAVIER. Apo.Manc.: GIL MATA JAVIER. Apo.Sol.: GONZALEZ DOMINGUEZIGNACIO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO. Apo.Sol.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MAZAMANUEL. Apo.Sol.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 3842, F 113, S 8, H AS 7218, I/A 67 (16.04.12).

13 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTOYA PEREZ JOSE. Presidente: MONTOYA PEREZ JOSE. Nombramientos. Consejero:ESCRIBA GALLEGO ALFREDO. Presidente: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Reelecciones. Secretario: GARCIA PAEZLIDIA. Consejero: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO;RIVAS VAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3842 , F 113, S 8,H AS 7218, I/A 65 ( 2.03.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: MONTOYA PEREZ JOSE. Datos registrales. T 3842 , F 113, S 8, H AS 7218, I/A 66 ( 2.03.12).

26 de Octubre de 2011
Reelecciones. Consejero: MONTOYA PEREZ JOSE;DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO;RIVAS VAL FRANCISCO JAVIER.Presidente: MONTOYA PEREZ JOSE. Secretario: GARCIA PAEZ LIDIA. Datos registrales. T 3842 , F 112, S 8, H AS 7218, I/A 64(14.10.11).

15 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: BAGO SOTILLO RAFAEL ANGEL. Apo.Sol.: MONTOYA PEREZ JOSE. Apo.Manc.: MONTOYA PEREZJOSE. Apo.Sol.: FLORES CANALES JOSE MARIA. Apo.Manc.: FLORES CANALES JOSE MARIA. Apo.Sol.: VALERO RODRIGUEZADRIAN. Apo.Manc.: VALERO RODRIGUEZ ADRIAN;AGUERA INFANTE RAUL. Apo.Sol.: AGUERA INFANTE RAUL. Apo.Manc.:SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO. Apo.Sol.: SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER.Apo.Manc.: LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: GIL CREGO CESAR. Apo.Manc.: GIL CREGO CESAR. Apo.Sol.:SANCHEZ ORTEGA MANUEL. Apo.Manc.: SANCHEZ ORTEGA MANUEL;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: MARTINEZJURADO LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T3842 , F 112, S 8, H AS 7218, I/A 63 (29.10.10).

08 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: ESCRIBA GALLEGO ALFREDO. Datos registrales. T 3544 , F 180, S 8, H AS 7218, I/A 62 (27.09.10).

06 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3544 , F 178, S 8, H AS 7218, I/A 61(25.08.10).

20 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO;ESCRIBA GALLEGO ALFREDO;VALERO RODRIGUEZADRIAN;ZUBIRIA FUREST BARBARA SOFIA;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER;GILMATA JAVIER;GONZALEZ DOMINGUEZ IGNACIO;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZA MANUEL. Apo.Manc.:DEL BARRIO GOMEZ JOSE IGNACIO;ESCRIBA GALLEGO ALFREDO;VALERO RODRIGUEZ ADRIAN;ZUBIRIA FURESTBARBARA SOFIA;SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO;LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER;GIL MATA JAVIER;GONZALEZDOMINGUEZ IGNACIO;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T 3544 , F 177, S 8,H AS 7218, I/A 59 (10.08.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORES CANALES JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: DEL BARRIO GOMEZ JOSEIGNACIO. Datos registrales. T 3544 , F 178, S 8, H AS 7218, I/A 60 (10.08.10).

26 de Julio de 2010
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. LA INSTALACION YMANTENIMIENTO DE APARATOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD. Datos registrales. T 3544 , F 177, S 8, H AS7218, I/A 58 (13.07.10).

26 de Noviembre de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: MONTOYA PEREZ JOSE. Apo.Sol.: MONTOYA PEREZ JOSE. Apo.Manc.: FLORES CANALES JOSEMARIA. Apo.Sol.: FLORES CANALES JOSE MARIA. Apo.Manc.: VALERO RODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Sol.: VALERO RODRIGUEZADRIAN. Apo.Manc.: AGUERA INFANTE RAUL. Apo.Sol.: AGUERA INFANTE RAUL. Apo.Manc.: SAAVEDRA OBERMANNFERNANDO. Apo.Sol.: SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO. Apo.Manc.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZMAZA MANUEL. Apo.Manc.: LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER.Apo.Manc.: GIL CREGO CESAR. Apo.Sol.: GIL CREGO CESAR. Apo.Manc.: SANCHEZ ORTEGA MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZORTEGA MANUEL. Apo.Manc.: ANGUEIRA GANDARA MANUEL. Apo.Sol.: ANGUEIRA GANDARA MANUEL. Datos registrales. T3544 , F 177, S 8, H AS 7218, I/A 57 (16.11.09).

15 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MERA FERNANDO. Datos registrales. T 3544 , F 174, S 8, H AS 7218, I/A 56 ( 1.10.09).

24 de Agosto de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: MONTOYA PEREZ JOSE. Apo.Sol.: MONTOYA PEREZ JOSE. Apo.Manc.: FLORES CANALES JOSEMARIA. Apo.Sol.: FLORES CANALES JOSE MARIA. Apo.Manc.: VALERO RODRIGUEZ ADRIAN. Apo.Sol.: VALERO RODRIGUEZADRIAN. Apo.Manc.: AGUERA INFANTE RAUL. Apo.Sol.: AGUERA INFANTE RAUL. Apo.Manc.: SAAVEDRA OBERMANNFERNANDO. Apo.Sol.: SAAVEDRA OBERMANN FERNANDO. Apo.Manc.: LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.:LEBRERO BURGOS FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GIL CREGO CESAR. Apo.Sol.: GIL CREGO CESAR. Apo.Manc.: SANCHEZORTEGA MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ ORTEGA MANUEL. Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: MARTINEZJURADO LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T3544 , F 174, S 8, H AS 7218, I/A 55 (11.08.09).

29 de Junio de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ FALCON AMANDO;GARCIA-QUILEZGOMEZ JESUS ANGEL;DE LAS CUEVAS TERAN FERNANDO. Datos registrales. T 3544 , F 173, S 8, H AS 7218, I/A 53(16.06.09).

Revocaciones. Apo.Sol.: CHAVES IBORRA PAULA. Datos registrales. T 3544 , F 174, S 8, H AS 7218, I/A 54 (16.06.09).

19 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: GASSET LORING MANUEL. Nombramientos. Secretario: GARCIA PAEZ LIDIA. Datosregistrales. T 3544 , F 173, S 8, H AS 7218, I/A 52 ( 8.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información