Actos BORME de Trans.laniet Sl
23 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: ALBA PARRA JOSEFA. Datos registrales. T 5913, L 3219, F 94, S 8, H V 56904, I/A 12 (16.10.14).
13 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JORRO BELANDO ANA MARIA;ROCA-MONZO JORRO FRANCISCO MIGUEL;ROMERO CASTROANGEL. Presidente: ROCA-MONZO JORRO FRANCISCO MIGUEL. Vicepresid.: ROMERO CASTRO ANGEL. Con.Delegado:ROMERO CASTRO ANGEL. SecreNoConsj: GOMEZ FERRER MORANT LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ROCA-MONZOJORRO FRANCISCO MIGUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador煤nico. Datos registrales. T 5913, L 3219, F 94, S 8, H V 56904, I/A 11 ( 6.08.14).
13 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO CASTRO ANGEL;ROCA MONZO JORRO FRANCISCO MIGUEL;NIETO BUENO JAVIERBERNARDO. Vicepresid.: ROMERO CASTRO ANGEL. Con.Delegado: ROMERO CASTRO ANGEL. Presidente: ROCA MONZOJORRO FRANCISCO MIGUEL. Nombramientos. Consejero: JORRO BELANDO ANA MARIA;ROCA MONZO JORRO FRANCISCOMIGUEL;ROMERO CASTRO ANGEL. Presidente: ROCA MONZO JORRO FRANCISCO MIGUEL. Vicepresid.: ROMERO CASTROANGEL. Con.Delegado: ROMERO CASTRO ANGEL. Reelecciones. SecreNoConsj: GOMEZ FERRER MORANT LUIS. Datosregistrales. T 5913, L 3219, F 93, S 8, H V 56904, I/A 10 ( 6.06.13).
03 de Abril de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 300.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 372.620,00 Euros. Datos registrales. T 5913, L 3219, F 93,S 8, H V 56904, I/A 9 (25.03.13).
17 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: ALBA PARRA JOSEFA. Datos registrales. T 5913, L 3219, F 92, S 8, H V 56904, I/A 8 ( 8.06.10).
17 de Febrero de 2009Ampliacion del objeto social. operador de transporte de mercancias. Datos registrales. T 5913, L 3219, F 92, S 8, H V 56904, I/A 7( 6.02.09).