Actos BORME de Transbecsa Sl
12 de Noviembre de 2013Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1003, L 567, F 13, S 8, H CS 1207, I/A 63 ( 5.11.13).
07 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BATALLA REIGADA GABRIEL ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: LUBASADESARROLLOS INMOBILIARIOS SL. Datos registrales. T 1003, L 567, F 12, S 8, H CS 1207, I/A 61 (29.07.13).
Nombramientos. Apoderado: JULIAN MATEU RUBEN. Datos registrales. T 1003, L 567, F 12, S 8, H CS 1207, I/A 62 (30.07.13).
12 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: GINER MARTI MANUEL. Datos registrales. T 1003, L 567, F 12, S 8, H CS 1207, I/A 60 ( 3.06.13).
10 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: TENA MORELLON ARTURO. Datos registrales. T 995, L 559, F 26, S 8, H CS 1207, I/A 59 (2.04.13).
13 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: GASCON BRINES FRANCISCO VICENTE. Datos registrales. T 995, L 559, F 26, S 8, H CS 1207, I/A58 ( 7.03.13).
19 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: MARCH VAZQUEZ JOSE BENITO. Datos registrales. T 995, L 559, F 26, S 8, H CS 1207, I/A 57(11.02.13).
23 de Octubre de 2012Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DEL RIO BARRIOS LUIS. Datos registrales. T 995, L 559, F 25, S 8, H CS 1207, I/A 56 (4.10.12).
16 de Octubre de 2012Revocaciones. Apoderado: BEOTEGUI ZUBIETA IGNACIO. Datos registrales. T 995, L 559, F 25, S 8, H CS 1207, I/A 55 (3.10.12).
23 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: GOMEZ SAFONT ARCADIO;GOMEZ SAFONT ARCADIO. Datos registrales. T 995, L 559, F 25, S 8, HCS 1207, I/A 54 (14.08.12).
01 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: MARCH VAZQUEZ JOSE BENITO. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A 53(23.05.12).
12 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: OLLER SANZ JUAN ALBERTO. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A 52(29.03.12).
21 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Apoderado: BALLESTER ESCRIG JUAN MANUEL. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A51 ( 9.11.11).
08 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: MARCO MU脩OZ ANTONIO;MARCO MU脩OZ ANTONIO JOSE;MARCO MU脩OZ ANTONIO;MARCOMU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A 50 (25.01.10).
18 de Diciembre de 2009Revocaciones. Auditor: PALLARES CHIVA RAMON JAVIER. Aud.Supl.: RALLO MONFORT MIGUEL. Nombramientos. Auditor:KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A 49 ( 9.12.09).
04 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: TIMONER LLORET FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A 48(26.10.09).
09 de Octubre de 2009Revocaciones. Apoderado: ANDREU MOLINER FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 995, L 559, F 24, S 8, H CS 1207, I/A47 (29.09.09).
24 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: PEREZ RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL. Datos registrales. T 963, L 528, F 165, S 8, H CS 1207, I/A46 (13.08.09).
13 de Febrero de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: AREOSA SASTRE MANUEL. Datos registrales. T 963, L 528, F 165, S 8, H CS 1207, I/A 45 (5.02.09).
14 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: PALLARES CHIVA RAMON JAVIER. Aud.Supl.: RALLO MONFORT MIGUEL. Datos registrales. T 963, L528, F 165, S 8, H CS 1207, I/A 44 (31.12.08).