Actos BORME de Transformados Castellanos De Cereales Sa
21 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MONEO MATA FRANCISCO JAVIER;MONEO ARCE CRISTINA;DE LA VILLA SAIZ RAFAEL.Secretario: MONEO MATA FRANCISCO JAVIER. Presidente: DE LA VILLA SAIZ RAFAEL. Nombramientos. Consejero: MONEOMATA ALBERTO;MONEO MATA FRANCISCO JAVIER;DE LA VILLA SAIZ RAFAEL. Presidente: DE LA VILLA SAIZ RAFAEL.Secretario: MONEO MATA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 782, L 573, F 188, S 8, H BU 1201, I/A 51 (15.12.23).
31 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: DE LA VILLA SAIZ RAFAEL. Datos registrales. T 782, L 573, F 186, S 8, H BU 1201, I/A 50(25.08.23).
24 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 782, L 573, F 186, S 8, H BU 1201, I/A 49 (18.11.22).
12 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 782, L 573, F 186, S 8, H BU 1201, I/A 48 ( 4.11.21).
04 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MONEO DE LA VILLA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: MONEO MATAFRANCISCO JAVIER;MONEO ARCE CRISTINA;DE LA VILLA SAIZ RAFAEL. Secretario: MONEO MATA FRANCISCO JAVIER.Presidente: DE LA VILLA SAIZ RAFAEL. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: Artículos 11, 18 y 24 a 28 de los estatutos: laadministración de la sociedad se encomienda a un Consejo, integrado por un mínimo de tres y un máximo de 12 miembros, quienesejercerán su cargo por plazo de dos años con carácter no retribuido.. Datos registrales. T 758, L 549, F 152, S 8, H BU 1201, I/A 46(29.07.21).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ ALONSO LUIS ANGEL. Datos registrales. T 758, L 549, F 152, S 8, H BU 1201, I/A 47(29.07.21).
04 de Junio de 2019Reelecciones. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 491, L 282, F 43, S 8, H BU 1201, I/A 45 (29.05.19).
05 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 491, L 282, F 43, S 8, H BU 1201, I/A 44 (29.11.18).
22 de Mayo de 2018Reelecciones. Adm. Unico: MONEO DE LA VILLA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 491, L 282, F 43, S 8, H BU 1201, I/A43 (16.05.18).
02 de Noviembre de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SLP.Datos registrales. T 491, L 282, F 43, S 8, H BU 1201, I/A 42 (27.10.15).
05 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Datos registrales. T 491, L 282, F 42, S 8, H BU 1201, I/A 41 (29.07.14).
17 de Junio de 2013Reelecciones. Adm. Unico: MONEO DE LA VILLA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 491, L 282, F 42, S 8, H BU 1201, I/A
Reelecciones. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Datos registrales. T 491, L 282, F 42, S 8, H BU 1201, I/A 40 (11.06.13).
21 de Febrero de 2013Reducción de capital. Importe reducción: 601.859,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.944.100,00 Euros. Datos registrales. T 491, L282, F 41, S 8, H BU 1201, I/A 38 (14.02.13).
26 de Abril de 2012Reelecciones. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Datos registrales. T 491, L 282, F 41, S 8, H BU 1201, I/A 37 (17.04.12).
14 de Julio de 2011Reelecciones. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Datos registrales. T 491, L 282, F 41, S 8, H BU 1201, I/A 36 ( 6.07.11).
24 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Datos registrales. T 491, L 282, F 41, S 8, H BU 1201, I/A 35 (15.06.10).
09 de Julio de 2009Reelecciones. Auditor: TRUE FAIR CL SL. Datos registrales. T 491, L 282, F 41, S 8, H BU 1201, I/A 34 (30.06.09).