Actos BORME de Transgallus Sl
26 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANCHEZ MARCOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 210, S 8, H CC 14999, I/A 26 (5.07.23).
Nombramientos. Apoderado: FLORES FRUTOS DAVID. Datos registrales. T 1051, L 878, F 210, S 8, H CC 14999, I/A 27 (5.07.23).
02 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL;GONZALEZ VELA CARLOS;DE LOSSANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 209, S 8, H CC 14999, I/A 24 (22.02.23).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL;MORALEDA OLIVARES MOISES JOSE;GONZALEZ VELACARLOS;DE LOS SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 210, S 8, H CC 14999, I/A 25 (22.02.23).
16 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANCHEZ MARCOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 209, S 8, H CC 14999, I/A 22 (6.02.23).
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GRANDE RAFAEL. Datos registrales. T 1051, L 878, F 209, S 8, H CC 14999, I/A 23 (6.02.23).
29 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 209, S 8, H CC 14999, I/A 20(22.12.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL;GONZALEZ VELA CARLOS;DELOS SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 209, S 8, H CC 14999, I/A 21 (22.12.21).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HUETE GEMMA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 208, S 8, H CC 14999, I/A 19(25.10.21).
09 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MANZANO EVA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 208, S 8, H CC 14999, I/A 18(27.05.21).
02 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MORENO MUÑOZ CARLOS;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA.Datos registrales. T 1051, L 878, F 208, S 8, H CC 14999, I/A 17 (19.02.21).
10 de Febrero de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AVICOLA VMR SL. Datosregistrales. T 1051, L 878, F 208, S 8, H CC 14999, I/A 15 ( 2.02.21).
Otros conceptos: Se adiciona un nuevo artículo a los estatutos sociales, el 7 bis, relativo a la prenda sobre participaciones sociales.Datos registrales. T 1051, L 878, F 208, S 8, H CC 14999, I/A 16 ( 2.02.21).
08 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: VALERO MARTINEZ IRENE. Datos registrales. T 1051, L 878, F 207, S 8, H CC 14999, I/A 14(29.09.20).
29 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ GRANDE RAFAEL. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 7(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 8(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: CARBAYO CARBAYO SANTOS. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 10(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 11(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: VALERO MARTINEZ IRENE. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 12(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VELA CARLOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 195, S 8, H CC 14999, I/A 9(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HUETE GEMMA. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 13(21.07.20).
23 de Abril de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ DE LAIGLESIA PAN CARLOS JOSE;GARCIA-BOENTE DAVILA ANA. Datos registrales. T1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 4 (27.03.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 5(27.03.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO AVICOLA VMR SL. Nombramientos. Adm. Unico:GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AVICOLA VMR SL. Datos registrales. T 1009, L 836, F 102, S 8, H CC 14999, I/A 6(27.03.20).
16 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 1009, L 836, F 101, S 8, H CC 14999, I/A 3 (9.07.19).
18 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO MUÑOZ CARLOS;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL;VAZQUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 1009, L 836, F 99, S 8, H CC 14999, I/A 2 ( 9.07.18).
18 de Mayo de 2018Constitución. Comienzo de operaciones: 5.04.18. Objeto social: El transporte de mercancias, agencia de transportes y alquiler demaquinaria y vehiculos con o sin motor. Domicilio: POLIG INDUSTRIAL LAGUNA NUEVA PARCELA 23 A 59 (CASATEJADA). Capital:250.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO AVICOLA VMR SL.Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO AVICOLA VMR SL. Datos registrales. T 1009, L 836, F 95,S 8, H CC 14999, I/A 1 ( 8.05.18).