Actos BORME de Transport Service & Releasing Iberia Sl
16 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36116 , F 206, S 8, H M 537169, I/A 28 ( 8.11.23).
13 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: VILALLONGA GORTAZAR BOSCO. Nombramientos. Representan: CACERES MARGARITJESUS. Datos registrales. T 36116 , F 206, S 8, H M 537169, I/A 27 ( 5.10.23).
01 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJOANDRES;MARTIN FRANCO JORGE;DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;ARREDONDOPORTILLA AINHOA. Datos registrales. T 36116 , F 206, S 8, H M 537169, I/A 26 (24.11.22).
21 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36116 , F 205, S 8, H M 537169, I/A 25 (14.11.22).
26 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: FORMANN MARKUS. Nombramientos. Representan: SUNDL ANDREAS. Datos registrales. T36116 , F 205, S 8, H M 537169, I/A 24 (19.09.22).
28 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: VARELA CENTENO FRANCISCO JESUS. Nombramientos. Representan: VILALLONGAGORTAZAR BOSCO. Datos registrales. T 36116 , F 205, S 8, H M 537169, I/A 23 (21.02.22).
25 de Enero de 2022Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 20 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 36116 , F 205, S 8, H M 537169, I/A22 (18.01.22).
21 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36116 , F 204, S 8, H M 537169, I/A 21 (14.12.21).
09 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36116 , F 204, S 8, H M 537169, I/A 20 (30.11.20).
01 de Julio de 2020Nombramientos. Con.Delegado: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL. Datos registrales. T 36116 , F204, S 8, H M 537169, I/A 19 (24.06.20).
12 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: LAFFEY ALEXANDER. Nombramientos. Representan: HUSTINX RAPHAEL. Datos registrales.T 36116 , F 203, S 8, H M 537169, I/A 18 ( 5.11.19).
23 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: ESTEVEZ MACARRO EDUARDO. Nombramientos. Representan: VARELA CENTENOFRANCISCO JESUS. Datos registrales. T 36116 , F 203, S 8, H M 537169, I/A 17 (16.10.19).
09 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36116 , F 203, S 8, H M 537169, I/A 16 ( 2.10.19).
02 de Julio de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social . Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 65 (MADRID).Datos registrales. T 36116 , F 203, S 8, H M 537169, I/A 15 (25.06.19).
15 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: AGAPITO VAQUER MANUEL. Datos registrales. T 36116 , F 201, S 8, H M 537169, I/A 14 ( 8.02.19).
11 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ ALONSO JUAN IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: ALEMANY ESPLUGUES JOSEP LLUIS.Datos registrales. T 29854 , F 56, S 8, H M 537169, I/A 13 ( 4.07.17).
16 de Mayo de 2017Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 29854 , F 56, S 8, H M 537169, I/A 12 ( 8.05.17).
12 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: HODLMAYR INTERNATIONAL AG. Nombramientos. Presidente: BERGE INFRAESTRUCTURASY SERVICIOS LOGISTICOS SL. Datos registrales. T 29854 , F 56, S 8, H M 537169, I/A 11 ( 4.05.17).
07 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MOSTYN BASON NIGEL JAMES. Apoderado: SANTISTEBAN RODRIGUEZ JOSE. Nombramientos.Apo.Sol.: LOPEZ ALONSO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 29854 , F 54, S 8, H M 537169, I/A 10 (29.06.16).
14 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: ZWIRNER KONRAD. Nombramientos. Representan: FORMANN MARKUS. Datos registrales.T 29854 , F 53, S 8, H M 537169, I/A 9 ( 7.06.16).
14 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: MOSTYN BASON NIGEL JAMES. Nombramientos. Representan: LAFFEY ALEXANDER. Datosregistrales. T 29854 , F 53, S 8, H M 537169, I/A 8 ( 4.03.16).
02 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: ROCARIES THIERRY. Nombramientos. Representan: ESTEVEZ MACARRO EDUARDO. Datosregistrales. T 29854 , F 53, S 8, H M 537169, I/A 7 (23.10.15).
08 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: SANTISTEBAN RODRIGUEZ JOSE. Datos registrales. T 29854 , F 51, S 8, H M 537169, I/A 6(31.07.14).
06 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: AUTOLOGIC HOLDINGS PLC. Nombramientos. Presidente: HODLMAYR INTERNATIONAL AG.Datos registrales. T 29854 , F 51, S 8, H M 537169, I/A 5 (30.07.14).
24 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Nombramientos. SecreNoConsj: MENENDEZ SANZALBERTO. Datos registrales. T 29854 , F 50, S 8, H M 537169, I/A 4 (14.02.14).
03 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Representan: ESTEVEZ MACARRO EDUARDO. Nombramientos. Representan: ZWIRNER KONRAD. Datosregistrales. T 29854 , F 50, S 8, H M 537169, I/A 3 (21.11.12).
03 de Mayo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOSTYN BASON NIGEL JAMES;ESTEVEZ MACARRO EDUARDO. Datos registrales. T 29854 , F48, S 8, H M 537169, I/A 2 (19.04.12).
27 de Abril de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 21.03.12. Objeto social: DESARROLLO LOGISTICO DE TODAS LAS ACTIVIDADESRELACIONADAS CON EL ALMACENAJE, DEPOSITO Y PUESTA A DISPOSICION DE MERCANCIAS Y MATERIALES QUE SEMANIPULAN, ASI COMO A LA LOGISTICA, EL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCION DE VEHICULOS... Domicilio: PASEO DE LACALDERONA S/N (CIEMPOZUELOS). Capital: 60.000,00 Euros. Nombramientos. Representan: MOSTYN BASON NIGELJAMES;ESTEVEZ MACARRO EDUARDO;ROCARIES THIERRY. Consejero: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOSLOGISTICOS SL;HODLMAYR INTERNATIONAL AG;AUTOLOGIC HOLDINGS PLC. Presidente: AUTOLOGIC HOLDINGS PLC.SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Datos registrales. T 29854 , F 46, S 8, H M 537169, I/A 1 (18.04.12).