Buscador CIF Logo

Actos BORME Transportes Buytrago Barcelona Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Transportes Buytrago Barcelona Sl

Actos BORME Transportes Buytrago Barcelona Sl - B58521626

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Transportes Buytrago Barcelona Sl con CIF B58521626

馃敊 Perfil de Transportes Buytrago Barcelona Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Transportes Buytrago Barcelona Sl

17 de Noviembre de 2020
Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO558/2014, AUTO FIRME DE FECHA 02/10/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Extinci贸n.Datos registrales. T 43199 , F 13, S 8, H B 163837, I/A 35 ( 9.11.20).

29 de Septiembre de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: MU脩OZ LAMBERTI ANTONIO. PRESIDENTE: MU脩OZ LAMBERTI ANTONIO. CONSEJERO:BARRIOPEDRO ESTATOLERO ALFONSO. SECRETARIO: BARRIOPEDRO ESTATOLERO ALFONSO. CONSEJERO: OCHAYTAMU脩OZ MARIA PILAR;MU脩OZ GIVICA MARIA ELENA;ALABAU CEBRIA JUAN JOSE. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL7 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 558/2014, AUTO FIRME DE FECHA 16/02/2015, RECTIFICADO PORAUTO DE FECHA 24/07/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 43199 , F12, S 8, H B 163837, I/A 34 (22.09.15).

09 de Enero de 2015
Nombramientos. ADM.CONCURS.: MARTINEZ SANZ FERNANDO. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 7 DE MADRID,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 558/2014, AUTO FIRME DE FECHA 28/07/2014, DECLARACION DE CONCURSOVOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES. Datos registrales. T 43199 , F 11, S 8, H B 163837,I/A 33 (30.12.14).

25 de Septiembre de 2012
Cambio de domicilio social. AV LES GARRIGUES 21 PO.IN. MAS BLAU II (PRAT DE LLOBREGAT (EL)). Datos registrales. T43199 , F 11, S 8, H B 163837, I/A 32 (17.09.12).

07 de Junio de 2012
Nombramientos. APODERADO: MU脩OZ LAMBERTI ANTONIO;OCHAYTA MU脩OZ PILUCA;BARRIOPEDRO ESPATOLEROALFONSO;GOMEZ ALABU CARMEN;FLORES GORDO ANDRES. Datos registrales. T 33874 , F 70, S 8, H B 163837, I/A 31(25.05.12).

28 de Marzo de 2012
Revocaciones. APODERADO: SUBIRANA ORTELLS JORGE;ALABAU SUSPERREGUI VICENTE;VICIANO AGOSTANTONIO;FLORES GORDO ANDRES;GOMEZ ALABAU CARMEN;GIMENEZ LATORRE RICARD. Datos registrales. T 33874 , F69, S 8, H B 163837, I/A 30 (16.03.12).

19 de Enero de 2011
Revocaciones. APODERADO: MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIO. Datos registrales. T 33874 , F 69, S 8, H B 163837, I/A 29 (5.01.11).

15 de Noviembre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: SAGA AUDITORES SL. Datos registrales. T 33874 , F 69, S 8, H B 163837, I/A 28 ( 3.11.10).

04 de Junio de 2010
Revocaciones. APODERADO: CABANE VENTURA JORDI;GOMEZ ALABAU CARMEN;GIMENEZ LATORRE RICARD.Nombramientos. APODERADO: MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIO;FLORES GORDO ANDRES;GOMEZ ALABAUCARMEN;GIMENEZ LATORRE RICARD. Datos registrales. T 33874 , F 68, S 8, H B 163837, I/A 27 (21.05.10).

23 de Septiembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GARRALDA TEUS MIGUEL. AUDITOR SUP.: BAEZ MONTERO CARLOS. Datos registrales. T33874 , F 68, S 8, H B 163837, I/A 26 ( 9.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n