Actos BORME de Transportes Farmaceuticos Sa
08 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Consejero: NAVAS GONZALEZ CARLOS;GARCIA MEDINA JESUS.Secretario: GARCIA MEDINA JESUS. Consejero: NAVAS AGUILERA SILVIA. Con.Delegado: NAVAS GONZALEZ CARLOS.Nombramientos. Adm. Solid.: NAVAS AGUILERA SILVIA;NAVAS AGUILERA MARIA DE LOS ANGELES. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9潞 Y 18潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE DEJA SIN EFECTO LOSARTICULOS 19潞 Y 20潞 DE LOS MISMOS. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 34106 , F 214, S 8, H M 56227, I/A 32 (27.04.23).
21 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 34106 , F 214, S 8, H M 56227, I/A 31 (14.02.23).
05 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: GARCIA MEDINA JESUS. Datos registrales. T 34106 , F 213, S 8, H M 56227, I/A 30 (28.11.22).
24 de Septiembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 332.179,39 Euros. Desembolsado: 332.179,39 Euros. Resultante Suscrito: 714.783,69 Euros.Resultante Desembolsado: 714.783,69 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 34106 , F 211, S 8, H M 56227, I/A 29 (17.09.21).
27 de Octubre de 2020Reelecciones. Presidente: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Consejero: NAVAS GONZALEZ CARLOS;GARCIA MEDINA JESUS.Secretario: GARCIA MEDINA JESUS. Consejero: NAVAS AGUILERA SILVIA. Con.Delegado: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Datosregistrales. T 34106 , F 211, S 8, H M 56227, I/A 28 (20.10.20).
17 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 34106 , F 210, S 8, H M 56227, I/A 27 (10.12.19).
09 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 249.960,93 Euros. Desembolsado: 249.960,93 Euros. Resultante Suscrito: 382.604,30 Euros.Resultante Desembolsado: 382.604,30 Euros. Datos registrales. T 21079 , F 173, S 8, H M 56227, I/A 25 ( 1.03.16).
Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 18 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 34106 , F 210, S 8, H M56227, I/A 26 ( 1.03.16).
17 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Cons.Del.Sol: GARCIA MEDINA JESUS. Cons.Del.Man: GARCIAMEDINA JESUS. Nombramientos. Con.Delegado: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Reelecciones. Presidente: NAVAS GONZALEZCARLOS. Consejero: NAVAS GONZALEZ CARLOS;GARCIA MEDINA JESUS. Secretario: GARCIA MEDINA JESUS. Consejero:NAVAS AGUILERA SILVIA. Datos registrales. T 21079 , F 172, S 8, H M 56227, I/A 24 (10.12.15).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ ORDU脩A JUAN. Datos registrales. T 21079 , F 171, S 8, H M 56227, I/A 23 (13.08.13).
16 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ DIAZ AGAPITO. Cons.Del.Man: DIAZ DIAZ AGAPITO. Cons.Del.Sol: DIAZ DIAZ AGAPITO.Nombramientos. Consejero: NAVAS AGUILERA SILVIA. Otros conceptos: HA QUEDADO RATIFICADO EL NOMBRAMIENTODEL CONSEJERO, DO脩A SILVIA NAVAS AGUILERA EFECTUADO POR EL CONSEJO CELEBRADO EL DIA 21 DE NOVIEMBREDE 2012.- Datos registrales. T 21079 , F 171, S 8, H M 56227, I/A 22 ( 7.08.13).
21 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: NAVAS AGUILERA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 21079 , F 170, S 8, H M 56227,I/A 21 (10.11.11).
25 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: FRANCO ALLUEVA FERNANDO CARLOS. Aud.Supl.: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SL. Datosregistrales. T 21079 , F 170, S 8, H M 56227, I/A 20 ( 6.04.11).
15 de Julio de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 67.734,06 Euros. Desembolsado: 67.734,06 Euros. Resultante Suscrito: 132.643,37 Euros.Resultante Desembolsado: 132.643,37 Euros. Datos registrales. T 21079 , F 169, S 8, H M 56227, I/A 19 ( 6.07.10).
06 de Julio de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 24.340,99 Euros. Datos registrales. T 21079 , F 168, S 8, H M 56227, I/A 18(24.06.10).
11 de Enero de 2010Nombramientos. Aud.Supl.: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: FRANCO ALLUEVA FERNANDOCARLOS. Datos registrales. T 21079 , F 166, S 8, H M 56227, I/A 15 (23.12.09).
Cambio de domicilio social. C/ DE SAHAGUN 28-30 - POSTERIOR, PLANTA BAJA (ALCORCON). Datos registrales. T 21079 , F167, S 8, H M 56227, I/A 16 (23.12.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER. Presidente: NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER.Cons.Del.Man: NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER. Cons.Del.Sol: NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER. Nombramientos.Presidente: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Consejero: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Co.De.Ma.So: NAVAS GONZALEZ CARLOS.Reelecciones. Consejero: GARCIA MEDINA JESUS;DIAZ DIAZ AGAPITO. Secretario: GARCIA MEDINA JESUS. Cons.Del.Man:DIAZ DIAZ AGAPITO. Cons.Del.Sol: DIAZ DIAZ AGAPITO;GARCIA MEDINA JESUS. Cons.Del.Man: GARCIA MEDINA JESUS.Datos registrales. T 21079 , F 167, S 8, H M 56227, I/A 17 (23.12.09).
05 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Cons.Del.Sol: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Cons.Del.Man: NAVASGONZALEZ CARLOS. Consejero: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: NAVAS AGUILERA CARLOSJAVIER. Presidente: NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER. Cons.Del.Man: NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER. Cons.Del.Sol:NAVAS AGUILERA CARLOS JAVIER. Reelecciones. Consejero: GARCIA MEDINA JESUS;DIAZ DIAZ AGAPITO. Secretario:GARCIA MEDINA JESUS. Cons.Del.Man: DIAZ DIAZ AGAPITO. Cons.Del.Sol: DIAZ DIAZ AGAPITO;GARCIA MEDINA JESUS.Cons.Del.Man: GARCIA MEDINA JESUS. Datos registrales. T 21079 , F 164, S 8, H M 56227, I/A 13 (26.05.09).
Nombramientos. Apoderado: NAVAS GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 21079 , F 165, S 8, H M 56227, I/A 14 (26.05.09).