Actos BORME de Transportes Lago Sl
31 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VASSEROT ANTON PEDRO. Consejero: DE TORRES ATENCIA BORJA;MARTIN-SANZMARTINEZ CESAREO;MARTIN-SANZ MARTINEZ JOSE CARMELO;DE TORRES PEREZ DOMINGO;GONZALEZ RUBIO ANGEL.Presidente: DE TORRES ATENCIA BORJA. Con.Delegado: DE TORRES ATENCIA BORJA. Revocaciones. Apo.Sol.: SAN JUANDELGADO CRISTOBAL GONZALO;ACOSTA MORENO JOSE ANTONIO. Apoderado: LAGO SANTOS JOSE LUIS. Disoluci贸n.Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5333, L 4240, F 47, S 8, H MA125286, I/A 3 (19.12.14).
07 de Noviembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ CASTELAO 9 - POLIGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. (MALAGA). Datos registrales. T 5333,L 4240, F 47, S 8, H MA125286, I/A 2 (29.10.14).
02 de Octubre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.609.007,40 Euros. Resultante Suscrito: 866.388,60 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 26119 , F 196, S 8, H M 20432, I/A 37 (22.09.14).
21 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: LAGO SANTOS JOSE LUIS;RUBIO VICO CRESCENCIO;RUBIO VICO CRESCENCIO. Apo.Sol.: SANJUAN DELGADO CRISTOBAL GONZALO. Datos registrales. T 26119 , F 196, S 8, H M 20432, I/A 36 (11.08.14).
16 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: DE SAN JUAN DELGADO CRISTOBAL;ACOSTA MORENO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T26119 , F 195, S 8, H M 20432, I/A 35 ( 8.05.14).
06 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN SANZ MARTINEZ CESAREO;MARTIN SANZ MARTINEZ JOSE CARMELO;MARTIN SANZMARTINEZ JESUS. Presidente: MARTIN SANZ MARTINEZ CESAREO. Secretario: MARTIN SANZ MARTINEZ JOSE CARMELO.Cons.Del.Sol: MARTIN SANZ MARTINEZ JESUS;MARTIN SANZ MARTINEZ JOSE CARMELO;MARTIN SANZ MARTINEZCESAREO. Nombramientos. Consejero: DE TORRES ATENCIA BORJA;DE TORRES PEREZ DOMINGO;GONZALEZ RUBIOANGEL;MARTIN SANZ MARTINEZ CESAREO;MARTIN SANZ MARTINEZ JOSE CARMELO. Presidente: DE TORRES ATENCIABORJA. Con.Delegado: DE TORRES ATENCIA BORJA. SecreNoConsj: VASSEROT ANTON PEDRO. Ampliaci贸n de capital.Capital: 475.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.475.396,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 15. Administraci贸n yRepresentacion.- MODIFICADO. 17. Administraci贸n y Representacion.- MODIFICADO. 18. Administraci贸n y Representacion.-MODIFICADO. 19. Administraci贸n y Representacion.- MODIFICADO. Datos registrales. T 26119 , F 191, S 8, H M 20432, I/A 34(22.04.14).
18 de Noviembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 434.396,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.999.796,00 Euros. Datos registrales. T 26119 , F 191, S 8,H M 20432, I/A 33 ( 8.11.13).
18 de Julio de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.308.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.565.400,00 Euros. Datos registrales. T 26119 , F 190, S8, H M 20432, I/A 32 ( 6.07.12).
06 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: ARANZAZU BARREIRA LUCIA. Aud.Supl.: FERNANDEZ LOPEZ JOSE. Datos registrales. T 26119 , F190, S 8, H M 20432, I/A 31 (26.06.12).
14 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: SAN JUAN DELGADO CRISTOBAL GONZALO. Datos registrales. T 26119 , F 190, S 8, H M 20432, I/A30 (31.03.09).