Actos BORME de Transportes Navalpotro Sociedad Limitada
19 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Liquidador: RENART MONTALAT JOAN BAPTISTA. Adm. Unico: SA VICHY CATALAN. Revocaciones.Apoderado: BARCONS ARUS MARIA EULALIA;RENART MONTALAT JOAN BAPTISTA;RENART CAVA JUAN BAUTISTA;RENARTCUENCA ANTONIO;RENART MONTALAT JOAN BAPTISTA;RENART CUENCA ANTONIO;VALLMAYOR CARRASCOAMADOR;CLAVERA GISPERT SERGIO;TRIVI脩O ENRIQUEZ JUAN CARLOS;ESTEBAN REGA脩O MARIAPURIFICACION;FERNANDEZ VI脩AS FRANCISCO JAVIER;SANZ VAZQUEZ PALOMA;LAURA BARTOLOME VILLAR.Nombramientos. Liquidador: RENART MONTALAT JOAN BAPTISTA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T203, L 152, F 162, S 8, H SO 510, I/A 38 (11.12.18).
05 de Septiembre de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SA VICHY CATALAN. Datos registrales. T 203, L 152, F 162, S 8,H SO 510, I/A 37 (28.08.18).
19 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: LAURA BARTOLOME VILLAR. Datos registrales. T 203, L 152, F 162, S 8, H SO 510, I/A 36(11.04.18).
27 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONATUR 1881 SL. Nombramientos. Adm. Unico: SA VICHY CATALAN. Datos registrales. T203, L 152, F 162, S 8, H SO 510, I/A 35 (16.01.17).
20 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Auditor: FACSS AUDITORS SL. Datos registrales. T 203, L 152, F 162, S 8, H SO 510, I/A 34 (18.12.15).
04 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: BARCONS ARUS MARIA EULALIA. Datos registrales. T 178, L 127, F 29, S 8, H SO 510, I/A 32(20.11.15).
Nombramientos. Apoderado: SANZ VAZQUEZ PALOMA. Datos registrales. T 203, L 152, F 162, S 8, H SO 510, I/A 33 (20.11.15).
18 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ VI脩AS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 178, L 127, F 29, S 8, H SO 510, I/A31 ( 1.09.14).
13 de Agosto de 2014Otros conceptos: Ampliaci贸n de las facultades asignadas a JUAN CARLOS TRIVI脩O ENRIQUEZ. Datos registrales. T 178, L 127,F 27, S 8, H SO 510, I/A 30 (31.07.14).
27 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: TRIVI脩O ENRIQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 178, L 127, F 27, S 8, H SO 510, I/A 27(17.02.14).
Revocaciones. Apoderado: ESTEBAN REGA脩O MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 178, L 127, F 27, S 8, H SO 510, I/A29 (17.02.14).
Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN REGA脩O MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 178, L 127, F 27, S 8, H SO 510,I/A 28 (17.02.14).
30 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: FACSS AUDITORS SL. Datos registrales. T 178, L 127, F 27, S 8, H SO 510, I/A 26 (21.08.13).
31 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: CLAVERA GISPERT SERGIO. Datos registrales. T 178, L 127, F 26, S 8, H SO 510, I/A 25(19.01.12).
25 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: PEDRO VILA RIUS. Datos registrales. T 178, L 127, F 26, S 8, H SO 510, I/A 23 (11.01.11).
Nombramientos. Apoderado: VALLMAYOR CARRASCO AMADOR. Datos registrales. T 178, L 127, F 26, S 8, H SO 510, I/A 24(11.01.11).
11 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: RENART MONTALAT JOAN BAPTISTA. Datos registrales. T 178, L 127, F 23, S 8, H SO 510, I/A 21(24.05.10).
Nombramientos. Apoderado: RENART CUENCA ANTONIO. Datos registrales. T 178, L 127, F 25, S 8, H SO 510, I/A 22(24.05.10).
08 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN REGA脩O MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T 178, L 127, F 22, S 8, H SO 510,I/A 17 (24.05.10).
Nombramientos. Apoderado: RENART CUENCA ANTONIO. Datos registrales. T 178, L 127, F 23, S 8, H SO 510, I/A 18(24.05.10).
Revocaciones. Apoderado: MARIA PURIFICACION ESTEBAN LEGA脩O;RENART CUENCA ANTONIO;RENART CAVAANTONIO;RENART CUENCA ANTONIO. Datos registrales. T 178, L 127, F 23, S 8, H SO 510, I/A 19 (24.05.10).
Nombramientos. Apoderado: PEDRO VILA RIUS. Datos registrales. T 178, L 127, F 23, S 8, H SO 510, I/A 20 (24.05.10).
05 de Octubre de 2009Nombramientos. Apoderado: RENART CAVA JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 178, L 127, F 21, S 8, H SO 510, I/A 16(18.09.09).