Actos BORME de Transportes Santo Domingo Sl
11 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLANA GONZALEZ JOSE CESAR. Datos registrales. T 28713 , F 189, S 8, H M 52051, I/A 33 (4.08.23).
09 de Marzo de 2022Cambio de domicilio social. C/ JOSEFA VALCARCEL 20 (MADRID). Datos registrales. T 28713 , F 188, S 8, H M 52051, I/A 32 (2.03.22).
05 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ BA脩UELOS JUAN ANTONIO;DIAZ SUAREZ DAVID. Datos registrales. T 28713 , F 188, S 8, HM 52051, I/A 31 (28.06.21).
05 de Febrero de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GENERAL TECNICA INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 28713 ,F 187, S 8, H M 52051, I/A 30 (29.01.20).
13 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: CEREIJO ALIJOSTES MARINA. Datos registrales. T 28713 , F 186, S 8, H M 52051, I/A 29 (6.05.19).
20 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS CAMPOS FRANCISCO. Datos registrales. T 28713 , F 185, S 8, H M 52051, I/A 27(11.09.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LLANA GONZALEZ JOSE CESAR;HERNANDO SANCHEZ VICTOR;GARCIA HIDALGOMARCOS;HERRERA CANO CONCEPCION;FERNANDEZ SANCHEZ ANA MARIA;CRESPO GUTIERREZ JESUS MARIA. Datosregistrales. T 28713 , F 185, S 8, H M 52051, I/A 28 (11.09.17).
12 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: ADRADOS MARTIN JAVIER;RUBIO VAQUERIZO OSCAR;PEREZ PRIETO MARIA;PASCUALARROYO NAIARA;GARCIA VALLE ALEJANDRO. Datos registrales. T 28713 , F 182, S 8, H M 52051, I/A 24 (31.08.17).
Revocaciones. Apoderado: URRUTIA GRACIA GUSTAVO;LAMEYER PASCUAL ASUNCION;LANZANI GONZALEZELENA;MARTINEZ GARCIA FRANCISCO;MU脩OZ LOBATO JOAQUIN;MIRON GONZALEZ JESUS;GARCIA MORENO PEDRO.Datos registrales. T 28713 , F 184, S 8, H M 52051, I/A 25 (31.08.17).
Cambio de objeto social. A) La prestaci贸n de toda clase de servicios de transporte por carretera, en cualquier modalidad y porcualquier medio. B) El alquiler de todo tipo de veh铆culos y dem谩s medios o elementos de transporte por carretera, con o sin conductor.C) La explotaci贸n de estaciones de servicio, garajes... Datos registrales. T 28713 , F 184, S 8, H M 52051, I/A 26 (31.08.17).
21 de Julio de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: NEX CONTINENTAL HOLDINGS SL. Ceses/Dimisiones.SecreNoConsj: ORTEGA MOLINA LUIS. Consejero: MIRON CALVIN JOSE. Presidente: MIRON CALVIN JOSE. Consejero: MIRONGONZALEZ JOSE LUIS;MIRON GONZALEZ JESUS. Nombramientos. Representan: GARCIA HIDALGO MARCOS;LOPEZMENENDEZ VICTOR-MANUEL. Adm. Mancom.: NEX CONTINENTAL HOLDINGS SL;GENERAL TECNICA INDUSTRIAL SL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Cambio dedomicilio social. C/ ALCALA 478 (MADRID). Datos registrales. T 28713 , F 181, S 8, H M 52051, I/A 23 (13.07.17).
23 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: MIRON GONZALEZ JOSE LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: ORTEGA MOLINA LUIS. Datosregistrales. T 28713 , F 179, S 8, H M 52051, I/A 21 (15.12.15).
Modificaciones estatutarias. 1. Refundici贸n de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 28713 , F 179, S 8, H M 52051, I/A 22(15.12.15).
22 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO;RISCO CRUZ PEDRO. Datos registrales. T 28713 , F 179,S 8, H M 52051, I/A 20 (14.08.13).
22 de Septiembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.016,50 Euros. Resultante Suscrito: 82.036,50 Euros. Datos registrales. T 14152 , F 225, S 8, HM 52051, I/A 19 (13.09.11).
15 de Enero de 2009Cambio de domicilio social. C/ INVESTIGACION - NUMERO 2, POLIGONO INDUSTRIAL (GETAFE). Datos registrales. T 14152 ,F 225, S 8, H M 52051, I/A 18 ( 2.01.09).