Actos BORME de Transportes Sedano Sa
27 de Enero de 2023Cambio de domicilio social. C/ CERAMICA, 6 19200 (AZUQUECA DE HENARES). Datos registrales. T 643 , F 73, S 8, H GU 432,I/A 42 (18.01.23).
Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES S.L. Datos registrales. T 643 , F 73, S 8, H GU 432, I/A 43 (18.01.23).
07 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES S.L. Datos registrales. T 643 , F 73, S 8, H GU 432, I/A 41 (27.01.22).
19 de Enero de 2021Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 608 , F 121, S 8, H GU 432, I/A 40 (31.12.20).
22 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: MANUEL ALVARO SANZ. Datos registrales. T 608 , F 121, S 8, H GU 432, I/A 39 ( 7.09.20).
08 de Julio de 2020Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES S.L. Datos registrales. T 608 , F 121, S 8, H GU 432, I/A 38 (15.06.20).
02 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ALONSO ANGELES. Datos registrales. T 608 , F 120, S 8, H GU 432, I/A 37 (19.07.19).
20 de Mayo de 2019Reelecciones. Consejero: JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA. Secretario: JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA. Consejero: SEDANOPRIETO VALENTIN. Presidente: SEDANO PRIETO VALENTIN. Consejero: DE LA ZARZA SEDANO MAGRANER MIREIA.Con.Delegado: SEDANO PRIETO VALENTIN. Consejero: SEDANO MAGRANER ESTHER. Datos registrales. T 608 , F 120, S 8, HGU 432, I/A 36 ( 9.05.19).
01 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: F.G.H. AUDITORES S.L. Datos registrales. T 608 , F 119, S 8, H GU 432, I/A 35 (22.02.19).
08 de Junio de 2018Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES S.L. Datos registrales. T 608 , F 119, S 8, H GU 432, I/A 34 (29.05.18).
25 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SEDANO MAGRANER ESTHER. Datos registrales. T 608 , F 118, S 8, H GU 432, I/A 33 (11.05.18).
02 de Enero de 2018Revocaciones. Apoderado: GOMEZ PRIETO DAVID. Datos registrales. T 608 , F 118, S 8, H GU 432, I/A 32 (19.12.17).
03 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ PRIETO DAVID. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ PRIETO DAVID. Datos registrales. T574 , F 24, S 8, H GU 432, I/A 31 (22.02.17).
17 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ PRIETO DAVID. Datos registrales. T 574 , F 23, S 8, H GU 432, I/A 30 (10.02.17).
04 de Enero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 52.107,75 Euros. Resultante Suscrito: 182.286,97 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 317.755,10 Euros. Desembolsado: 317.755,10 Euros. Resultante Suscrito: 500.042,07 Euros. Resultante Desembolsado:500.042,07 Euros. Datos registrales. T 574 , F 22, S 8, H GU 432, I/A 29 (24.12.15).
15 de Diciembre de 2015Nombramientos. Auditor: FGH AUDITORES SL. Datos registrales. T 574 , F 22, S 8, H GU 432, I/A 28 ( 3.12.15).
25 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SEDANO PRIETO VALENTIN;JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA;FRANCK COURTAUT. Presidente:SEDANO PRIETO VALENTIN. Secretario: JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA. Con.Delegado: SEDANO PRIETO VALENTIN.Nombramientos. Consejero: JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA. Secretario: JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA. Consejero:SEDANO PRIETO VALENTIN. Presidente: SEDANO PRIETO VALENTIN. Consejero: DE LA ZARZA SEDANO MAGRANER MIREIA.Con.Delegado: SEDANO PRIETO VALENTIN. Consejero: SEDANO MAGRANER ESTHER. Datos registrales. T 574 , F 22, S 8, HGU 432, I/A 27 (10.06.14).
20 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 574 , F 22, S 8, H GU 432, I/A 26 (12.08.13).
04 de Diciembre de 2012Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 159 , F 59, S 8, H GU 432, I/A 25 (22.11.12).
14 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ;RUBEN FERNANDEZ GARCIA. Datos registrales. T 159 , F59, S 8, H GU 432, I/A 23 (30.08.11).
Reelecciones. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 159 , F 59, S 8, H GU 432, I/A 24 (30.08.11).
04 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 159 , F 59, S 8, H GU 432, I/A 22 (10.12.10).
25 de Agosto de 2009Reelecciones. Consejero: SEDANO PRIETO VALENTIN;JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA;FRANCK COURTAUT. Presidente:
Nombramientos. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 159 , F 58, S 8, H GU 432, I/A 21 (28.07.09).
14 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: JESUS ANTONIO CALLEJA PLAZA. Datos registrales. T 159 , F 57, S 8, H GU 432, I/A 19(26.06.09).
02 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 148 , F 161, S 8, H GU 432, I/A 17 (28.11.08).
Reelecciones. Auditor: F.G.H. AUDITORES SL. Datos registrales. T 159 , F 57, S 8, H GU 432, I/A 18 (28.11.08).