Actos BORME de Tranvias Electricos De Vigo Sa
25 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: FONTAN GAGO PEDRO. Nombramientos. Consejero: FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO. Datosregistrales. T 1230, L 1230, F 130, S 8, H PO 7236, I/A 116 (17.08.22).
01 de Junio de 2021Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.tranviasdevigo.com. Datos registrales. T 1230, L 1230, F129, S 8, H PO 7236, I/A 115 (21.05.21).
07 de Abril de 2021Cambio de domicilio social. PLAZA DE COMPOSTELA 27 (VIGO). Datos registrales. T 1230, L 1230, F 129, S 8, H PO 7236, I/A114 (24.03.21).
16 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON. Presidente: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA. Consejero:FIAÑO VALVERDE JOSE S. Vicepresid.: FIAÑO VALVERDE JOSE S. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON. Consejero:VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;GARCIA DOMENECH CARLOS. Vicesecret.: GARCIA DOMENECH CARLOS. Consejero:BIANCHI VALCARCE EMILIO;VALCARCE DE ANGULO JOSE MARIA. Revocaciones. Apo.Manc.: VALCARCE VALCARCE JOSEANTONIO;DE SOUSA DAVILA JAIME ENRIQUE;VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO;BIANCHI VALCARCE EMILIO;FIAÑOVALVERDE JOSE S.;VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;BIANCHI VALCARCE EMILIO;FERNANDEZ ALVAREZ IAGOANTON;GARCIA DOMENECH CARLOS. Apo.Sol.: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON.Nombramientos. Consejero: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA. Presidente: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA. Consejero:GARCIA DOMENECH CARLOS. Secretario: GARCIA DOMENECH CARLOS. Consejero: FIAÑO VALVERDE JOSE SANTIAGO.Vicepresid.: FIAÑO VALVERDE JOSE SANTIAGO. Consejero: DIDAPESCA SL;FONTAN GAGO PEDRO. Cons.Del.Sol: FIAÑOVALVERDE JOSE SANTIAGO;DIDAPESCA SL. Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 498.893,50 Euros. Otrosconceptos: Se REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 118, S 8, H PO 7236, I/A 113 (5.08.19).
10 de Agosto de 2018Ampliación de capital. Suscrito: 1.001.000,00 Euros. Desembolsado: 502.106,50 Euros. Resultante Suscrito: 2.001.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.502.106,50 Euros. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 114, S 8, H PO 7236, I/A 112 ( 1.08.18).
15 de Noviembre de 2017Reducción de capital. Importe reducción: 9.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Otros conceptos: Semodifica el artículo 13º de los estatutos sociales, relativo al número de acciones necesarias para poder asistir a las Juntas Generales.Datos registrales. T 1230, L 1230, F 113, S 8, H PO 7236, I/A 111 ( 3.11.17).
19 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: VALCARCE VALCARCE JOSE-ANTONIO. Apo.Manc.: VALCARCE VALCARCE JOSE-ANTONIO;VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;BIANCHI VALCARCE EMILIO;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON;GARCIADOMENECH CARLOS;VALCARCE DE ANGULO JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: FIAÑO VALVERDE JOSES.;VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;BIANCHI VALCARCE EMILIO;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON;GARCIA DOMENECHCARLOS. Apo.Sol.: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON. Datos registrales. T 1230, L 1230,F 113, S 8, H PO 7236, I/A 110 ( 9.10.17).
24 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA. Consejero: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO.Presidente: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Nombramientos. Presidente: VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA.Consejero: FIAÑO VALVERDE JOSE S. Vicepresid.: FIAÑO VALVERDE JOSE S. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZALVAREZ IAGO ANTON. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON. Consejero: VALCARCE AVILA ANTONIOMARIA;GARCIA DOMENECH CARLOS. Vicesecret.: GARCIA DOMENECH CARLOS. Consejero: BIANCHI VALCARCEEMILIO;VALCARCE DE ANGULO JOSE MARIA. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 113, S 8, H PO 7236, I/A 109 (16.01.17).
23 de Enero de 2015Ampliación de capital. Suscrito: 9.000.000,00 Euros. Desembolsado: 9.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 10.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 13º.- Podrán asistir a las JuntasGenerales los accionistas que acrediten ser titulares de acciones cuyo valor nominal sea, al menos, de 5.000,00 euros con unaantelación mínima de 5 días al señalado para la celebración de la Junta General, en el libro registro de registro de acciones. Datosregistrales. T 1230, L 1230, F 112, S 8, H PO 7236, I/A 108 ( 9.01.15).
06 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DOMENECH CARLOS;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO;VALCARCE VALCARCE JOSEANTONIO;BUSTILLO NUÑEZ SANTIAGO;BIANCHI VALCARCE EMILIO;VALCARCE ANGULO JOSE MARIA. Vicepresid.: GARCIADOMENECH CARLOS. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO. Con.Delegado: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO.Presidente: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: VALCARCE VALCARCE JOSEANTONIO;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON;BIANCHI VALCARCE EMILIO;VALCARCE DE ANGULO JOSE MARIA;GARCIADOMENECH CARLOS;VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA. Presidente: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Vicepresid.:VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO ANTON. Vicesecret.: GARCIA DOMENECHCARLOS. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 87, S 8, H PO 7236, I/A 106 (27.05.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO;DE SOUSA DAVILA JAIME;VALCARCE VALCARCE JOSEANTONIO;DE SOUSA DAVILA JAIME;BIANCHI VALCARCE EMILIO;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO. Nombramientos. Apo.Manc.:VALCARCE VALCARCE JOSE-ANTONIO;VALCARCE AVILA ANTONIO MARIA;BIANCHI VALCARCE EMILIO;FERNANDEZALVAREZ IAGO ANTON;GARCIA DOMENECH CARLOS;VALCARCE DE ANGULO JOSE MARIA. Apoderado: VALCARCEVALCARCE JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 87, S 8, H PO 7236, I/A 107 (27.05.14).
26 de Marzo de 2014Nombramientos. Vicepresid.: GARCIA DOMENECH CARLOS. Consejero: GARCIA DOMENECH CARLOS. Datos registrales. T1230, L 1230, F 86, S 8, H PO 7236, I/A 104 (14.03.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO;DE SOUSA DAVILA JAIME;BIANCHI VALCARCEEMILIO;FERNANDEZ ALVAREZ IAGO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 86, S 8, H PO 7236, I/A 105 (14.03.14).
13 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SOUSA DAVILA JAIME. Vicepresid.: SOUSA DAVILA JAIME. Datos registrales. T 1230, L 1230, F86, S 8, H PO 7236, I/A 103 ( 5.02.14).
31 de Enero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: FONTAN DOMINGUEZ JACOBO;FONTAN DOMINGUEZ JACOBO. Datos registrales. T 1230, L 1230,F 86, S 8, H PO 7236, I/A 102 (22.01.14).
08 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FONTAN DOMINGUEZ JACOBO;FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO. Presidente: FONTANDOMINGUEZ JACOBO. Consejero: FIAÑO VALVERDE JOSE SANTIAGO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 85, S 8, H PO 7236,I/A 98 (27.12.13).
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Secretario: SOUSA DAVILA JAIME. Vicesecret.:FERNANDEZ ALVAREZ IAGO. Nombramientos. Presidente: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Vicepresid.: SOUSADAVILA JAIME. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 85, S 8, H PO 7236, I/A 99(27.12.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO;DE SOUSA DAVILA JAIME. Datos registrales. T 1230, L1230, F 86, S 8, H PO 7236, I/A 100 (27.12.13).
11 de Noviembre de 2013Nombramientos. Auditor: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 85, S 8, H PO 7236, I/A 97 (4.11.13).
08 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Nombramientos. Vicepresid.: VALCARCE VALCARCEJOSE ANTONIO. Vicesecret.: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 85, S 8, H PO 7236, I/A 96(27.09.13).
28 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VALVERDE ALONSO MARIA CONCEPCION. Vicepresid.: VALVERDE ALONSO MARIACONCEPCION. Nombramientos. Consejero: FIAÑO VALVERDE JOSE SANTIAGO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 84, S 8,H PO 7236, I/A 94 (20.08.13).
17 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ARMESTO JORGE. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ ALVAREZ IAGO.Datos registrales. T 1230, L 1230, F 84, S 8, H PO 7236, I/A 93 ( 3.07.12).
29 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: FERNANDEZ ARMESTO JORGE. Vicesecret.: SOUSA DAVILA JAIME. Nombramientos.Secretario: SOUSA DAVILA JAIME. Vicesecret.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 84,S 8, H PO 7236, I/A 92 (19.03.12).
09 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: BIANCHI VALCARCE EMILIO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 83, S 8, H PO 7236, I/A 91(27.02.12).
15 de Septiembre de 2009Reelecciones. Consejero: VALVERDE ALONSO MARIA CONCEPCION;VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO;FERNANDEZARMESTO JORGE;SOUSA DAVILA JAIME;FONTAN DOMINGUEZ JACOBO;BUSTILLO NUÑEZ SANTIAGO;FONTAN DOMINGUEZROBERTO;VALCARCE ANGULO JOSE MARIA;BIANCHI VALCARCE EMILIO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 82, S 8, H PO7236, I/A 87 (28.08.09).
Revocaciones. Vicesecret.: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Nombramientos. Vicesecret.: SOUSA DAVILA JAIME.Reelecciones. Presidente: FONTAN DOMINGUEZ JACOBO. Vicepresid.: VALVERDE ALONSO MARIA CONCEPCION. Secretario:FERNANDEZ ARMESTO JORGE. Co.De.Ma.So: VALCARCE VALCARCE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1230, L 1230, F 82,S 8, H PO 7236, I/A 88 (28.08.09).