Actos BORME de Trasur Sa
05 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALMINA AUTOMOCION SOCIEDAD ANONIMA;NITA SL. Revocaciones. Apoderado: LANCHALANCHA JOSE MARIA;LANCHA LANCHA JOSE MARIA. Apo.Sol.: ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA. Apo.Man.Soli:MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ESCRIBANO DEL CASTILLO CLARA MARIA;ZAMBRANO SANCHEZ MANUELA.Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO;BAUTISTA PEREZ RAMON MANUEL;BORRASMARTIN JOSE MARIA. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 6542 , F 47, S 8, H SE 9788, I/A 65 (27.12.22).
22 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6542 , F 47, S 8, H SE 9788, I/A 64(14.11.22).
03 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 6542 , F 46, S 8, H SE 9788, I/A 62(26.01.21).
28 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 45, S 8, H SE 9788, I/A 61 (17.12.20).
15 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: RIOJA MIGUEZ JOSE LUIS;RIOJA MIGUEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZRODRIGUEZ PABLO. Otros conceptos: REVOCADOS TODOS los poderes conferidos por la sociedad a favor de don José LuisRioja Míguez, tanto los inscritos, como los posibles otorgados y no inscritos.- Datos registrales. T 6542 , F 44, S 8, H SE 9788, I/A 60( 3.12.20).
14 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BAUTISTA PEREZ RAMON MANUEL. Datos registrales. T 6542 , F 44, S 8, H SE 9788, I/A 59 (3.12.20).
24 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: RIOJA MIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 6542 , F 43, S 8, H SE 9788, I/A 58 (27.03.20).
27 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 42, S 8, H SE 9788, I/A 57 (19.12.19).
20 de Agosto de 2018Declaración de unipersonalidad. Socio único: COMERCIAL AUTOTRACTOR SA. Datos registrales. T 6542 , F 42, S 8, H SE9788, I/A 56 ( 8.08.18).
18 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMAN MANUEL;ESCRIBANO IVISON JOSEMARIA;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;VILLAGRAN NUÑEZ JUAN BOSCO;DELGADO DE COS CHOZASALFREDO;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO;OSBORNE BORES EDUARDO;ALVEAR ALMUNIA CRISTOBAL;MARTINEZMEJIAS LAFFITTE JOSE JOAQUIN. Presidente: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Vicepresid.: ESCRIBANOIVISON JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMAN MANUEL;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CIDJOSE JOAQUIN;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO. SecreNoConsj: MORA CARAZO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm.Solid.: COMERCIAL AUTOTRACTOR SA;NITA SL. Modificaciones estatutarias. 1 al 25. Modificación Estatutos.-. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Ampliacion del objetosocial. La adquisición, enajenación de toda clase de bienes, incluidas las fincas rústicas y urbanas, y en consecuencia, comprar,adquirir, o por cualquier otro medio, poseer, administrar, pignorar, hipotecar, vender o disponer de cualquier forma, y en generalnegociar con productos, mercancías, artículos d. Datos registrales. T 4251 , F 207, S 8, H SE 9788, I/A 53 ( 9.05.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ESCRIBANO DEL CASTILLO CLARA MARIA;ZAMBRANOSANCHEZ MANUELA. Datos registrales. T 6542 , F 41, S 8, H SE 9788, I/A 54 ( 9.05.18).
Nombramientos. Apoderado: RIOJA MIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 6542 , F 41, S 8, H SE 9788, I/A 55 (10.05.18).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 4251 , F 207, S 8, H SE 9788, I/A 52 (3.05.18).
22 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: COSTILLA PURO ANGEL;SUAREZ ALMAYONES ANTONIO;VARELA ARRECIADOALEJANDRO;ALCAZAR GEA JOSE;COSTILLA PURO ANGEL;CRISTOBAL DE ALVEAR ZAMBRANO;GARCIA NIETOFRANCISCO;COSTILLA PURO ANGEL;VENTURA CASTELLO DIAZ. Apo.Manc.: JUAN ALVAREZ GORDON;VENTURA CASTELLODIAZ;DELGADO COS CHOZAS ALFREDO;LANCHA LANCHA JOSE MARIA. Apoderado: RAFAEL MARIA GARCIAALVEAR;VARELA GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO. Apo.Manc.: ESCRIBANO CASTILLO CLARAMARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;COSTILLAPURO ANGEL;COSTILLA PURO ANGEL;LANCHA LANCHA JOSE MARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;ALVEARALMUNIA GUADALUPE;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER. Apo.Sol.: MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR
25 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: RIOJA MIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4251 , F 206, S 8, H SE 9788, I/A 50 (18.05.15).
07 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR ALMUNIAGUADALUPE. Datos registrales. T 4251 , F 205, S 8, H SE 9788, I/A 49 (26.06.14).
05 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 4º: Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA DE SUEMINENCIA 26 (SEVILLA). Datos registrales. T 4251 , F 205, S 8, H SE 9788, I/A 48 (24.02.14).
12 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO;NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO. Otros conceptos: La Sociedad REVOCA elPODER NO INSCRITO, conferido a favor de DON ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ, en virtud de escritura autorizada en Sevilla, el día 3de enero de 2.006, por el Notario Don Joaquín Serrano Valverde, bajo el número 12 de su protocolo.- Datos registrales. T 4251 , F205, S 8, H SE 9788, I/A 47 (29.08.13).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;LANCHA LANCHA JOSE MARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARAMARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 4251 , F 204, S 8, H SE9788, I/A 46 ( 8.08.13).
31 de Mayo de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL;VILLAGRAN DECARDENAS MANUEL;ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;DELGADO DECOS CHOZAS ALFREDO;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO;YBARRA OSBORNE PELAYO;OSBORNE BORESEDUARDO;ALVEAR ALMUNIA CRISTOBAL. Cons.Del.Sol: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Presidente:ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Vicepresid.: ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: VILLAGRANDE CARDENAS MANUEL;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO.Nombramientos. SecreNoConsj: MORA CARAZO JUAN CARLOS. Consejero: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMANMANUEL;ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;VILLAGRAN NUÑEZ JUANBOSCO;DELGADO DE COS CHOZAS ALFREDO;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO;OSBORNE BORES EDUARDO;ALVEARALMUNIA CRISTOBAL;MARTINEZ MEJIAS LAFFITTE JOSE JOAQUIN. Presidente: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMANMANUEL. Vicepresid.: ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: ROCA DE TOGORES PEREZ DE GUZMANMANUEL;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO. Datos registrales. T 4251, F 203, S 8, H SE 9788, I/A 45 (22.05.13).
23 de Octubre de 2012Ampliación de capital. Suscrito: 300.510,00 Euros. Desembolsado: 300.510,00 Euros. Resultante Suscrito: 450.765,00 Euros.Resultante Desembolsado: 450.765,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 4251 , F 203, S 8, H SE 9788, I/A 44 ( 8.10.12).
17 de Octubre de 2012Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 4251 , F 202, S 8, H SE 9788, I/A 42 ( 4.10.12).
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 4251 , F 202, S 8, H SE 9788, I/A 43 ( 4.10.12).