Buscador CIF Logo

Actos BORME Trea Asset Management Sgiic Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Trea Asset Management Sgiic Sa

Actos BORME Trea Asset Management Sgiic Sa - A64472681

Tenemos registrados 44 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Trea Asset Management Sgiic Sa con CIF A64472681

馃敊 Perfil de Trea Asset Management Sgiic Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Trea Asset Management Sgiic Sa

14 de Diciembre de 2021
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 36577 , F 177, S 8, H M 656662, I/A 34 ( 3.12.21).

02 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: JAQUOTOT HERRANZ MARIA-DOLORES;GREGORIO MERINO ALFONSO. Nombramientos. Apo.Sol.:EZQUIAGA FERNANDEZ PEDRO. Datos registrales. T 36577 , F 177, S 8, H M 656662, I/A 33 (25.11.21).

09 de Agosto de 2021
Fe de erratas: Se public贸 por error en la incripci贸n 32陋 el domicilio social, siendo el correcto CALLE JOSE ORTEGA Y GASSETNUMERO 20 DE MADRID. Datos registrales. T 36577 , F 176, S 8, H M 656662, I/A 32 ( 2.07.21).

09 de Julio de 2021
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 28062021 (MADRID). Datos registrales. T 36577 , F 176, S 8, H M656662, I/A 32 ( 2.07.21).

10 de Febrero de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 31潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 36577 , F176, S 8, H M 656662, I/A 31 ( 3.02.21).

28 de Enero de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.650.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.891.964,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificaci贸n de los art铆culos 6潞 y 7潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 36577 , F175, S 8, H M 656662, I/A 30 (21.01.21).

29 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Cons.NO Ejec: ACHIRICA ORTEGA RODRIGO. Nombramientos. Con.Ind.: AGUILAR FERNANDEZHONTORIA EDUARDO. Datos registrales. T 36577 , F 175, S 8, H M 656662, I/A 29 (22.09.20).

28 de Julio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: BORRAS CHIA JOAN. Datos registrales. T 36577 , F 174, S 8, H M 656662, I/A 27 (21.07.20).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36577 , F 175, S 8, H M 656662, I/A 28 (21.07.20).

27 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: PEREZ-RIU PEDRO. Datos registrales. T 36577 , F 173, S 8, H M 656662, I/A 25 (20.05.20).

Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: ACHIRICA ORTEGA RODRIGO. Nombramientos. Cons.NO Ejec: ACHIRICA ORTEGA RODRIGO.Con.Ind.: GRAU MONJO MERCEDES. Datos registrales. T 36577 , F 174, S 8, H M 656662, I/A 26 (20.05.20).

27 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: CARULLA TIGERIN XAVIER;BONET GOMEZ MARIO. Datos registrales. T 36577 , F 173, S 8, H M656662, I/A 24 (20.03.20).

10 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Vicepresid.: GONZALEZ DE BETOLAZAGARCIA ROBERTO RAMON. Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON.Nombramientos. PresEjecutiv: TUSQUETS TRIAS DE BES CARLOS. Datos registrales. T 36577 , F 173, S 8, H M 656662, I/A 23 (3.03.20).

21 de Febrero de 2020
Nombramientos. Con.Ind.: ACHIRICA ORTEGA RODRIGO. Datos registrales. T 36577 , F 172, S 8, H M 656662, I/A 22 (14.02.20).

13 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DOMENECH JOAQUIM;GLADSTONES JAVALOYES DAVID. Datos registrales. T 36577, F 172, S 8, H M 656662, I/A 21 ( 6.11.19).

30 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: RIPOLLES DE LA PE脩A EDUARDO. Datos registrales. T 36577 , F 172, S 8, H M 656662, I/A 20(23.09.19).

20 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Vicepresid.: GONZALEZ DE BETOLAZAGARCIA ROBERTO RAMON. Datos registrales. T 36577 , F 171, S 8, H M 656662, I/A 19 (13.09.19).

05 de Septiembre de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.979.536,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.541.964,00 Euros. Datos registrales. T36577 , F 171, S 8, H M 656662, I/A 18 (29.08.19).

21 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: SALMERON MIR DANIEL. Datos registrales. T 36577 , F 171, S 8, H M 656662, I/A 17 (14.06.19).

03 de Junio de 2019
Reelecciones. Consejero: TUSQUETS TRIAS DE BES CARLOS JAVIER. Presidente: TUSQUETS TRIAS DE BES CARLOS JAVIER.Datos registrales. T 36577 , F 170, S 8, H M 656662, I/A 16 (27.05.19).

29 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: ORIA VILLEGAS IRATXE. Datos registrales. T 36577 , F 170, S 8, H M 656662, I/A 14 (22.04.19).

Nombramientos. Apoderado: BELMONTE MONTORO FERRAN. Datos registrales. T 36577 , F 170, S 8, H M 656662, I/A 15(22.04.19).

01 de Febrero de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 31潞 DE LOS ESTATUTOS. . Datos registrales. T 36577 , F 169, S8, H M 656662, I/A 13 (25.01.19).

10 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: BRUN LOZANO XAVIER. Datos registrales. T 36577 , F 169, S 8, H M 656662, I/A 12 ( 3.10.18).

04 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: MORATONA MONTOYO PEDRO. Datos registrales. T 36577 , F 169, S 8, H M 656662, I/A 11(27.09.18).

24 de Septiembre de 2018
Modificaciones estatutarias. 3. Duraci贸n de la sociedad. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.treaam.com. Datos registrales. T 36577 , F 168, S 8, H M 656662, I/A 10 (14.09.18).

20 de Abril de 2018
Nombramientos. Con.Ind.: SOLER ALBERTI JOSEP. Datos registrales. T 36577 , F 168, S 8, H M 656662, I/A 9 (13.04.18).

08 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apoderado: VILLOSLADA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL;MANSA ALAVEDRA XAVIER. Datos registrales. T 36577, F 168, S 8, H M 656662, I/A 8 ( 1.03.18).

16 de Febrero de 2018
Nombramientos. Vicepresid.: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Datos registrales. T 36577 , F 167, S 8, HM 656662, I/A 6 ( 9.02.18).

Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 36577 , F 168, S 8, H M 656662, I/A 7 ( 9.02.18).

08 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: JAQUOTOT HERRANZ MARIA-DOLORES;GREGORIO MERINO ALFONSO. Datos registrales. T36577 , F 166, S 8, H M 656662, I/A 4 (31.01.18).

Nombramientos. Apoderado: GLADSTONES JAVALOYES DAVID. Datos registrales. T 36577 , F 167, S 8, H M 656662, I/A 5 (1.02.18).

07 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-LIZ CORBELLA SONIA. Datos registrales. T 36577 , F 166, S 8, H M 656662, I/A 3(31.01.18).

22 de Noviembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 66 - 5陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36577 , F 166, S 8, H M 656662, I/A 2(15.11.17).

18 de Septiembre de 2017
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 17.000.000,00 Euros. Desembolsado: 17.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.521.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 17.521.500,00 Euros. Datos registrales. T 44176 , F 150, S 8, H B 342646, I/A 31 ( 7.09.17).

13 de Julio de 2017
Revocaciones. APODERAD.SOL: TUSQUETS TRIAS DE BES CARLOS. APOD.SOL/MAN: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIAROBERTO RAMON;MU脩OZ SU脩E ANTONIO;CARDIL BAUTISTA RAMON;FERNANDEZ DOMENECH JOAQUIM;ZAPLANA MACIASDANIEL. APODERAD.SOL: ROHIT GAJENDRAGADKAR;RIVIERE REYNOSO LUIS. Nombramientos. APOD.SOL/MAN:TUSQUETS TRIAS DE BES CARLOS;GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON;MU脩OZ SU脩E ANTONIO;CARDILBAUTISTA RAMON;LOPEZ MARTINEZ RICARDO;RIPOLLES DE LA PE脩A EDUARDO. APODERAD.SOL: FERNANDEZDOMENECH JOAQUIM;ZAPLANA MACIAS DANIEL;BONET GOMEZ MARIO;ORIA VILLEGAS IRATXE. Datos registrales. T 44176 ,F 148, S 8, H B 342646, I/A 30 ( 5.07.17).

16 de Marzo de 2017
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: TEAM & WORK 5000 SL. Datos registrales. T44176 , F 148, S 8, H B 342646, I/A 29 ( 7.03.17).

13 de Enero de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44176 , F 148, S 8, H B342646, I/A 28 ( 4.01.17).

13 de Octubre de 2016
Revocaciones. APODERAD.SOL: TUSQUETS TRIAS DE BES JUAN PABLO. Nombramientos. APODERAD.SOL: TORIBIOGONZALEZ ANTONIO. Datos registrales. T 44176 , F 147, S 8, H B 342646, I/A 27 ( 4.10.16).

09 de Junio de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: IZQUIERDO CARDENAS ALEX;ALLAH GARRETA OMAR KHER;CARULLA TIGERIN XAVIER.Datos registrales. T 44176 , F 147, S 8, H B 342646, I/A 26 ( 1.06.16).

10 de Marzo de 2016
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 44176 , F 147, S 8, H B 342646, I/A 25 ( 2.03.16).

09 de Diciembre de 2015
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON;CARDIL BAUTISTA RAMON.APODERADO: CARDIL BAUTISTA RAMON. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTORAMON;MU脩OZ SU脩E ANTONIO;CARDIL BAUTISTA RAMON;FERNANDEZ DOMENECH JOAQUIM;ZAPLANA MACIAS DANIEL.APODERAD.SOL: TUSQUETS TRIAS DE BES JUAN PABLO;GOMEZ AMIGO ASCENSION;VILLOSLADA RODRIGUEZ MIGUELANGEL;MORATONA MONTOYO PEDRO;MANSA ALAVEDRA XAVIER;ROHIT GAJENDRAGADKAR;RIVIERE REYNOSOLUIS;TUSQUETS BATLLE POL;ARMENGOL FREIXAS JORDI;SALMERON MIR DANIEL;GIL FALCON RICARDO. Datos

Revocaciones. CONSEJERO: TUSQUETS TRIAS DE BES JUAN PABLO. Nombramientos. CONSEJERO: MU脩OZ SU脩EANTONIO. Datos registrales. T 44176 , F 147, S 8, H B 342646, I/A 24 (25.11.15).

31 de Agosto de 2015
Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA INS. 21 EN CUANTO AL REDACTADO DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 44176 , F 145, S 8, H B 342646, I/A 22 (19.08.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n