Buscador CIF Logo

Actos BORME Trench & Pipes Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Trench & Pipes Sl

Actos BORME Trench & Pipes Sl - B65382574

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Trench & Pipes Sl con CIF B65382574

馃敊 Perfil de Trench & Pipes Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Trench & Pipes Sl

29 de Junio de 2017
Revocaciones. ADM.CONCURS.: FORNER BELTRAN OLGA. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 603/2015, AUTO FIRME DE FECHA 29/05/2017, CONCLUSION DEL CONCURSODE LA SOCIEDAD. Extinci贸n. Datos registrales. T 42046 , F 24, S 8, H B 400257, I/A 9 (23.06.17).

11 de Abril de 2016
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 603/2015, AUTOFIRME DE FECHA 28/01/2016, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION. Datos registrales. T42046 , F 24, S 8, H B 400257, I/A 8 ( 4.04.16).

23 de Octubre de 2015
Revocaciones. ADM.UNICO: VALLS GOMEZ JORDI. Nombramientos. ADM.CONCURS.: FORNER BELTRAN OLGA. Otrosconceptos: JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 603/2015,AUTO DE FECHA 16/07/2015,RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 21/07/2015,FIRMES, DECLARACION DE CONCURSOVOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 42046 , F 23, S 8, H B400257, I/A 7 (16.10.15).

26 de Diciembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 32.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 71.677,00 Euros. Cambio de domicilio social. AV DE XILE,NUMERO 36, LOCAL A (BARCELONA). Cambio de objeto social. AMPLIAR EN: "(CNAE 4399) ASI COMO LAS ACTIVIDADESPROPIAS DE MONTAJE, REPARACION, MANTENIMIENTO, REVISION E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS, TELEFONIA,CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO, AGUA Y GAS". Datos registrales. T 42046 , F 22, S 8, H B 400257, I/A 6 (18.12.14).

18 de Diciembre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 36.471,00 Euros. Resultante Suscrito: 39.477,00 Euros. Datos registrales. T 42046 , F 22, S 8, H B400257, I/A 5 (10.12.13).

22 de Agosto de 2012
Nombramientos. APODERADO: CHOPO PUERTOLLANO MERCEDES. Datos registrales. T 42046 , F 21, S 8, H B 400257, I/A 4 (9.08.12).

10 de Agosto de 2012
Revocaciones. ADMINISTR.: CHOPO PUERTOLLANO MERCEDES. Nombramientos. ADM.UNICO: VALLS GOMEZ JORDI.Cambio de domicilio social. CL PISUERGA 9 LOCAL 6 (BARCELONA). Datos registrales. T 42046 , F 20, S 8, H B 400257, I/A 3(26.07.12).

19 de Junio de 2012
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: VAZQUEZ MONTERO JOSE. Datos registrales. T 42046 , F 20, S 8, H B 400257, I/A 2 ( 6.06.12).

13 de Agosto de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.07.10. Objeto social:CONSTRUCCION,ZANJAS,URBANIZACIONES,CANALIZACIONES,ALCANTARILLADO,DESVIOS DE SERVICIO Y OBRA CIVIL ENGENERAL. Domicilio: AV MADRID,63-73 ESC.A P.7 PTA.4 (BARCELONA). Capital: 3.006,00 Euros. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: CHOPO PUERTOLLANO MERCEDES;VAZQUEZ MONTERO JOSE. Datos registrales. T 42046 , F 18, S 8, H B400257, I/A 1 ( 3.08.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n