Actos BORME de Tres60 Servicios Audiovisuales Sl
23 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MEDIAPRODUCCION SL;ROURES LLOP JAUME. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA.
21 de Noviembre de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUP MEDIAPRO SL. Datos registrales. T 38380 , F 152, S 8, H M475759, I/A 49 (14.11.23).
12 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: VAZQUEZ CASTELLANOS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: BAS LOSTAO PABLO.Datos registrales. T 38380 , F 151, S 8, H M 475759, I/A 48 ( 3.04.23).
08 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SISTERNAS TUSELL MARIA. Datos registrales. T 38380 , F 151, S 8, H M 475759, I/A 47 ( 1.02.23).
05 de Octubre de 2022Otros conceptos: El socio único de la sociedad de esta hoja, IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SAU, con CIF A64200744, ha pasadoa denominarse GRUP MEDIAPRO SAU en virtud de escritura autorizada por el Notario D. Ramón García-Torrent Carballo el día 6 dejulio de 2022 con el número 4250. Datos registrales. T 38380 , F 151, S 8, H M 475759, I/A 45M (28.09.22).
31 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: RIERA FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 38380 , F 151, S 8, H M 475759, I/A 46 (24.03.22).
20 de Octubre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SA. Datos registrales. T 38380 ,F 150, S 8, H M 475759, I/A 45 (13.10.21).
15 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: CARDENAL CARRO MIGUEL. Datos registrales. T 38380 , F 149, S 8, H M 475759, I/A 44 ( 8.03.21).
19 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ENSESA VIÑAS JOSEP;KIRPAL ADRIAN. Datos registrales. T 38380 , F 147, S 8, H M 475759, I/A43 (12.08.20).
24 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ DE GAUNA PELAEZ JUAN;FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO;ABANS IGLESIAS EVAMARIA;RUBIO GARCIA JOSE LUIS;FERNANDEZ TALLON MARI CARMEN;SOLER CANTALOSELLA JORDI;MENDEZ ZORI JAVIERMARIA;DIEZ GAMBOA IRANTZU;DE LA FUENTE RUZ FRANCISCO JOSE;JIMENEZ GOMEZ MARIA PILAR;VIA MELICHALBERTO;FERNANDEZ ESPESO LAURA;D'AMATO JOSE NICOLAS;ANGLADA DORDAL CARME;ANGUERA ARMENGOLLAURA;SISTERNAS TUSELL MARIA;PANIGHI ALEJANDRA CLAUDIA;VAZQUEZ CASTELLANOS MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 38380 , F 144, S 8, H M 475759, I/A 42 (17.01.20).
16 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROURES LLOP JAUME;BENET FERRAN JOSEP MARIA. Apo.Manc.: RUIZ DE GAUNA PELAEZJUAN;ABANS IGLESIAS EVA MARIA. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL;MATEU DE LA PEÑA PEDRO.Datos registrales. T 38380 , F 142, S 8, H M 475759, I/A 41 ( 9.04.19).
12 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA. Adm. Unico: MEDIAPRODUCCION SL. Nombramientos.Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA. Adm. Solid.: MEDIAPRODUCCION SL;ROURES LLOP JAUME. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 31524 , F 99, S 8, H M475759, I/A 40 ( 5.03.19).
10 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ OCAÑA MARIA VICENTA. Apoderado: PEREZ OCAÑA MARIA VICENTA;PEREZ OCAÑA MARIAVICENTA. Apo.Man.Soli: GARCIA PEREZ JUAN JOSE. Apoderado: COBO BUXENS ALVARO. Nombramientos. Apoderado:GARCIA PEREZ JUAN JOSE;MENENDEZ DEL CAMPO IGNACIO;PEREZ OCAÑA MARIA VICENTA;RUBIO ALCARRIA MARIAENCARNACION. Datos registrales. T 31524 , F 97, S 8, H M 475759, I/A 39 ( 3.10.18).
22 de Marzo de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MEDIAPRODUCCION SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BERGELSAINZ DE BARANDA JAIME;REAÑO COSTALES LEOPOLDO. Vicepresid.: BERGEL SAINZ DE BARANDA JAIME. Consejero: DEPARIAS MORA-FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA. Presidente: REAÑO COSTALES LEOPOLDO. SecreNoConsj: SANCHEZBLEDA GARCIA PILAR. Nombramientos. Adm. Unico: MEDIAPRODUCCION SL. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T31524 , F 96, S 8, H M 475759, I/A 38 (15.03.18).
04 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: VICENTE TRUJILLO OSCAR. Datos registrales. T 31524 , F 96, S 8, H M 475759, I/A 37 (24.11.17).
03 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ RUIZ ARTURO. Datos registrales. T 31524 , F 96, S 8, H M 475759, I/A 36 (25.10.17).
21 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: COBO BUXENS ALVARO. Datos registrales. T 31524 , F 93, S 8, H M 475759, I/A 35 (13.07.17).
09 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: RIER HENRIQUEZ JUAN ADELTO. Apoderado: RIER HENRIQUEZ JUAN ADELTO. Datosregistrales. T 31524 , F 93, S 8, H M 475759, I/A 34 (28.04.17).
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Presidente: REAÑO COSTALES LEOPOLDO. Datos registrales. T 31524 , F 92, S 8, H M 475759, I/A 33(17.03.17).
09 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ALTA BUSINESS SERVEIS SL. Presidente: ALTA BUSINESS SERVEIS SL. Representan: BIRULESBERTRAN ANNA MARIA. Nombramientos. Consejero: DE PARIAS MORA-FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA. Datosregistrales. T 31524 , F 92, S 8, H M 475759, I/A 32 ( 1.03.17).
02 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: RIER HENRIQUEZ JUAN ADELTO. Con.Delegado: RIER HENRIQUEZ JUAN ADELTO. Datosregistrales. T 31524 , F 92, S 8, H M 475759, I/A 31 (23.11.16).
21 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PEREZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 31524 , F 89, S 8, H M 475759, I/A 30(12.09.16).
01 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ OCAÑA MARIA VICENTA. Datos registrales. T 31524 , F 88, S 8, H M 475759, I/A 29(24.05.16).
30 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: VELASCO DE ALBA FERNANDO. Datos registrales. T 31524 , F 88, S 8, H M 475759, I/A 28 (22.12.15).
11 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 31524 , F 88, S 8, H M 475759, I/A 27 ( 2.12.15).
25 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUILERA LUCIO VILLEGAS MARIA BELEN. Apoderado: AGUILERA LUCIO VILLEGAS MARIABELEN. Datos registrales. T 31524 , F 85, S 8, H M 475759, I/A 25 (17.06.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ RUIZ ARTURO. Datos registrales. T 31524 , F 85, S 8, H M 475759, I/A 26(17.06.15).
07 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: VICENTE TRUJILLO OSCAR. Datos registrales. T 31524 , F 85, S 8, H M 475759, I/A 24 (28.04.15).
24 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ SANTOS FRANCISCO. Datos registrales. T 31524 , F 84, S 8, H M 475759, I/A 23 (16.03.15).
05 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: AGUILERA LUCIO VILLEGAS MARIA BELEN;RIER HENRIQUEZ JUAN ADELTO;SANCHEZ SANTOSFRANCISCO;VELASCO DE ALBA FERNANDO;PEREZ OCAÑA MARIA VICENTA. Datos registrales. T 31524 , F 84, S 8, H M475759, I/A 22 (25.07.14).
17 de Julio de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31524 , F 84, S 8, H M 475759, I/A 21 (10.07.14).
07 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUE I CAMPS JOSEP;GARCIA-DURAN BAYO MANUEL. Presidente: PIQUE I CAMPS JOSEP.MeCoNoRe: PIQUE I CAMPS JOSEP. Nombramientos. Consejero: ALTA BUSINESS SERVEIS SL. Presidente: ALTA BUSINESSSERVEIS SL. Representan: BIRULES BERTRAN ANNA MARIA. Vicepresid.: BERGEL SAINZ DE BARANDA JAIME. Datosregistrales. T 31524 , F 83, S 8, H M 475759, I/A 20 (30.06.14).
04 de Julio de 2014Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31524 , F 83, S 8, H M 475759, I/A 19 (26.06.14).