Actos BORME de Tresca Ingenieria Sa
23 de Enero de 2023Reelecciones. Adm. Unico: CARRO DE LORENZO FRANCISCO-JULIAN. Datos registrales. T 1316 , F 151, S 8, H LE 12032, I/A36 (16.01.23).
09 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PARRA RAUL. Datos registrales. T 1316 , F 151, S 8, H LE 12032, I/A 35 ( 2.06.22).
03 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 1316 , F 150, S 8, H LE 12032, I/A 34(27.07.21).
01 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ CARPINTERO MARINA. Datos registrales. T 1316 , F 150, S 8, H LE 12032, I/A 33(25.06.21).
05 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ CARPINTERO MARINA. Datos registrales. T 1316 , F 149, S 8, H LE 12032, I/A 31(26.03.21).
Nombramientos. Apoderado: BADIOLA GONZALEZ RUBEN. Datos registrales. T 1316 , F 149, S 8, H LE 12032, I/A 32 (26.03.21).
08 de Mayo de 2018Revocaciones. Auditor: AUDITAS AUDITORES ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 1316 , F 148, S 8, H LE 12032, I/A 30(30.04.18).
01 de Agosto de 2017Ampliación de capital. Suscrito: 165.600,00 Euros. Desembolsado: 165.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 303.600,00 Euros.Resultante Desembolsado: 303.600,00 Euros. Datos registrales. T 1316 , F 148, S 8, H LE 12032, I/A 29 (26.07.17).
09 de Mayo de 2017Reelecciones. Adm. Unico: CARRO DE LORENZO FRANCISCO-JULIAN. Datos registrales. T 1316 , F 147, S 8, H LE 12032, I/A25 (28.04.17).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PARRA RAUL. Datos registrales. T 1316 , F 147, S 8, H LE 12032, I/A 26 (28.04.17).
Nombramientos. Auditor: AUDITAS AUDITORES ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 1316 , F 147, S 8, H LE 12032, I/A 27(28.04.17).
Nombramientos. Apoderado: BADIOLA GONZALEZ RUBEN. Datos registrales. T 1316 , F 148, S 8, H LE 12032, I/A 28 (28.04.17).
03 de Enero de 2017Otros conceptos: Establecimiento del carácter retribuido del cargo de Administrador, y en consecuencia, modificación del Artículo 18ºde los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio social. C/ JULIA MORROS S/N - EDIFICIO USOS MULTIPLES 2ª P (LEON). Datosregistrales. T 926 , F 151, S 8, H LE 12032, I/A 24 (27.12.16).
19 de Julio de 2016Revocaciones. Apoderado: DEL RIO ALIJA EVA. Datos registrales. T 926 , F 151, S 8, H LE 12032, I/A 23 (12.07.16).
19 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ CARPINTERO MARINA. Datos registrales. T 926 , F 150, S 8, H LE 12032, I/A 22(11.05.16).
22 de Octubre de 2014Cambio de domicilio social. C/ GREGORIO PEREZ DE MARIA 2 1º N (LEON). Datos registrales. T 926 , F 150, S 8, H LE 12032,I/A 21 (15.10.14).
04 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ CARPINTERO MARINA. Datos registrales. T 926 , F 150, S 8, H LE 12032, I/A 20(28.05.14).
24 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: BADIOLA GONZALEZ RUBEN. Datos registrales. T 926 , F 149, S 8, H LE 12032, I/A 18 (17.04.13).
Nombramientos. Apoderado: DEL RIO ALIJA EVA. Datos registrales. T 926 , F 149, S 8, H LE 12032, I/A 19 (17.04.13).
12 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: GAYOSO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO. Datos registrales. T 926 , F 149, S 8, H LE 12032, I/A17 (30.03.12).
13 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: GAYOSO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO. Datos registrales. T 926 , F 113, S 8, H LE 12032, I/A11 ( 5.04.11).
Revocaciones. Apoderado: DE LA IGLESIA ALONSO MARIA DE LA ALMUDENA. Datos registrales. T 926 , F 113, S 8, H LE12032, I/A 12 ( 5.04.11).
Nombramientos. Apoderado: GAYOSO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO. Datos registrales. T 926 , F 113, S 8, H LE 12032, I/A13 ( 5.04.11).
Nombramientos. Apoderado: DEL RIO ALIJA EVA. Datos registrales. T 926 , F 148, S 8, H LE 12032, I/A 14 ( 5.04.11).
Nombramientos. Apoderado: BADIOLA GONZALEZ RUBEN. Datos registrales. T 926 , F 148, S 8, H LE 12032, I/A 15 ( 5.04.11).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARRO DE LORENZO FRANCISCO JULIAN. Nombramientos. Adm. Unico: CARRO DELORENZO FRANCISCO JULIAN. Datos registrales. T 926 , F 149, S 8, H LE 12032, I/A 16 ( 5.04.11).