Buscador CIF Logo

Actos BORME Triocar Comercial Del Automovil Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Triocar Comercial Del Automovil Sociedad Limitada

Actos BORME Triocar Comercial Del Automovil Sociedad Limitada - B24323057

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Triocar Comercial Del Automovil Sociedad Limitada con CIF B24323057

馃敊 Perfil de Triocar Comercial Del Automovil Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Triocar Comercial Del Automovil Sociedad Limitada

27 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SOLIS PAULA. Datos registrales. T 25749 , F 189, S 8, H M 317668, I/A 45 (19.12.23).

09 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 25749 , F 189, S 8, H M 317668, I/A 44 (30.11.22).

12 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BANIELLO IRMA;MENENDEZ VELASCO CONCEPCION;TADEO GARCIA SARA. Datosregistrales. T 25749 , F 189, S 8, H M 317668, I/A 43 ( 5.09.22).

07 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: DIEZ VALDES MIGUEL. Datos registrales. T 25749 , F 188, S 8, H M 317668, I/A 42 (30.06.22).

12 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 25749 , F 188, S 8, H M 317668, I/A 41( 5.02.21).

02 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 25749 , F 188, S 8, H M 317668, I/A 40 (27.05.20).

07 de Abril de 2020
Nombramientos. Apoderado: DIEZ VALDES MIGUEL. Datos registrales. T 25749 , F 188, S 8, H M 317668, I/A 39 (31.03.20).

19 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSOPURIFICACION. Reelecciones. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T25749 , F 187, S 8, H M 317668, I/A 38 (12.02.20).

24 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 25749 , F 187, S 8, H M 317668, I/A 37(16.01.18).

16 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: DIAZ FERNANDEZ JOSE JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.: MALLO NIEVES VICTOR. Datosregistrales. T 25749 , F 187, S 8, H M 317668, I/A 36 ( 9.02.16).

04 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: DIAZ FERNANDEZ JOSE JAVIER;CUERVO FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 25749 , F186, S 8, H M 317668, I/A 35 (26.01.16).

13 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION;VERDIN BOUZA PABLO. Datos registrales. T 25749 , F186, S 8, H M 317668, I/A 34 ( 5.03.15).

05 de Febrero de 2015
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 25749 , F 186, S 8, H M 317668, I/A33 (29.01.15).

23 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 25749 , F 185, S 8, H M 317668, I/A 32(16.07.14).

04 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Presidente: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Consejero:MARTINEZ ALONSO ROSA. Vicepresid.: MARTINEZ ALONSO ROSA. Consejero: GARCIA ARENAS MANUEL. Vicepresid.: GARCIAARENAS MANUEL. Consejero: MARTINEZ ALONSO ALBERTO;VAZQUEZ ORDAS CAMILO JOSE. Co.De.Ma.So: MARTINEZALONSO ROSA. Cons.Del.Sol: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Secretario: MARTINEZ ALONSO ROSA. Cons.Del.Man: MARTINEZALONSO ALBERTO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZALONSO ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores solidarios. Otros conceptos: La sociedad de esta hoja queda con car谩cter unipersonal, siendo su socio 煤nico"RESNOVA, S.L.", que adquiere las 煤ltimas trescientas doce (312) participaciones sociales, n煤meros "2.501" al "2.812", ambosinclusive, por compra seg煤n escritura autorizada por el Notario de Le贸n, Don Santiago-Alfonso G. Datos registrales. T 25749 , F 185,S 8, H M 317668, I/A 31 (26.06.14).

06 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: VAZQUEZ ORDAS CAMILO JOSE. Co.De.Ma.So: GARCIA ARENAS MANUEL. Nombramientos.Secretario: MARTINEZ ALONSO ROSA. Cons.Del.Man: MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 25749 , F 184, S 8, HM 317668, I/A 30 (26.02.14).

04 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO.Presidente: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Consejero: MARTINEZ ALONSO ROSA. Vicepresid.: MARTINEZ ALONSO ROSA.Consejero: GARCIA ARENAS MANUEL. Vicepresid.: GARCIA ARENAS MANUEL. Consejero: MARTINEZ ALONSOALBERTO;VAZQUEZ ORDAS CAMILO JOSE. Secretario: VAZQUEZ ORDAS CAMILO JOSE. Co.De.Ma.So: MARTINEZ ALONSOROSA;GARCIA ARENAS MANUEL. Cons.Del.Sol: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 25749 , F 183, S 8, H M 317668,I/A 29 (28.01.14).

03 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25749 , F 183, S 8, H M 317668, I/A 28 (24.01.14).

28 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25749 , F 183, S 8, H M 317668, I/A 27 (21.02.13).

25 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25749 , F 182, S 8, H M 317668, I/A 26 (12.01.12).

10 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: REGADERA RODRIGUEZ JUAN PABLO. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Presidente:MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Consejero: ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Vicepresid.: ALONSO GARCIA MARIAPURIFICACION. Consejero: MARTINEZ ALONSO ROSA. Co.De.Ma.So: MARTINEZ ALONSO ROSA. Consejero: MARTINEZALONSO MARIA PURIFICACION. Co.De.Ma.So: MARTINEZ ALONSO MARIA PURIFICACION. Consejero: MARTINEZ ALONSOALFREDO. Co.De.Ma.So: MARTINEZ ALONSO ALFREDO. Consejero: MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Nombramientos. Adm.Unico: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 25749 , F 182, S 8, H M 317668, I/A 24 (29.12.11).

Otros conceptos: AMPLIADO EL PODER CONFERIDO A DO脩A ROSA MARTINEZ ALONSO, MEDIANTE ESCRITURA QUECAUSO LA INSCRIPCION 22&, CON LA INCLUSION DEL APARTADO h) DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. Datos registrales.T 25749 , F 182, S 8, H M 317668, I/A 25 (29.12.11).

19 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 25749 , F 181, S 8, H M 317668, I/A 23 (2.12.11).

29 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALONSO ROSA. Datos registrales. T 25749 , F 181, S 8, H M 317668, I/A 22 (18.11.11).

23 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: CARRAGAL MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 25749 , F 181, S 8, H M 317668, I/A 21 (29.08.11).

17 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25749 , F 181, S 8, H M 317668, I/A 20 ( 3.01.11).

21 de Septiembre de 2010
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RESNOVA SL. Datos registrales. T 25749 , F 181, S 8, H M 317668, I/A 19 (9.09.10).

20 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25749 , F 180, S 8, H M 317668, I/A 18 ( 7.01.10).

14 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25749 , F 180, S 8, H M 317668, I/A 17 (30.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n