Buscador CIF Logo

Actos BORME Trouwfarma Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Trouwfarma Sa

Actos BORME Trouwfarma Sa - A78406725

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Trouwfarma Sa con CIF A78406725

馃敊 Perfil de Trouwfarma Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Trouwfarma Sa

29 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PEINADO GONZALEZ JOAQUIN;GOMEZ DE PARADA ELUA DANIEL. Disoluci贸n. Fusion.Extinci贸n. Datos registrales. T 39251 , F 68, S 8, H M 62578, I/A 79 (22.11.23).

12 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA. Datos registrales. T 39251 , F 67, S 8, H M 62578, I/A77 ( 5.05.23).

01 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39251 , F 67, S 8, H M 62578, I/A 76 (22.02.23).

22 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;RODRIGUEZ COJO RAUL. Datos registrales. T 39251 ,F 67, S 8, H M 62578, I/A 75 (15.02.23).

30 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: CARMONA BOTANA PATRICIA;CARMONA BOTANA PATRICIA. Datos registrales. T 39251 , F 66, S 8,H M 62578, I/A 74 (23.11.22).

12 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: NIETO GUTIERREZ AITANA. Apo.Sol.: NIETO GUTIERREZ AITANA. Apoderado: VAN REENENREMCO;ALVAREZ HERNANDEZ ROSA ANA;RUIZ PI脩A CARLOS;RODRIGUEZ COJO RAUL;FERNANDEZ DEL POZO MARIAPALOMA. Apo.Sol.: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ ELISA;GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;DEL CAMPOPASTOR AMALIA MARIA. Apo.Man.Soli: VAN REENEN REMCO;NIETO GUTIERREZ AITANA;VAN REENEN REMCO;NIETOGUTIERREZ AITANA. Datos registrales. T 39251 , F 66, S 8, H M 62578, I/A 73 ( 5.09.22).

04 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: PEINADO GONZALEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 39251 , F 65, S 8, H M 62578, I/A 72(27.03.22).

23 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: PEINADO GONZALEZ JOAQUIN;PLANA INIESTA ANA MARIA. Datos registrales. T 39251 , F 63, S 8,H M 62578, I/A 70 (16.03.22).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39251 , F 65, S 8, H M 62578, I/A 71 (16.03.22).

15 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VAN REENEN REMCO;NIETO GUTIERREZ AITANA. Nombramientos. Adm. Mancom.:PEINADO GONZALEZ JOAQUIN;GOMEZ DE PARADA ELUA DANIEL. Datos registrales. T 39251 , F 63, S 8, H M 62578, I/A 69 (8.03.22).

27 de Mayo de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39251 , F 62, S 8, H M 62578, I/A 68 (20.05.21).

22 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VAN REENEN REMCO;NIETO GUTIERREZ AITANA;GOMEZ DE PARADA ELUADANIEL;FOGLIATO MARIA VERONICA;DE ANCOS ARACIL MARIA ELENA;ALLOGGIA CARRILLO YIMMY BETLUI;QUINTANARODRIGUEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 39251 , F 60, S 8, H M 62578, I/A 67 (15.01.21).

21 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: FOGLIATO MARIA VERONICA;DE ANCOS ARACIL MARIA ELENA;ALLOGGIA CARRILLO YIMMYBETLUI;QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES. Apo.Man.Soli: VAN REENEN REMCO;NIETO GUTIERREZ AITANA. Apo.Sol.:DE ANCOS ARACIL MARIA ELENA;GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;DEL CAMPO PASTOR AMALIAMARIA;RODRIGUEZ COJO RAUL;FERNANDEZ PALOMO MARIA PALOMA;JUAN MONREAL ANGEL LUIS;GARCIA GARCIABEATRIZ. Datos registrales. T 39251 , F 53, S 8, H M 62578, I/A 66 (14.01.21).

02 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39251 , F 53, S 8, H M 62578, I/A 65 (25.11.19).

20 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. Consejero: NIETO GUTIERREZ AITANA;VANREENEN REMCO. Vicepresid.: VAN REENEN REMCO. SecreNoConsj: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ ELISA. Nombramientos.Adm. Mancom.: VAN REENEN REMCO;NIETO GUTIERREZ AITANA. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICANPARCIALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFUNDIENDOSE EL TEXTO INTEGRO DE LOS MISMOS.-. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 28852 , F225, S 8, H M 62578, I/A 64 (13.09.19).

28 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;DEL CAMPO PASTOR AMALIA MARIA. Datosregistrales. T 28852 , F 224, S 8, H M 62578, I/A 63 (21.03.19).

25 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 224, S 8, H M 62578, I/A 62 (17.01.19).

11 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ DE BONILLAGONZALEZ ELISA. Datos registrales. T 28852 , F 223, S 8, H M 62578, I/A 60 ( 3.07.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ ELISA. Datos registrales. T 28852 , F 224, S 8, H M 62578, I/A 61 (3.07.18).

13 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORES CANO LUIS;DE WILDT HARM. Presidente: DE WILDT HARM. Nombramientos.Consejero: BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. Consejero: NIETO GUTIERREZ AITANA. Reelecciones.SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Consejero: VAN REENEN REMCO. Vicepresid.: VAN REENEN REMCO. Datosregistrales. T 28852 , F 223, S 8, H M 62578, I/A 58 ( 6.02.18).

Revocaciones. Apoderado: FLORES CANO LUIS;FLORES CANO LUIS. Datos registrales. T 28852 , F 223, S 8, H M 62578, I/A 59( 6.02.18).

20 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 223, S 8, H M 62578, I/A 57 (12.12.17).

11 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ COJO RAUL;FERNANDEZ DEL POZO MARIA PALOMA. Datos registrales. T 28852 , F222, S 8, H M 62578, I/A 56 (29.11.17).

13 de Junio de 2017
Revocaciones. Apoderado: ARMADA CUESTA TEODORO;SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 28852 , F220, S 8, H M 62578, I/A 54 ( 5.06.17).

Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ HERNANDEZ ROSA ANA;RUIZ PI脩A CARLOS. Datos registrales. T 28852 , F 220, S 8, HM 62578, I/A 55 ( 5.06.17).

17 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 220, S 8, H M 62578, I/A 53 ( 9.01.17).

30 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 220, S 8, H M 62578, I/A 52 (21.12.15).

27 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO. Vicepresid.: SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO.Nombramientos. Consejero: VAN REENEN REMCO. Vicepresid.: VAN REENEN REMCO. Reelecciones. Consejero: FLORESCANO LUIS. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Consejero: DE WILDT HARM. Presidente: DE WILDT HARM. Datosregistrales. T 28852 , F 219, S 8, H M 62578, I/A 51 (19.11.15).

28 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: VAN REENEN REMCO. Datos registrales. T 28852 , F 217, S 8, H M 62578, I/A 50 (20.10.15).

14 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 217, S 8, H M 62578, I/A 49 ( 2.01.15).

25 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: BELTEJAR CAMPOS JESUS. Datos registrales. T 28852 , F 217, S 8, H M 62578, I/A 48 (18.09.14).

17 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Vicepresid.: TROUW NUTRITION ESPA脩A SA. Consejero: TROUWNUTRITION ESPA脩A SA. Secretario: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Representan: SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO.Nombramientos. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Consejero: SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO. Vicepresid.:SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO. Consejero: FLORES CANO LUIS. Reelecciones. Consejero: DE WILDT HARM.Presidente: DE WILDT HARM. Datos registrales. T 28852 , F 217, S 8, H M 62578, I/A 47 (10.06.14).

05 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: NIETO GUTIERREZ AITANA. Datos registrales. T 28852 , F 216, S 8, H M 62578, I/A 46 (28.05.14).

29 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: VERGEER JERRY ANTONY. Presidente: VERGEER JERRY ANTONY. Nombramientos.Consejero: DE WILDT HARM. Presidente: DE WILDT HARM. Reelecciones. Consejero: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ.Vicepresid.: TROUW NUTRITION ESPA脩A SA. Consejero: TROUW NUTRITION ESPA脩A SA. Secretario: GALLEGO LONGASESTIBALIZ. Representan: SALVADOR MARTINEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 28852 , F 216, S 8, H M 62578, I/A 45(21.05.14).

17 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARIN ANOZ JESUS MARIA;SACRISTAN HUELVES ANGEL. Datos registrales. T 28852 , F 216, S 8,H M 62578, I/A 44 ( 7.02.14).

31 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 215, S 8, H M 62578, I/A 43 (23.10.13).

12 de Agosto de 2013
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 215, S 8, H M 62578, I/A 42 ( 1.08.13).

28 de Mayo de 2013
Otros conceptos: CAMBIO DEL NOMBRE DE LA CALLE DONDE FIGURA DOMICILIADA LA SOCIEDAD, PASANDO A SER DERONDA DE LA ESTACION NUMERO 7 A RONDA DE PONIENTE NUMERO 9. Datos registrales. T 28852 , F 215, S 8, H M 62578,I/A 41 (20.05.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n