Actos BORME de Tt21 Catsud Sociedad Limitada Laboral
11 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO;ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID;ESCORIZA BENEITOJUAN JOSE;CALVET BELLOT JUAN JOSE;PITARCH ESCRICHE JORGE;PA脩ELLA GABALDA JOSE;MONTOYA MARTINEZ JOSE.Cons.Del.Sol: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Presidente: ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID. Vicepresid.: ESCORIZABENEITO JUAN JOSE. Secretario: PA脩ELLA GABALDA JOSE. Cons.Del.Sol: PITARCH ESCRICHE JORGE;PA脩ELLA GABALDAJOSE. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID. Presidente: ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID.Consejero: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Vicepresid.: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Consejero: PA脩ELLA GABALDAJOSE. Secretario: PA脩ELLA GABALDA JOSE. Consejero: PITARCH ESCRICHE JORGE. Cons.Del.Sol: PITARCH ESCRICHEJORGE;PA脩ELLA GABALDA JOSE. Otros conceptos: RECTIFICADA LA INSCRIPCION 8陋 EN CUANTO A LOS CESES YNUEVOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.- Datos registrales. T 2657 , F 194, S 8, H T 43498, I/A 9 (4.02.21).
07 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVET BELLOT JUAN JOSE. Vicepresid.: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Secretario: GARCIASOLE JUAN FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Presidente: ALVAREZ LOPEZSALVADOR DAVID. Vicepresid.: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Secretario: PA脩ELLA GABALDA JOSE. Cons.Del.Sol: PITARCHESCRICHE JORGE;PA脩ELLA GABALDA JOSE. Adaptaci贸n Ley 44/2015. Datos registrales. T 2657 , F 14, S 8, H T 43498, I/A 8(29.10.18).
07 de Diciembre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 18.166,00 Euros. Resultante Suscrito: 217.834,00 Euros. Datos registrales. T 2657 , F 14,S 8, H T 43498, I/A 7 (27.11.15).
07 de Noviembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ ULLDECONA, 21, BAJOS (ROQUETES). Datos registrales. T 2657 , F 14, S 8, H T 43498, I/A 6(31.10.14).
14 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Nombramientos. Consejero: ESCORIZA BENEITO JUANJOSE;GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO. Ampliacion del objeto social. LOCALIZACION, CARGA Y DESCARGA, REMOLQUE YTRANSPORTE POR CARRETERA DE TODA CLASEES DE MATERIALES, VEHICULOS Y MAQUINARIA.CONSOLIDACION YPREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INCLUIDOS SISTEMAS DE DESAGUES YDRAGADOS, DEMOLICIONES Y DERRIBOS DE LAS MISMAS.COMPRA VENTA DE VE. Datos registrales. T 2657 , F 13, S 8, H T43498, I/A 5 ( 2.04.14).
23 de Octubre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 236.000,00 Euros. Datos registrales. T 2657 , F 12, S 8, H T43498, I/A 4 (11.10.13).
13 de Diciembre de 2012Otros conceptos: Queda modificado el art铆culo 6潞 de los Estatutos Sociales correspondientes al capital social, en cuanto que latotalidad de las participaciones sociales en que esta dividido el mismo pasa a ser de clase laboral.- Datos registrales. T 2657 , F 11,S 8, H T 43498, I/A 3 ( 3.12.12).
13 de Abril de 2012Nombramientos. Con.Delegado: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Datos registrales. T 2657 , F 11, S 8, H T 43498, I/A 2 (2.04.12).
18 de Enero de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.12.11. Objeto social: TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA, ASI COMOSU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION I QUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL TRANSPORTE. COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE TERRENOS Y EDIFICACIONES.- Domicilio: C/ LA MASIA 1 2 4 (ROQUETES). Capital: 218.000,00 Euros.Nombramientos. Consejero: GARCIA SOLE JUAN FRANCISCO;ALVAREZ LOPEZ SALVADOR DAVID;ESCORIZA BENEITO JUANJOSE;CALVET BELLOT JUAN JOSE;PITARCH ESCRICHE JORGE;PA脩ELLA GABALDA JOSE;MONTOYA MARTINEZ JOSE.Presidente: CALVET BELLOT JUAN JOSE. Vicepresid.: ESCORIZA BENEITO JUAN JOSE. Secretario: GARCIA SOLE JUAN