Actos BORME de Tubo Sol Pe2 Sociedad Limitada
14 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3467 , F 71, S 8, H MU 70974, I/A55 ( 7.09.23).
27 de Julio de 2022Reelecciones. Consejero: NORBERT RUDOLF BACKERT. Datos registrales. T 3467 , F 71, S 8, H MU 70974, I/A 51 (19.07.22).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3467 , F 71, S 8, H MU 70974, I/A52 (19.07.22).
22 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JILLIAN FELICIA HJORDIS KANEL. Nombramientos. SecreNoConsj: SIMONA URSULAKREIENBUHL-CHRISTEN. VsecrNoConsj: JILLIAN FELICIA HJORDIS KANEL. Datos registrales. T 3467 , F 70, S 8, H MU 70974,I/A 50 (15.03.22).
21 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CHARLES MAURON. Nombramientos. Consejero: MARTIN SCHAUB. Reelecciones. Consejero:ALAIN SERGE JOURDAN;BEAT ANDRIST;HANSPETER FUCHS;MARTIN SELIG. Vicepresid.: ALAIN SERGE JOURDAN.Cons.Del.Man: ALAIN SERGE JOURDAN;BEAT ANDRIST. Datos registrales. T 3467 , F 70, S 8, H MU 70974, I/A 49 ( 8.10.21).
30 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: URS JOSEF STEINER. Datos registrales. T 3467 , F 70, S 8, H MU 70974, I/A 48 (23.08.21).
23 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MAX MERTINS;MICHAEL WENGER;MARTIN ROTH. Nombramientos. Consejero: TIZIANOBOTTINELLI. Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 23潞 de los Estatutos Sociales.- Datos registrales. T 3467 , F 69, S 8, H MU70974, I/A 47 (16.10.20).
05 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3124 , F 202, S 8, H MU 70974,I/A 46 (28.10.19).
18 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAUDE MINDER;ERICH MARTIN GEISER-WALTER. Nombramientos. Consejero: ROGERSCHEIDEGGER;MICHAEL WENGER;WALTER ERICH MARTIN GEISER. Reelecciones. Consejero: TOBIAS ANDRIST;MARTINROTH;MAX MERTINS. Presidente: TOBIAS ANDRIST. Cons.Del.Man: TOBIAS ANDRIST. Datos registrales. T 3124 , F 202, S 8, HMU 70974, I/A 44 (12.07.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: NADINE MESSER. Datos registrales. T 3124 , F 202, S 8, H MU 70974, I/A 45 (12.07.19).
10 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 3124 , F 202, S 8, H MU 70974, I/A 43 ( 2.01.19).
21 de Noviembre de 2018Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MICHAEL ACKERMANN. Datos registrales. T 3124 , F 158, S 8, H MU70974, I/A cad (14.11.18).
08 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: URS JOSEF STEINER. Presidente: URS JOSEF STEINER. Cons.Del.Man: URS JOSEF STEINER.Nombramientos. Consejero: NORBERT RUDOLF BACKERT. Presidente: TOBIAS ANDRIST. Datos registrales. T 3124 , F 202, S8, H MU 70974, I/A 42 ( 1.08.18).
15 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: YVES GREBENAROV. Datos registrales. T 3124 , F 200, S 8, H MU 70974, I/A 40 ( 8.01.18).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NATASCHA JUTTA NEIDINGER. Nombramientos. SecreNoConsj: JILLIAN FELICIA HJORDISKANEL. Datos registrales. T 3124 , F 200, S 8, H MU 70974, I/A 41 ( 8.01.18).
14 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 3124 , F 200, S 8, H MU 70974, I/A 39 ( 5.12.17).
17 de Noviembre de 2017Fe de erratas: Se envio por error el cese de Don Michel Ackerman, Tobias Andrich, Max Mentins, Martin Roth y Enrich Martin Geisel.Datos registrales. T 3124 , F 199, S 8, H MU 70974, I/A 37 ( 8.09.17).
27 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: EMILIA RITTER. Apoderado: ISABELANNECHARLOTTE PEREZ LJUNGGREN. Nombramientos.Apo.Manc.: VIOLA CARMEN FRITZ;MICHAEL WENGER. Datos registrales. T 3124 , F 199, S 8, H MU 70974, I/A 38 (20.09.17).
15 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MICHAEL ACKERMANN;TOBIAS ANDRIST;MAX MERTINS;MARTIN ROTH. Cons.Del.Man: TOBIASANDRIST. Consejero: ERICH MARTIN GEISER-WALTER. SecreNoConsj: NATASCHA JUTTA NEIDINGER. Nombramientos.Consejero: URS JOSEF STEINER. Presidente: URS JOSEF STEINER. Consejero: ALAIN SERGE JOURDAN. Vicepresid.: ALAINSERGE JOURDAN. Consejero: HANSPETER FUCHS;MARTIN SELIG;BEAT ANDRIST;CLAUDE MINDER;CHARLES MAURON.Cons.Del.Man: URS JOSEF STEINER;ALAIN SERGE JOURDAN;BEAT ANDRIST. SecreNoConsj: NATASCHA JUTTA NEIDINGER.Datos registrales. T 3124 , F 199, S 8, H MU 70974, I/A 37 ( 8.09.17).
07 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: TAMARA BARTSCHI-PELLET;ESTHER ELIZABETH SCHINDELHOLZ. Datos registrales. T 3124 , F199, S 8, H MU 70974, I/A 36 (31.05.17).
19 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: WALTER XAVER INEICHEN. Apo.Man.Soli: WALTER INEICHEN. Datos registrales. T 3124 , F 198, S8, H MU 70974, I/A 35 (11.10.16).
20 de Junio de 2016Otros conceptos: MODIFICACON DEL ARTICULO 2 EN LO REFERENTE A LA ADOPCION DE ACUERDOS DEL CONSEJO Datosregistrales. T 3124 , F 198, S 8, H MU 70974, I/A 33 (13.06.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARC OLIVER HOFMANN. Nombramientos. Apoderado: ISABELANNECHARLOTTE PEREZLJUNGGREN. Otros conceptos: AMPLIACION DE FACULTADES DE LOS APODERADOS DE LA CATEGORIA A1, SUPRIMIENTOLA FACULTAD DE 5.2 DEL APARTADO "FACULTADES RELATIVAS A ASUNTOS LABORALES" RESPECTO DE LOSAPODERADOS DE LAS CATEGORIAS A1 A2 Y A3. Datos registrales. T 3124 , F 198, S 8, H MU 70974, I/A 34 (13.06.16).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Consejero: ERICH MARTIN GEISER-WALTER. Datos registrales. T 3124 , F 198, S 8, H MU 70974, I/A 32(18.12.15).
15 de Diciembre de 2015Otros conceptos: Modifican los articulos 16 y 23 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3124 , F 197, S 8, H MU 70974, I/A31 ( 4.12.15).
11 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDRE MORO. Nombramientos. Consejero: FABIAN BARLOCHER. Datos registrales. T 3124 , F197, S 8, H MU 70974, I/A 30 ( 3.12.15).
25 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: REINHOLD TSCHOPP. Revocaciones. Apo.Manc.: TOBIAS ANDRIST. Apo.Sol.: URS JOSEFSTEINER;BEAT ANDRIST;YOLANDA LOPEZ CASERO. Apo.Man.Soli: JUAN RICARDO ROTHE. Apoderado: JUAN RICARDOROTHE. Apo.Manc.: SIMON JENZER;CLAUDIA VOEGELIN;ISAAC HERNANDEZ VALLES;JUAN RICARDO ROTHE;MARC OLIVERHOFMANN;ESTHER ELIZABETH SCHINDELHOLZ;EMILIA RITTER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: WALTER INEICHEN;SIMONJENZER;ISAAC HERNANDEZ VALLES;JUAN RICARDO ROTHE;JUAN ANTONIO BASILDO GARCIA;NOELIA RAJA PEREZ.Apo.Sol.: MARC OLIVER HOFMANN. Apo.Manc.: EMILIA RITTER;TAMARA BARTSCHI-PELLET;ESTHER ELIZABETHSCHINDELHOLZ. Datos registrales. T 3124 , F 194, S 8, H MU 70974, I/A 29 (18.11.15).
28 de Octubre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 181.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 231.500,00 Euros. Datos registrales. T 3030 , F 160, S 8, HMU 70974, I/A 28 (21.10.15).
02 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: WALTER INEICHEN;BRUNO HURLIMANN;ANDREAS WITTKE. Cons.Del.Man: ANDREAS WITTKE.Nombramientos. Consejero: TOBIAS ANDRIST;MAX MERTINS;MARTIN ROTH. Datos registrales. T 3030 , F 159, S 8, H MU70974, I/A 26 (25.09.15).
Nombramientos. Cons.Del.Man: TOBIAS ANDRIST. Apo.Manc.: WALTER XAVER INEICHEN;URS JOSEF STEINER;TOBIASANDRIST;ALAIN SERGE JOURDAN;JUAN RICARDO ROTHE. Datos registrales. T 3030 , F 159, S 8, H MU 70974, I/A 27(25.09.15).
10 de Julio de 2015Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 3030 , F 158, S 8, H MU 70974, I/A 25 ( 3.07.15).
18 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: MARC OLIVER HOFMANN;ESTHER ELIZABETH SCHINDELHOLZ;EMILIA RITTER. Datosregistrales. T 3030 , F 158, S 8, H MU 70974, I/A 24 (11.02.15).
18 de Julio de 2014Nombramientos. Consejero: MICHAEL ACKERMANN. Datos registrales. T 3030 , F 158, S 8, H MU 70974, I/A 23 (11.07.14).
22 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BERNHARD BRODBECK. Revocaciones. Apo.Manc.: ARLIETTE MIRELLE METILLEBERTSCHINGER. Datos registrales. T 3030 , F 158, S 8, H MU 70974, I/A 22 (14.05.14).
22 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: JUAN RICARDO ROTHE. Datos registrales. T 2850 , F 128, S 8, H MU 70974, I/A 20 (15.11.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: ISAAC HERNANDEZ VALLES. Datos registrales. T 2850 , F 130, S 8, H MU 70974, I/A 21 (15.11.13).
17 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: JOSEF GEROLD FRICKER. Consejero: URS JOSEF STEINER. Presidente: URS JOSEF STEINER.Consejero: BEAT ANDRIST;REINHOLD TSCHOPP;HANS-GERD FISCHER;MARTIN SELIG. Cons.Del.Man: URS JOSEFSTEINER;BEAT ANDRIST;HANS-GERD FISCHER. Consejero: BERNHARD BRODBECK;ALAIN SERGE JOURDAN. Cons.Del.Man:ALAIN SERGE JOURDAN. Consejero: BRUNO HURLIMANN;HANSPETER FUCHS;ANDRE MORO;RENATO WALTHER BUCHER.Vicepresid.: ALAIN SERGE JOURDAN. Consejero: CLAUDE MINDER. Revocaciones. Apo.Manc.: RENATO WALTER BUCHER.Nombramientos. SecreNoConsj: NATASCHA JUTTA NEIDINGER. Consejero: URS JOSEF STEINER. Presidente: URS JOSEFSTEINER. Consejero: ALAIN SERGE JOURDAN. Vicepresid.: ALAIN SERGE JOURDAN. Cons.Del.Man: URS JOSEFSTEINER;ALAIN SERGE JOURDAN. Consejero: BEAT ANDRIST. Cons.Del.Man: BEAT ANDRIST. Consejero: ANDREAS WITTKE.Cons.Del.Man: ANDREAS WITTKE. Consejero: WALTER INEICHEN;REINHOLD TSCHOPP;MARTIN SELIG;BERNHARDBRODBECK;BRUNO HURLIMANN;HANSPETER FUCHS;ANDRE MORO. Datos registrales. T 2850 , F 127, S 8, H MU 70974, I/A19 (11.09.13).
20 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: SIMON JENZER;CLAUDIA VOEGELIN. Datos registrales. T 2850 , F 127, S 8, H MU 70974, I/A 18(13.12.12).
20 de Junio de 2012Nombramientos. Vicepresid.: ALAIN SERGE JOURDAN. Datos registrales. T 2758 , F 20, S 8, H MU 70974, I/A 17 (12.06.12).
30 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: JUAN RICARDO ROTHE. Datos registrales. T 2758 , F 20, S 8, H MU 70974, I/A 16 (21.12.11).
06 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MARKUS KUNG. Nombramientos. Consejero: BRUNO HURLIMANN;HANSPETER FUCHS;ANDREMORO;RENATO WALTHER BUCHER. Otros conceptos: modificacion de los articulos 16 y 23 y refundici贸n de la totalidad de losestatutos sociales. Datos registrales. T 2758 , F 20, S 8, H MU 70974, I/A 15 (28.09.11).
04 de Abril de 2011Otros conceptos: Inclusi贸n de un nuevo art铆culo 8 bis de los estatutos. Datos registrales. T 2758 , F 20, S 8, H MU 70974, I/A 14(25.03.11).
20 de Enero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 46.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.000,00 Euros. Datos registrales. T 2758 , F 19, S 8, H MU70974, I/A 13 (11.01.11).
18 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: PETER SCHAFROTH. Consejero: PETER SCHAFROTH. Nombramientos. Consejero: ALAINSERGE JOURDAN. Cons.Del.Man: ALAIN SERGE JOURDAN. Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 16 de los estatutossociales. Cambio de domicilio social. CTRA RM-714, Km 34,8 NORTE - PUERTO ERRADO S/N. A (CALASPARRA). Datosregistrales. T 2758 , F 19, S 8, H MU 70974, I/A 12 ( 6.10.10).
02 de Julio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUAN RICARDO ROTHE. Datos registrales. T 2680 , F 51, S 8, H MU 70974, I/A 11 (24.06.10).
18 de Mayo de 2010Nombramientos. Consejero: BERNHARD BRODBECK;MARKUS KUNG. Otros conceptos: Modificacion del articulo 23 de losestatutos sociales. Datos registrales. T 2680 , F 50, S 8, H MU 70974, I/A 10 ( 7.05.10).
24 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE ENRICH MURT;MARIA DOLORES SANCHA HERRERA;YOLANDA LOPEZ CASERO. Datosregistrales. T 2680 , F 50, S 8, H MU 70974, I/A 9 (12.03.10).
19 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 2680 , F 49, S 8, H MU 70974, I/A 6 (11.02.10).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 2680 , F 49, S 8, H MU 70974, I/A 7 (11.02.10).
09 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN SELIG;IGNACIO AYCART LOPEZ;GERHARD HAUTMANN. Presidente: MARTIN SELIG.Cons.Del.Sol: MARTIN SELIG;GERHARD HAUTMANN. Con.Delegado: IGNACIO AYCART LOPEZ. SecreNoConsj: PAUL THOMASO'DONNELL. Revocaciones. Apo.Sol.: PABLO GERMAN CUBEL SANCHEZ;JUAN JOSE RUIZ VILLAFRANCA. Nombramientos.Secretario: JOSEF GEROLD FRICKER. Consejero: URS JOSEF STEINER. Presidente: URS JOSEF STEINER. Consejero: BEATANDRIST;PETER SCHAFROTH;REINHOLD TSCHOPP;HANS-GERD FISCHER;MARTIN SELIG. Cons.Del.Man: URS JOSEFSTEINER;BEAT ANDRIST;PETER SCHAFROTH;HANS-GERD FISCHER. Apo.Manc.: TOBIAS ANDRIST;ARLIETTE MIRELLEMETILLE BERTSCHINGER;RENATO WALTER BUCHER. Apo.Sol.: URS JOSEF STEINER;BEAT ANDRIST. Otros conceptos:Modificaci贸n de la totalidad de los Estatutos sociales. Cambio de objeto social. La sociedad tiene como 煤nico objeto social eldesarrollo, construcci贸n, propiedad y explotaci贸n de la central termosolar PE2, sita en Calasparra (Espa帽a) y basada en la tecnolog铆aNovatec Nova 1 Linear Fresnel, as铆 como la realizaci贸n de todas aquellas actividades empresariales vinculadas con el cit. Datosregistrales. T 2680 , F 45, S 8, H MU 70974, I/A 5 (29.01.10).
22 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 994,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.000,00 Euros. Datos registrales. T 2680 , F 44, S 8, H MU70974, I/A 4 (11.06.09).
19 de Mayo de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.10.08. Objeto social: a) La direcci贸n, gesti贸n, administraci贸n y control de sociedadesparticipadas, excetu谩ndose las actividades reservadas a Instituciones de Inversi贸n Colectiva y a Sociedades y Agencia de Valores. b)El estudio, el desarrollo y la supervisi贸n de proyectos de todo tipo de energia solar. c) La gesti贸n,. Domicilio: C/ CARRIL RUIPEREZ 52(MURCIA). Capital: 3.006,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TUBO SOL MURCIA SA. Nombramientos.Consejero: MARTIN SELIG;IGNACIO AYCART LOPEZ;GERHARD HAUTMANN. Datos registrales. T 2680 , F 42, S 8, H MU 70974,I/A 1 ( 7.05.09).
Nombramientos. Presidente: MARTIN SELIG. SecreNoConsj: PAUL THOMAS O'DONNELL. Cons.Del.Sol: MARTINSELIG;GERHARD HAUTMANN. Con.Delegado: IGNACIO AYCART LOPEZ. Datos registrales. T 2680 , F 43, S 8, H MU 70974, I/A 2( 7.05.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: PABLO GERMAN CUBEL SANCHEZ;JUAN JOSE RUIZ VILLAFRANCA. Datos registrales. T 2680 , F44, S 8, H MU 70974, I/A 3 ( 7.05.09).