Actos BORME de Tubos Reunidos Sa
26 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LASALA URRUTICOECHEA KOLDO. Datos registrales. T 1739 , F 146, S 8, H VI 6719, I/A 236 (4.10.23).
Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. PresEjecutiv: IRAZUSTA RODRIGUEZFRANCISCO VALENTIN. Revocaciones. Apo.Man.Soli: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Apo.Manc.: IRAZUSTARODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCOVALENTIN;IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;IRAZUSTARODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO;IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO. Datosregistrales. T 1739 , F 147, S 8, H VI 6719, I/A 237 (16.10.23).
04 de Septiembre de 2023Reelecciones. Consj.Domini: MIGOYA PELAEZ ENRIQUE. Con.Ind.: MU脩OZ BERAZA ANA ISABEL. Datos registrales. T 1739 , F146, S 8, H VI 6719, I/A 235 (17.08.23).
24 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: PIPAON PALACIO ANTONIO. Datos registrales. T 1739 , F 146, S 8, H VI 6719, I/A 234 ( 3.04.23).
24 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIPAON PALACIO ANTONIO. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO;LOPEZ DE LASHERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;BARON LOPEZ IGNACIO. Datos registrales. T 1739 , F 144, S 8, H VI 6719, I/A 233( 8.03.23).
27 de Septiembre de 2022P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.tubosreunidosgroup.com. Datosregistrales. T 1739 , F 135, S 8, H VI 6719, I/A 229 (15.09.22).
Reelecciones. Consj.Domini: VALDES GUINEA CRISTOBAL. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG S.L.Datos registrales. T 1739 , F 136, S 8, H VI 6719, I/A 230 (15.09.22).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Objeto social.-. Otros conceptos: Se modifican los estatutos sociales dela compa帽铆a, incluido el art铆culo referente al objeto social, se introducen nuevos art铆culos estatutarios y se les da nueva redacci贸n atodos ellos.- Cambio de objeto social. a) La fabricaci贸n de tubos de hierro y acero dulces soldados y volteados por el procedimientocuyas patentes posee; b) La fabricaci贸n , transformaci贸n y venta de acero y productos derivados del mismo, fundamentalmente,tuber铆a y accesorios de todas clases, de todo g茅nero de construcciones e instalac. Datos registrales. T 1739 , F 136, S 8, H VI 6719,I/A 231 (15.09.22).
Otros conceptos: Se modifica el Reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad y se le da nueva redacci贸n almismo.- Datos registrales. T 1739 , F 141, S 8, H VI 6719, I/A 232 (15.09.22).
13 de Mayo de 2022Otros conceptos: SE MODIFICA Y APRUEBA UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DEADMINISTRACION DE DICHA COMPA脩IA.- Datos registrales. T 1739 , F 129, S 8, H VI 6719, I/A 228 ( 2.05.22).
18 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARON LOPEZ IGNACIO. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO;LOPEZ DE LASHERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;EYARA ALVAREZ IZASKUN;PIPAON PALACIO ANTONIO. Datos registrales. T 1739, F 126, S 8, H VI 6719, I/A 227 ( 4.04.22).
02 de Marzo de 2022Otros conceptos: Modificaci贸n de los t茅rminos y condiciones de la emisi贸n de los bonos garantizados convertibles en acciones de"TUBOS REUNIDOS, S.A.", a que se refiere la inscripci贸n 211陋 de esta hoja, y la ratificaci贸n de las garant铆as. Datos registrales. T1737 , F 154, S 8, H VI 6719, I/A 223 (11.02.22).
Otros conceptos: Modificaci贸n de los t茅rminos y condiciones de los bonos simples garanti-zados de "TUBOS REUNIDOS, S.A.", aque se refiere la inscripci贸n 206陋 de esta hoja, y ratificaci贸n de las garant铆as. Datos registrales. T 1739 , F 114, S 8, H VI 6719, I/A224 (11.02.22).
Otros conceptos: Modificaci贸n de los t茅rminos y condiciones de los warrants de "TUBOS REUNIDOS, S.A." a que se refiere lainscripci贸n 204陋 de esta hoja. Datos registrales. T 1739 , F 121, S 8, H VI 6719, I/A 225 (11.02.22).
Nombramientos. Con.Ind.: QUIROS ALVAREZ MARIA TERESA;SICILIA SALVADORES MARIA. Datos registrales. T 1739 , F 125,S 8, H VI 6719, I/A 226 (11.02.22).
16 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIPAON PALACIO ANTONIO. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;LOPEZDE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1689 , F 165, S 8, H VI6719, I/A 216 (31.01.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTIZ ZARATE NAGORE. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;LOPEZDE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1689 , F 166, S 8, H VI6719, I/A 217 (31.01.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LASALA URRUTICOECHEA KOLDO. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCOVALENTIN;LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO. Datos registrales. T 1689 ,F 167, S 8, H VI 6719, I/A 218 (31.01.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: EYARA ALVAREZ IZASKUN. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;LOPEZDE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO. Datos registrales. T 1737 , F 139, S 8, H VI6719, I/A 219 (31.01.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCOVALENTIN;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1737 , F142, S 8, H VI 6719, I/A 220 (31.01.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NU脩EZ DE LA PARTE INES. Apo.Manc.: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN;LOPEZDE LAS HERAS CARLOS;PIPAON PALACIO ANTONIO;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1737 , F 147, S 8, H VI6719, I/A 221 (31.01.22).
Revocaciones. Apoderado: GABIOLA MENDIETA JORGE. Apo.Manc.: PEREDA GOMEZ JOSEBA I脩AKI;ITURRIAGA ARRILLAGAJOSE MANUEL;PEREDA GOMEZ JOSEBA I脩AKI;ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL;PIPAON PALACIO ANTONIO;PASCUALORBE JUAN PABLO. Apo.Man.Soli: PIPAON PALACIO ANTONIO;ARTECHE URRUTIA JESUS FRANCISCO-JOSU- Apo.Manc.:ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO;PASCUAL ORBE JUAN PABLO.Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS. Apo.Manc.: ALONSO RODRIGUEZ SANTIAGO;NU脩EZ DE LA PARTEINES;PIPAON PALACIO ANTONIO;PASCUAL ORBE JUAN PABLO. Apo.Sol.: NU脩EZ DE LA PARTE INES. Apo.Man.Soli: EYARAALVAREZ IZASKUN. Apo.Manc.: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIOANTONIO;PASCUAL ORBE JUAN PABLO;LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIOANTONIO;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1737 , F 153, S 8, H VI 6719, I/A 222 (31.01.22).
18 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: IRAZUSTARODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Apo.Manc.: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAONPALACIO ANTON;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1689 , F 161, S 8, H VI 6719, I/A 215 (10.01.22).
15 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: ROMAN GONCALVES JUAN MARIA. Reelecciones. Cons.Ext.Dom: BARANDIARAN OLLEROSALFONSO;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA;ZORRILLA DE LEQUERICA PUIG LETICIA. Vicepresid.: YBARRA AZNAR EMILIOMARIA. Datos registrales. T 1689 , F 160, S 8, H VI 6719, I/A 214 (29.09.21).
29 de Diciembre de 2020Nombramientos. Cons.Externo: PEREZ RODRIGUEZ-URRUTIA JESUS. Reelecciones. Cons.Ejecuti: IRAZUSTA RODRIGUEZFRANCISCO VALENTIN. Con.Ind.: GABIOLA MENDIETA JORGE. Otros conceptos: Se ratifican a tres miembros del 贸rgano deadministraci贸n por cooptaci贸n de la compa帽铆a: don Francisco Irazusta Rodr铆guez, don Jorge Gabiola Mendieta y don Jes煤s P茅rezRodr铆guez-Urrutia. Datos registrales. T 1689 , F 159, S 8, H VI 6719, I/A 213 (15.12.20).
13 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Apo.Manc.: LOPEZ DE LAS HERASCARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO;EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1689 , F 158,S 8, H VI 6719, I/A 212 (28.10.20).
08 de Septiembre de 2020Otros conceptos: Modificaci贸n de los t茅rminos y condiciones de la emisi贸n de los bonos garantizados convertibles en acciones de"TUBOS REUNIDOS, S.A.", a que se refiere la inscripic贸n 205陋 de esta hoja, y la ratificaci贸n de las garant铆as. Datos registrales. T1689 , F 153, S 8, H VI 6719, I/A 211 (21.08.20).
12 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE. Con.Ind.: GABIOLA MENDIETA JORGE. Mmbr.Com.Del: GABIOLAMENDIETA JORGE. Consejero: GABIOLA MENDIETA JORGE. Presidente: GABIOLA MENDIETA JORGE. Nombramientos.Cons.Ejecuti: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Pres.Com.Del: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN.PresEjecutiv: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN. Mmbr.Com.Del: IRAZUSTA RODRIGUEZ FRANCISCO VALENTIN.Con.Ind.: GABIOLA MENDIETA JORGE. Consej.Coord: GABIOLA MENDIETA JORGE. Otros conceptos: Se hace constar que losnuevos consejeros nombrados por cooptaci贸n ocuparan los cargos vacantes, hasta que tenga lugar la primera junta general que secelebre con posterioridad a la reuni贸n del consejo de administraci贸n, siempre dentro de la vigencia de los cargos de los anteriorestitulares. Datos registrales. T 1689 , F 152, S 8, H VI 6719, I/A 210 ( 2.06.20).
19 de Mayo de 2020Otros conceptos: Se cancela la inscripci贸n 165陋 de la emisi贸n de 155 bonos simples de 100000 euros de valor nominal unitario, porun importe total de 15.500.000 euros, realizada en virtud de escritura autorizada por el notario de Bilbao, Don Jos茅 Antonio IsusiEzcurdia, el 14-12-2015, n潞 5127 de protocolo, en uni贸n de acta autorizada por el mismo notario, el 23-12-2015, n潞. Datos registrales.T 1689 , F 151, S 8, H VI 6719, I/A 209 ( 5.05.20).
27 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: QMC DIRECTORSHISPS S.L. Mmbr.Com.Del: QMC DIRECTORSHISPS S.L. Nombramientos.Consejero: PEREZ RODRIGUEZ-URRUTIA JESUS. Datos registrales. T 1689 , F 149, S 8, H VI 6719, I/A 207 (20.04.20).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO RODRIGUEZ SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: EYARA ALVAREZ IZASKUN.Apo.Manc.: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO;PASCUAL ORBE JUANPABLO. Datos registrales. T 1689 , F 150, S 8, H VI 6719, I/A 208 (20.04.20).
31 de Diciembre de 2019Emisi贸n de obligaciones. Comisario: - Importe de la emisi贸n: 161.428.363,10 Euros. 18.12.19. Otros conceptos: Emisi贸n dewarrants. T茅rminos y condiciones en que se realiza la emisi贸n. La total suscripci贸n de los mismos.- Conforme lo previsto en el art铆culo311 del R.R.M., se declara el cierre de la emisi贸n de warrants, habiendo sido integramente suscritos los warrants. Datos registrales.T 1681 , F 40, S 8, H VI 6719, I/A 204 (20.12.19).
Nombramientos. Comisario: SANNE AGENSYND SL. Emisi贸n de obligaciones. Comisario: SANNE AGENSYND SL. Importe de laemisi贸n: 10.633.217,00 Euros. 18.12.19. Otros conceptos: Emisi贸n de obligaciones convertibles en acciones, los t茅rminos ycondiciones, la total suscripci贸n y desembolso de las mismas, constituci贸n del sindicato. El Reglamento del sindicato de bonistas.Conforme lo previsto en el art铆culo 311 del R.R.M., se declara el cierre de la emisi贸n de bonos, habiendo sido integramente suscritos ydesembolsados los bonos convertibles. Datos registrales. T 1689 , F 114, S 8, H VI 6719, I/A 205 (20.12.19).
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: SANNE AGENSYND SL. Importe de la emisi贸n: 5.634.002,00 Euros. 18.12.19. Otrosconceptos: Emisi贸n de obligaciones SIMPLES, los t茅rminos y condiciones, la total suscripci贸n y desembolso de las mismas,constituci贸n del sindicato. Y Reglamento del sindicato de bonistas. Conforme lo previsto en el art铆culo 311 del R.R.M. se declara elcierre de la emisi贸n de los bonos, habiendo sido integramente suscritos y desembolsados los bonos. Datos registrales. T 1689 , F138, S 8, H VI 6719, I/A 206 (20.12.19).
21 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;ALONSO RODRIGUEZ SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Manc.:LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTE INES. Apo.Sol.: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;NU脩EZ DE LA PARTEINES;PIPAON PALACIO ANTON. Datos registrales. T 1681 , F 39, S 8, H VI 6719, I/A 203 ( 4.11.19).
07 de Noviembre de 2019Otros conceptos: Se excluyen a negociaci贸n en Bolsa de Valores de Madrid, 174.680.888 acciones de 0,1 euros cada una y seadmiten 174.680.888 acciones de 0,02 euros, representadas en anotaciones en cuenta, con efectos desde el 12 de agosto de 2019.-Datos registrales. T 1681 , F 39, S 8, H VI 6719, I/A 202 (28.10.19).
03 de Octubre de 2019Otros conceptos: Se excluyen de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao 174.680.888 acciones de 0,10 euros de valornominal, cada una de ellas, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta, con efectos desde el 12 de agostode 2019.- Se admiten en la citada bolsa 174.680.888 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmentedesembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta, con efectos desde 12 de agosto de 2019.- Datos registrales. T 1681 , F39, S 8, H VI 6719, I/A 201 (18.09.19).
22 de Agosto de 2019Nombramientos. Consj.Domini: MIGOYA PELAEZ ENRIQUE. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG S.L.Reelecciones. Con.Ind.: MU脩OZ BERAZA ANA ISABEL. Datos registrales. T 1618 , F 92, S 8, H VI 6719, I/A 199 ( 2.08.19).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 13.974.471,04 Euros. Resultante Suscrito: 3.493.617,76 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 1618 , F 92, S 8, H VI 6719, I/A 200 ( 2.08.19).
22 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: GONDRA RODRIGO VICTORIA. Datos registrales. T 1618 , F 90, S 8, H VI 6719, I/A 197 ( 7.11.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: NU脩EZ DE LA PARTE INES. Datos registrales. T 1618 , F 90, S 8, H VI 6719, I/A 198 ( 7.11.18).
15 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. PresEjecutiv: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Mmbr.Com.Del:ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Secretario: GABIOLA MENDIETA JORGE. Consej.Coord: GABIOLA MENDIETA JORGE.Revocaciones. Apo.Man.Soli: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Apo.Manc.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO;ULACIA ARNAIZGUILLERMO;ULACIA ARNAIZ GUILLERMO;ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Nombramientos. Presidente: GABIOLA MENDIETAJORGE. SecreNoConsj: NU脩EZ DE LA PARTE INES. Sec.Com.Del: NU脩EZ DE LA PARTE INES. Datos registrales. T 1618 , F 88,S 8, H VI 6719, I/A 194 ( 7.11.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS;ALONSO RODRIGUEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 1618 , F88, S 8, H VI 6719, I/A 195 ( 7.11.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS. Apo.Manc.: ALONSO RODRIGUEZ SANTIAGO;NU脩EZ DE LAPARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO;PASCUAL ORBE JUAN PABLO. Datos registrales. T 1618 , F 89, S 8, H VI 6719, I/A196 ( 7.11.18).
24 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO RODRIGUEZSANTIAGO. Apo.Manc.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO;NU脩EZ DE LA PARTE INES;PIPAON PALACIO ANTONIO;PASCUAL ORBEJUAN PABLO. Datos registrales. T 1618 , F 87, S 8, H VI 6719, I/A 193 ( 9.10.18).
24 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Ext.Dom: ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE. Mmbr.Com.Del: ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE.Nombramientos. Consj.Domini: MIGOYA PELAEZ ENRIQUE. MiCoAudi: MIGOYA PELAEZ ENRIQUE. Otros conceptos: Se haceconstar que el nuevo consejero nombrado por cooptaci贸n miembro del consejo de administraci贸n y miembro de la comisi贸n deAuditoria, ocupar谩 el cargo vacante hasta que tenga lugar la primera junta general que se celebre con posterioridad a la reuni贸n delconsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1618 , F 85, S 8, H VI 6719, I/A 190 (10.08.18).
Nombramientos. Mmbr.Com.Del: MIGOYA PELAEZ ENRIQUE. Otros conceptos: Se hace constar que Don Enrique Migoyaocupar谩 su cargo como miembro de la comisi贸n delegada hasta que tenga lugar la primera junta general que se celebre conposterioridad a la reuni贸n del consejo de administraci贸n donde se le ha nombrado consejero por cooptaci贸n. Datos registrales. T1618 , F 86, S 8, H VI 6719, I/A 191 (10.08.18).
Nombramientos. Consj.Domini: VALDES GUINEA CRISTOBAL. Reelecciones. Consejero: QMC DIRECTORSHISPS S.L. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datosregistrales. T 1618 , F 86, S 8, H VI 6719, I/A 192 (10.08.18).
31 de Mayo de 2018Nombramientos. Mmbr.Com.Del: VALDES GUINEA CRISTOBAL;GABIOLA MENDIETA JORGE. Datos registrales. T 1618 , F 85,S 8, H VI 6719, I/A 189 (16.05.18).
14 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE. Mmbr.Com.Del: PORTOCARREROZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE. Nombramientos. Cons.Ext.Dom: VALDES GUINEA CRISTOBAL. VsecrNoConsj: NU脩EZ DELA PARTE INES. ViceSec.C.Dl: NU脩EZ DE LA PARTE INES. Otros conceptos: Se hace constar que el nuevo consejero dominicalnombrado POR COOPTACION ocupar谩 el cargo de vacante hasta que tenga lugar la primera Junta General que se celebre conposterioridad a la reuni贸n del Consejo de Administraci贸n.- Datos registrales. T 1618 , F 84, S 8, H VI 6719, I/A 188 (30.04.18).
05 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Externo: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Presidente: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Vicepresid.: ULACIAARNAIZ GUILLERMO. Nombramientos. PresEjecutiv: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Consej.Coord: GABIOLA MENDIETA JORGE.Datos registrales. T 1618 , F 84, S 8, H VI 6719, I/A 187 ( 7.02.18).
12 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES S.L. Datos registrales. T 1618 , F 84, S 8, H VI 6719, I/A 186 (20.11.17).
22 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: GABIOLA MENDIETA JORGE. Consejero: ZORRILLA DE LEQUERICA PUIG LETICIA;ESTEVEROMERO FRANCISCO JOSE;ABASOLO ALBONIGA PEDRO;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Presidente: ABASOLO ALBONIGAPEDRO. Vicepresid.: YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Consejero: GABIOLA MENDIETA JORGE. Secretario: GABIOLA MENDIETAJORGE. Consejero: BARANDIARAN OLLEROS ALFONSO. Vicepresid.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Consejero: ULACIA ARNAIZGUILLERMO. Pres.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ESTEVE ROMEROFRANCISCO JOSE;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE. Cancelaciones de oficio denombramientos. Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA ALBERTO;VELASCO BARROETABE脩A ROBERTO. Nombramientos.Con.Ind.: ROMAN GONCALVES JUAN MARIA. Cons.Externo: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Cons.Ext.Dom: BARANDIARANOLLEROS ALFONSO;ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE. Con.Ind.: GABIOLA MENDIETA JORGE. Cons.Ejecuti: ULACIAARNAIZ GUILLERMO. Cons.Ext.Dom: YBARRA AZNAR EMILIO MARIA;ZORRILLA DE LEQUERICA PUIG LETICIA. Presidente:ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Vicepresid.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Secretario: GABIOLAMENDIETA JORGE. Otros conceptos: Se ratifica el nombramiento de Guillermo Ulacia Arnaiz, como consejero ejecutivo de laCompa帽铆a.- Se modifica el art. 26潞 de los estatutos sociales relativo a la retribuci贸n de los administradores.- Datos registrales. T 1618, F 81, S 8, H VI 6719, I/A 184 (30.08.17).
Nombramientos. Pres.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ULACIA ARNAIZGUILLERMO;ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE.Datos registrales. T 1618 , F 83, S 8, H VI 6719, I/A 185 (30.08.17).
28 de Abril de 2017Nombramientos. Consejero: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Vicepresid.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Otros conceptos: Sehace constar que el nuevo consejero nombrado por cooptaci贸n ocupar谩 el cargo vacante hasta que tenga lugar la primera juntageneral que se celebre con posterioridad a la reuni贸n del consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1618 , F 78, S 8, H VI 6719,I/A 178 ( 7.04.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Apo.Manc.: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL;PIPAONPALACIO ANTONIO;PASCUAL ORBE JUAN PABLO. Datos registrales. T 1618 , F 78, S 8, H VI 6719, I/A 179 ( 7.04.17).
Revocaciones. Apoderado: ENDERIKA DE LA SIERRA I脩IGO;ENDERIKA DE LA SIERRA I脩IGO. Apo.Man.Soli: PEREDA GOMEZJOSEBA I脩AKI;ARTECHE URRUTIA JESUS FRANCISCO-JOSU- Apoderado: PIPAON PALACIO ANTONIO. Apo.Man.Soli:ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1618 , F 79, S 8, H VI 6719, I/A 180 ( 7.04.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Apo.Manc.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Datosregistrales. T 1618 , F 80, S 8, H VI 6719, I/A 181 ( 7.04.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIPAON PALACIO ANTONIO. Apo.Manc.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Datos registrales. T1618 , F 80, S 8, H VI 6719, I/A 182 ( 7.04.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: ULACIA ARNAIZ GUILLERMO. Apo.Man.Soli: ARTECHE URRUTIA JESUS FRANCISCO-JOSU-Apo.Manc.: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1618 , F 81, S 8, H VI 6719, I/A 183 ( 7.04.17).
30 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE. Apo.Manc.: ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE;ARRIOLA ALCIBARENRIQUE;ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE. Datos registrales. T 1618 , F 78, S 8, H VI 6719, I/A 177 (23.03.17).
22 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO. Con.Ind.: JORDA CASTRO MARIA LUISA. Mmbr.Com.Del: MA脩ASANTON LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1618 , F 77, S 8, H VI 6719, I/A 176 (14.11.16).
26 de Octubre de 2016Otros conceptos: Se modifican los art铆culos 3潞, 13潞, 16潞, 17潞, 19潞, 20潞, 21潞, 22潞, 23潞, 24潞 y 25潞 Estatutarios, para su adecuaci贸n a las煤ltimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo, aprob谩ndose un nuevo texto refundido de losEstatutos Sociales de la compa帽铆a. Datos registrales. T 1604 , F 59, S 8, H VI 6719, I/A 173 (29.09.16).
Otros conceptos: Modificaci贸n y aprobaci贸n de un nuevo Texto Refundido del Reglamento de la Junta General de dicha compa帽铆apara su adecuaci贸n a las 煤ltimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T 1604 , F 61, S 8, H VI 6719, I/A174 (29.09.16).
Otros conceptos: Se modifica y aprueba un nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administraci贸n de dichaCompa帽铆a. Datos registrales. T 1604 , F 64, S 8, H VI 6719, I/A 175 (29.09.16).
16 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1604 , F 59, S 8, H VI 6719, I/A 172 (19.08.16).
20 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: ARRIOLA ALCIBARENRIQUE;PEREDA GOMEZ JOSEBA I脩AKI. Apo.Man.Soli: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1604 , F58, S 8, H VI 6719, I/A 171 (11.07.16).
13 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: GABIOLA MENDIETA JORGE;POMPOSO GAZTELU LUIS MARIA. Datos registrales. T 1604 , F 58, S8, H VI 6719, I/A 170 ( 4.05.16).
27 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Apo.Manc.: ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE;PEREDAGOMEZ JOSEBA I脩AKI. Datos registrales. T 1604 , F 56, S 8, H VI 6719, I/A 166 (18.04.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREDA GOMEZ JOSEBA I脩AKI;ARTECHE URRUTIA JESUS FRANCISCO-JOSU- Apo.Manc.:ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE;ITURRIAGA ARRILLAGA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1604 , F 56, S 8, H VI 6719, I/A 167(18.04.16).
Nombramientos. Apoderado: PASCUAL ORBE JUAN PABLO. Datos registrales. T 1604 , F 57, S 8, H VI 6719, I/A 168 (18.04.16).
Nombramientos. Apoderado: PIPAON PALACIO ANTONIO. Datos registrales. T 1604 , F 58, S 8, H VI 6719, I/A 169 (18.04.16).
23 de Marzo de 2016Emisi贸n de obligaciones. Comisario: - Importe de la emisi贸n: 1.550.000.000 Ptas. 14.12.15. Datos registrales. T 1542 , F 174, S 8,H VI 6719, I/A 165 ( 7.03.16).
Otros conceptos: Se declara el cierre de la emisi贸n con suscripcion integra de las 155 obligaciones, quedando suscritas ydesembolsadas por importe de 15.500.000 euros.- Datos registrales. T 1542 , F 174, S 8, H VI 6719, I/A 165 1 ( 7.03.16).
27 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: GONDRA RODRIGO VICTORIA. Datos registrales. T 1542 , F 173, S 8, H VI 6719, I/A 164 ( 7.08.15).
23 de Julio de 2015Nombramientos. Con.Ind.: JORDA CASTRO MARIA LUISA;MU脩OZ BERAZA ANA ISABEL. Datos registrales. T 1542 , F 173, S 8,H VI 6719, I/A 163 ( 9.07.15).
03 de Julio de 2015Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1542 , F 173, S 8, H VI 6719, I/A 162 (19.06.15).
15 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Pres.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ESTEVEROMERO FRANCISCO JOSE;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO;PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;YBARRAAZNAR EMILIO MARIA;GABIOLA MENDIETA JORGE. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE. Nombramientos.Pres.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ESTEVE ROMERO FRANCISCOJOSE;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO;PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;YBARRA AZNAR EMILIOMARIA;QMC DIRECTORSHISPS S.L. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE. Datos registrales. T 1542 , F 172, S 8, H VI6719, I/A 161 ( 7.10.14).
02 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO.Nombramientos. Consejero: QMC DIRECTORSHISPS S.L.;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO;PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE. Otros conceptos: El consejero nombrado " QMC DIRECTORSHIPS, SL" designa como su representantepersona fisica en dicho cargo a Don Jacobo Llanza Figueroa.- Se ratifica el nombramiento por cooptacion del consejero dominical DonAlfonso Barandiaran Olleros.- Datos registrales. T 1542 , F 170, S 8, H VI 6719, I/A 160 (13.08.14).
04 de Julio de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1542 , F 170, S 8, H VI 6719, I/A 159 (19.06.14).
07 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DE OLEA MENDARO JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: BARANDIARAN OLLEROSALFONSO. Datos registrales. T 1542 , F 170, S 8, H VI 6719, I/A 158 (22.10.13).
09 de Octubre de 2013Revocaciones. Apoderado: NOGUERA ERQUIAGA LUIS FERNANDO;ACHALANDABASO BARANDICA FRANCISCOJAVIER;GANZABAL LANDALUCE JUAN CRUZ;EYARA ALVAREZ IZASKUN;ARTECHE URRUTIA JESUS FRANCISCO-JOSU-Datos registrales. T 1511 , F 145, S 8, H VI 6719, I/A 157 (30.09.13).
12 de Agosto de 2013Nombramientos. Secretario: GABIOLA MENDIETA JORGE. Otros conceptos: Cesa en el cargo de Secretario no consejero delConsejo de Administraci贸n de la Compa帽铆a, Don Jorge Gabiola Mendieta.- Datos registrales. T 1511 , F 144, S 8, H VI 6719, I/A 155(24.07.13).
Ceses/Dimisiones. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE;YBARRA AZNAREMILIO MARIA. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE. Mmbr.Com.Del: NOGUERA DE ERQUIAGA LUISFERNANDO;PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO. Nombramientos.Pres.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ESTEVE ROMERO FRANCISCOJOSE;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO;PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;YBARRA AZNAR EMILIOMARIA;GABIOLA MENDIETA JORGE. Sec.Com.Del: GABIOLA MENDIETA JORGE. Datos registrales. T 1511 , F 145, S 8, H VI6719, I/A 156 (24.07.13).
26 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: IRIBECAMPOS ZUBIA JUAN JOSE;NOGUERA DE ERQUIAGA LUIS FERNANDO. Nombramientos.Consejero: GABIOLA MENDIETA JORGE. Reelecciones. Consejero: ZORRILLA DE LEQUERICA PUIG LETICIA;DELCLAUX DE LASOTA ALBERTO;ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE;VELASCO BARROETABE脩A ROBERTO;GOMEZ DE OLEA MENDAROJOAQUIN;ABASOLO ALBONIGA PEDRO;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Presidente: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Vicepresid.:YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Datos registrales. T 1511 , F 142, S 8, H VI 6719, I/A 154 (16.07.13).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1511 , F 142, S 8, H VI 6719, I/A 153 (12.07.13).
02 de Julio de 2013Otros conceptos: Se designa a ANTONIO PIPAON PALACIO persona f铆sica representante de TUBOS REUNIDOS S.A., en elejercicio del cargo de administrador 煤nico de TUBOS REUNIDOS COMERCIAL, S.A. Datos registrales. T 1511 , F 141, S 8, H VI6719, I/A 152 (19.06.13).
22 de Mayo de 2013Otros conceptos: Se cesa a Don Lu铆s Fernando Noguera de Erquiaga y se nombraa Don Enrique Arriola Alcibar, como persona f铆sicarepresentante de "TUBOS REUNIDOS, S.A.", Administradora Unica de la sociedad "TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.". Datosregistrales. T 1511 , F 141, S 8, H VI 6719, I/A 151 (29.04.13).
24 de Julio de 2012Otros conceptos: Queda modificado y aprobado un nuevo Texto Refundido del Reglamento de la Junta General de la Compa帽铆a.-Datos registrales. T 1511 , F 135, S 8, H VI 6719, I/A 150 ( 9.07.12).
26 de Junio de 2012Otros conceptos: Alta sede electr贸nica: www.tubosreunidos.comSe modifican y redactan de nuevo los Estatutos sociales para suadaptaci贸n al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.- Datos registrales. T 1435 , F 20, S 8, H VI 6719, I/A 147(12.06.12).
Otros conceptos: Se modifica y redacta de nuevo el Reglamento del Consejo deAdministraci贸n de la Compa帽铆a.- Datos registrales.T 1435 , F 22, S 8, H VI 6719, I/A 148 (12.06.12).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1511 , F 135, S 8, H VI 6719, I/A 149 (12.06.12).
17 de Febrero de 2012Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 15潞 Estatutario.- Datos registrales. T 1435 , F 19, S 8, H VI 6719, I/A 146 ( 2.02.12).
27 de Julio de 2011Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1435 , F 19, S 8, H VI 6719, I/A 145 ( 2.07.11).
03 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: ESCUDERO BAHILLO OSCAR MANUEL. Datos registrales. T 1435 , F 19, S 8, H VI 6719, I/A 144(26.01.11).
28 de Enero de 2011Nombramientos. Mmbr.Com.Del: PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO. Datosregistrales. T 1435 , F 18, S 8, H VI 6719, I/A 143 ( 3.01.11).
12 de Julio de 2010Nombramientos. Consejero: MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO;PORTOCARRERO ZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE. Datosregistrales. T 1435 , F 17, S 8, H VI 6719, I/A 141 (14.06.10).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1435 , F 18, S 8, H VI 6719, I/A 142(14.06.10).
21 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: URIBARREN AXPE LUIS MARIA. Mmbr.Com.Del: URIBARREN AXPE LUIS MARIA.Nombramientos. Consejero: MA脩AS ANTON LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1435 , F 16, S 8, H VI 6719, I/A 140 ( 8.04.10).
16 de Diciembre de 2009Otros conceptos: Se aprueba el Reglamento del Consejo de Administraci贸n de la compa帽铆a. Datos registrales. T 1435 , F 132, S 8,H VI 6719, I/A 139 (26.11.09).
20 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: DENIZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;MENDIBIL SOBRON RAFAEL;VI脩UELA GALLEGO JOSEANTONIO;ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE;SANTANDER GOMEZ MARIANO. Datos registrales. T 1435 , F 10, S 8, H VI 6719, I/A 135( 4.11.09).
Nombramientos. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ENRIQUE. Datos registrales. T 1435 , F 10, S 8, H VI 6719, I/A 136 ( 4.11.09).
Nombramientos. Apoderado: EYARA ALVAREZ IZASKUN. Datos registrales. T 1435 , F 12, S 8, H VI 6719, I/A 137 ( 4.11.09).
Nombramientos. Apoderado: ARTECHE URRUTIA JESUS FRANCISCO-JOSU- Datos registrales. T 1435 , F 12, S 8, H VI 6719,I/A 138 ( 4.11.09).
01 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: DENIZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: DENIZ HERNANDEZ FRANCISCOJAVIER. Nombramientos. Consejero: VELASCO BARROETABE脩A ROBERTO;NOGUERA DE ERQUIAGA LUIS FERNANDO.Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE OLEA MENDARO JOAQUIN;ABASOLO ALBONIGA PEDRO;YBARRA AZNAR EMILIOMARIA. Presidente: ABASOLO ALBONIGA PEDRO. Vicepresid.: YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Otros conceptos: Se modifica elart铆culo 32潞 estatutario y se redactan de nuevo todos los estatutos sociales.- Datos registrales. T 1376 , F 80, S 8, H VI 6719, I/A 133(22.08.09).
Nombramientos. Mmbr.Com.Del: ABASOLO ALBONIGA PEDRO;ESTEVE ROMERO FRANCISCO JOSE;PORTOCARREROZORRILLA-LEQUERICA ENRIQUE;URIBARREN AXPE LUIS MARIA;YBARRA AZNAR EMILIO MARIA. Sec.Com.Del: GABIOLAMENDIETA JORGE. Mmbr.Com.Del: NOGUERA DE ERQUIAGA LUIS FERNANDO. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n Delegada. Otros conceptos: Se designa Presidente de laComisi贸n Delegada de la Compa帽铆a a Don Pedro Abasolo Alb贸niga.- Datos registrales. T 1435 , F 10, S 8, H VI 6719, I/A 134(22.08.09).
31 de Julio de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1376 , F 79, S 8, H VI 6719, I/A 132(18.07.09).
30 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: URIBARREN IRIBECAMPOS MAITE;IRIBECAMPOS ESCUDERO EUKENE ELIXABETE. Vicepresid.:URIBARREN AXPE LUIS MARIA. Nombramientos. Consejero: BASURCO ABOITIZ PELLO. Datos registrales. T 1376 , F 79, S 8,H VI 6719, I/A 131 (27.02.09).
02 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: GABIOLA MENDIETA JORGE;ENDERIKA DE LA SIERRA I脩IGO. Datos registrales. T 1376 , F 78, S8, H VI 6719, I/A 130 (19.12.08).